GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01196721 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?
- Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
Dove si trova GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PERSONAL COMPUTERS LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
| JEREMY OATES (PROPERTY) LIMITED | 16 gen 1975 | 16 gen 1975 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 2 pagine | AD03 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 2 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 2 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT a 1 More London Place London SE1 2AF in data 22 lug 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Stewart Girling il 01 mag 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 06 feb 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 15 gen 2019
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Notifica di Ge Ese Uk Limited come persona con controllo significativo il 06 giu 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 04 gen 2018 | 2 pagine | PSC09 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Gillian May Wheeler come amministratore in data 27 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Ann Elizabeth Brennan come amministratore in data 23 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen John Dwyer come amministratore in data 03 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Segretario | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| GATT, Jonathan Lawrence John | Amministratore | 201 Talgarth Road Hammersmith W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | Maltese | 228824220001 | |||||||||
| GIRLING, Paul Stewart | Amministratore | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 225432580001 | |||||||||
| GREEN, Pamela Anne | Segretario | 7 Belgravia Road St Johns WF1 3JP Wakefield West Yorkshire | British | 38435990009 | ||||||||||
| LAMB, Philip Ronald | Segretario | 80 Wroughton Road SW11 6BG London | British | 61718770001 | ||||||||||
| LIDDELL, Nigel | Segretario | Flat 2 27 Kingdon Road NW6 1PJ London | British | 65708280001 | ||||||||||
| ROSSINGTON, Paul Steven | Segretario | 21 Barley Brook Meadow Sharples BL1 7HP Bolton Lancashire | British | 18750870002 | ||||||||||
| SMYTH, Derek | Segretario | Alois Johannes Lippl Strasse 11 82166 Grafelfing FOREIGN Germany | British | 56554540001 | ||||||||||
| WHITE, Kevin Robert | Segretario | 35 Benett Drive BN3 6US Hove East Sussex | British | 3735730002 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED | Segretario | Ship Canal House King Street M2 4WB Manchester | 86546820001 | |||||||||||
| TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED | Segretario | Trafalgar House 29 Park Place LS1 2SP Leeds West Yorkshire | 50087010001 | |||||||||||
| ATKIN, John Duncan | Amministratore | 20 Hallside Park WA16 8NQ Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 4769830001 | |||||||||
| BEATON, Andrew Laurie | Amministratore | 3 Manor Road TW11 8BH Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 18079130002 | |||||||||
| BRECHT, Michael | Amministratore | 27 Donarail Street SW6 6EL London | British | 68271110001 | ||||||||||
| BRENNAN, Ann Elizabeth | Amministratore | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 137519160001 | |||||||||
| CASSON, John Heaton | Amministratore | Chase House The Street Worlington IP28 8RU Bury St Edmunds Suffolk | British | 78499960003 | ||||||||||
| CITRON, Zachary Joseph | Amministratore | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 91783950002 | |||||||||
| CITRON, Zachary Joseph | Amministratore | 23 Holders Hill Crescent NW14 1NE London | British | 91783950001 | ||||||||||
| CLARK, Roy Graham | Amministratore | 18 Rosary Gardens SW7 4NT London | British | 65257100001 | ||||||||||
| DOUGLAS, Stuart Robert | Amministratore | 23 Elmside Onslow Village GU2 7SH Guildford Surrey | British | 91330020001 | ||||||||||
| DWYER, Stephen John | Amministratore | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom | England | British | 57914140001 | |||||||||
| FORD, Michael | Amministratore | 14555 Freemanville Road 30004 Alpharetta Georgia Usa | American | 56506280001 | ||||||||||
| FUNCH, Henrik | Amministratore | Carinaparken 9c 3460 Birkeroed Denmark | Danish | 63424560001 | ||||||||||
| GOLDING, Jeremy | Amministratore | 21 Holland Park Gardens W14 8DZ London | British | 55861150002 | ||||||||||
| GREEN, Pamela Anne | Amministratore | 7 Belgravia Road St Johns WF1 3JP Wakefield West Yorkshire | British | 38435990009 | ||||||||||
| HEFFER, Philip | Amministratore | Deerbolts Cottage Blacksmith Green IP14 5PZ Wetheringsett | British | 80098040001 | ||||||||||
| HILTON, Peter Anthony | Amministratore | 22 Macleod Road RH13 5JL Horsham West Sussex | British | 68012190002 | ||||||||||
| HITCHIN, Paul Robert | Amministratore | 27 Northcliffe Close KT4 7DS Worcester Park Surrey | British | 114603290002 | ||||||||||
| JUX, Keith | Amministratore | Flat 1, 141 Old Woking Road Pyrford GU22 8PD Woking Surrey | British | 60622300001 | ||||||||||
| MCGOUN, Michael Frederick | Amministratore | The Old Rectory Church Lane Mobberley WA16 7RD Knutsford Cheshire | England | British | 8300340001 | |||||||||
| OLIVER, John Lancaster | Amministratore | Muhlgasse 11 Berg Bayern 82335 Germany | British | 87846400001 | ||||||||||
| SMITH, David Arthur | Amministratore | 4 Hillsborough Park GU15 1HG Camberley Surrey | United Kingdom | British | 141689930001 | |||||||||
| SOUTHWORTH, David Robert | Amministratore | Salmesbury 12 Millwood Close Withnell Fold PR6 8AR Chorley Lancashire | British | 6026950001 | ||||||||||
| WHEELER, Gillian May | Amministratore | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 114603310001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ge Ese Uk Limited | 06 giu 2017 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 31 mag 2017 | 20 dic 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 08 lug 1987 Consegnato il 28 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease d/d/ 13.5.84. | |
Brevi particolari The sum of £17,500 paid by personal computers PLC to bowstead PLC and placed in a specifically designated depsoit account. (Please see from 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 06 giu 1983 Consegnato il 09 giu 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 18 giu 1982 Consegnato il 30 giu 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H lower ground floor premises and ground floor premises of nos 218/226 bishopsgate london EC2 and the lower ground floor and ground floor premises known as 220/226 bishopsgate aforesaid and the ground floor shop and lower ground floor premises known as 218 bishopsgate london EC2. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0