PREGIS INTERNATIONAL LTD

PREGIS INTERNATIONAL LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPREGIS INTERNATIONAL LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01200088
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PREGIS INTERNATIONAL LTD?

    • fabbricazione di altri prodotti in plastica (22290) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova PREGIS INTERNATIONAL LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Aspect One
    Gunnels Wood Road
    SG1 2DG Stevenage
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PREGIS INTERNATIONAL LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FP INTERNATIONAL (UK) LIMITED16 set 200216 set 2002
    FLO-PAK (U.K.) LIMITED13 feb 197513 feb 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di PREGIS INTERNATIONAL LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per PREGIS INTERNATIONAL LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Cornelis Johannes Maria Oostrom come amministratore in data 01 giu 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Leon Poppegaai come amministratore in data 01 giu 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Leon Poppegaai come amministratore in data 03 nov 2022

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Pregis Europe Limited come persona con controllo significativo il 24 dic 2021

    2 paginePSC05

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione di Fpi Holding Company B.V. come persona con controllo significativo il 01 giu 2020

    1 paginePSC07

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    13 pagineAA

    Notifica di Pregis Europe Limited come persona con controllo significativo il 01 giu 2020

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Victory House 400 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7PA a Aspect One Gunnels Wood Road Stevenage SG1 2DG in data 11 mag 2020

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2019 al 31 dic 2019

    1 pagineAA01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2018

    15 pagineAA

    legacy

    57 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Chi sono gli amministratori di PREGIS INTERNATIONAL LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAUDHUIN, Kevin
    Lake Cook Road
    60015 Deerfield
    1650
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Lake Cook Road
    60015 Deerfield
    1650
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican204740650001
    LAVANWAY, Donald Keith
    Lake Cook Road
    60015 Deerfield
    1650
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Lake Cook Road
    60015 Deerfield
    1650
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican204740660001
    BLOOD, James
    605 Pisces Lane
    Foster City
    California Ca 94404
    Usa
    Segretario
    605 Pisces Lane
    Foster City
    California Ca 94404
    Usa
    American69366890001
    GOODMAN, Stephen Tony
    4 Orchard Drive
    Off Royton Drive Whittle-Le-Woods
    PR7 1XJ Chorley
    Lancashire
    Segretario
    4 Orchard Drive
    Off Royton Drive Whittle-Le-Woods
    PR7 1XJ Chorley
    Lancashire
    British42598360002
    YOUNG, George Hunter
    Penn 11 Plough Hill
    Cuffley
    EN6 4DN Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    Penn 11 Plough Hill
    Cuffley
    EN6 4DN Potters Bar
    Hertfordshire
    British9667110001
    BRIGHTMAN, Geoffrey William
    38 Willow Drive
    Bourton Grange
    MK18 7JH Buckingham
    Amministratore
    38 Willow Drive
    Bourton Grange
    MK18 7JH Buckingham
    British34946240001
    CAMPS, Rex
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    Amministratore
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    NetherlandsDutch196700920001
    CLARK, Michael
    Abbotts Wood Hill Road
    Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancs
    Amministratore
    Abbotts Wood Hill Road
    Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancs
    British3138650001
    CONNOR, Peter
    Carillon
    Bell Lane Syresham
    NN13 5HP Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    Carillon
    Bell Lane Syresham
    NN13 5HP Brackley
    Northamptonshire
    British10181590001
    DAVIES, David William
    77 Mably Grove
    OX12 9XW Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    77 Mably Grove
    OX12 9XW Wantage
    Oxfordshire
    United KingdomBritish98272270001
    FERNANDEZ, Dennis
    19684 Ashton Court
    Saratoga
    Santa Clara Ca 95070
    Usa
    Amministratore
    19684 Ashton Court
    Saratoga
    Santa Clara Ca 95070
    Usa
    American69366850001
    GOODMAN, Stephen Tony
    4 Orchard Drive
    Off Royton Drive Whittle-Le-Woods
    PR7 1XJ Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    4 Orchard Drive
    Off Royton Drive Whittle-Le-Woods
    PR7 1XJ Chorley
    Lancashire
    British42598360002
    GRAHAM, Arthur
    700 Westridge Drive
    Portola Valley
    California Ca 94028
    Usa
    Amministratore
    700 Westridge Drive
    Portola Valley
    California Ca 94028
    Usa
    UsaAmerican69366730001
    JACKSON, Steven
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    Amministratore
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    UsaAmerican196714870001
    LANE, Gordon Stuart
    6 Park Road
    High Barnet
    EN5 5SQ Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Park Road
    High Barnet
    EN5 5SQ Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish551970006
    MACFARLANE OF BEARSDEN, Lord
    50 Manse Road
    Bearsden
    G61 3PN Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    Amministratore
    50 Manse Road
    Bearsden
    G61 3PN Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    British51933510001
    MACKIE, William Paterson
    Clearwater 1 Queens Point
    Shandon
    G84 8QZ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Scotland
    Amministratore
    Clearwater 1 Queens Point
    Shandon
    G84 8QZ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Scotland
    British51933540001
    MARIA, Cornelis Johannes
    6422 Pd Heerlen
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    Amministratore
    6422 Pd Heerlen
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    NetherlandsDutch255123480001
    MATTHEWS, John Robert
    14 Brick Kiln Close
    NN12 6TG Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    14 Brick Kiln Close
    NN12 6TG Towcester
    Northamptonshire
    British10181580001
    MOHENG, Jean Charles
    5 Rue Henry Monnier
    FOREIGN Paris
    75009
    France
    Amministratore
    5 Rue Henry Monnier
    FOREIGN Paris
    75009
    France
    FranceFrench113500440001
    NEZWEK, Joe
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    Amministratore
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    United StatesAmerican196719920001
    OOSTROM, Cornelis Johannes Maria
    6422 Pd
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    Amministratore
    6422 Pd
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    NetherlandsDutch255316200001
    POPPEGAAI, Leon
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    Hertfordshire
    England
    NetherlandsDutch305565750001
    VAN LEUSDEN, Casper Hubertus Antonius Titus
    400 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7PA Northampton
    Victory House
    Amministratore
    400 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7PA Northampton
    Victory House
    NetherlandsDutch227961200001
    WALLACE, Richard Anthony
    3 Wolverton Road
    Marston Green
    B37 7XJ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    3 Wolverton Road
    Marston Green
    B37 7XJ Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish92603420001
    YOUNG, George Hunter
    Penn 11 Plough Hill
    Cuffley
    EN6 4DN Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Penn 11 Plough Hill
    Cuffley
    EN6 4DN Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish9667110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PREGIS INTERNATIONAL LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    England
    01 giu 2020
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09981936
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Fpi Holding Company B.V.
    Nijverheidsweg 4
    6422 Pd
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    09 mag 2016
    Nijverheidsweg 4
    6422 Pd
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    Forma giuridicaB.V.
    Paese di registrazioneNederlands
    Autorità legaleCompany Act In Holland
    Luogo di registrazioneDutch Chamber Of Commerce
    Numero di registrazione14052380
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PREGIS INTERNATIONAL LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 27 ott 2003
    Consegnato il 01 nov 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land adjoining buckingham road, brackley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 27 ott 2003
    Consegnato il 01 nov 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land on the south side of buckingham road, brackley and the land and buildings on the west side of boundary road and on the south side of buckingham road, brackley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Debenture
    Creato il 27 ott 2003
    Consegnato il 01 nov 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Debenture
    Creato il 03 apr 2001
    Consegnato il 19 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 apr 2001
    Consegnato il 11 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as land/blds on the west side of boundary road and on south side of buckingham rd,brackley,northamptonshire; t/nos HN12102 and HN11988.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0