R.S. MARSDEN (CHEMIST) LIMITED

R.S. MARSDEN (CHEMIST) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàR.S. MARSDEN (CHEMIST) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01200990
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di R.S. MARSDEN (CHEMIST) LIMITED?

    • Farmacia al dettaglio in negozi specializzati (47730) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova R.S. MARSDEN (CHEMIST) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Peterwood Way
    CR0 4UQ Croydon
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di R.S. MARSDEN (CHEMIST) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DAVID LEVAN (CHEMISTS) LIMITED31 gen 198431 gen 1984
    VICKERS AND STORER LIMITED20 feb 197520 feb 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di R.S. MARSDEN (CHEMIST) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per R.S. MARSDEN (CHEMIST) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2021

    8 pagineAA

    legacy

    69 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2020

    10 pagineAA

    legacy

    65 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Peterwood Way Croydon Surrey CR0 4UQ England a 2 Peterwood Way Croydon Surrey CR0 4UQ in data 28 apr 2020

    2 pagineAD01

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di R.S. MARSDEN (CHEMIST) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PATEL, Ameetkumar Ramanbhai
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    Segretario
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    198458190001
    PATEL, Heena
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector62369320002
    PATEL JUNIOR, Jayanti Chimanbhai
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector174158560001
    PATEL JUNIOR, Kirit Chimanbhai
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector101281110001
    MARSDEN, Richard Stephen
    Bishopton
    HG4 2QL Ripon
    Bishopton Rise
    North Yorkshire
    Segretario
    Bishopton
    HG4 2QL Ripon
    Bishopton Rise
    North Yorkshire
    British19086970001
    MARSDEN, Hazel Ann
    Bishopsgate Rise
    Bishopton
    HG4 2QL Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Bishopsgate Rise
    Bishopton
    HG4 2QL Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector44407680001
    MARSDEN, Richard Stephen
    Bishopton
    HG4 2QL Ripon
    Bishopton Rise
    North Yorkshire
    Amministratore
    Bishopton
    HG4 2QL Ripon
    Bishopton Rise
    North Yorkshire
    EnglandBritishPharmacist19086970001
    MORJARIA, Bhavin
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    Amministratore
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    EnglandBritishDirector165434900002
    MORJARIA, Nalin Mansukhlal
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    Amministratore
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United KingdomBritishOccupational Psychologist13151460002
    PATEL, Kirit Chimanbhai
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Lion Street
    WC1R 4GB London
    Lion House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector11545120001

    Chi sono le persone con controllo significativo di R.S. MARSDEN (CHEMIST) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peterwood Way
    CR0 4UQ Croydon
    2
    England
    06 apr 2016
    Peterwood Way
    CR0 4UQ Croydon
    2
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04395746
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    R.S. MARSDEN (CHEMIST) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2012
    Consegnato il 06 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 11 market place masham t/no NYK383771 fixed charge all benefits in respect of any insurances, assignment the rental income, the benefit of all guarantees, all agreements for lease see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2012
    Consegnato il 06 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 86 galgate barnard castle t/no DU275562 fixed charge all benefits in respect of any insurances, assignment the rental income, the benefit of all guarantees, all agreements for lease see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2012
    Consegnato il 06 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 81 north street ripon t/no NYK374099 fixed charge all benefits in respect of any insurances, assignment the rental income, the benefit of all guarantees, all agreements for lease see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2012
    Consegnato il 06 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 85 leeds road harrogate t/no NYK167657 fixed charge all benefits in respect of any insurances, assignment the rental income, the benefit of all guarantees, all agreements for lease see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2012
    Consegnato il 06 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 67 front street acomb york t/no NYK368424 fixed charge all benefits in respect of any insurances, assignment the rental income, the benefit of all guarantees, all agreements for lease see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 nov 2012
    Consegnato il 06 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 2008
    Consegnato il 03 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ground floor shop and storeroom at 67 front street acomb york t/no NYK26165 (part) by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 30 mag 2007
    Consegnato il 14 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    11 market place masham ripon north yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 06 set 2004
    Consegnato il 11 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    86 galgate barnard castle. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 gen 2004
    Consegnato il 22 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    81 north street ripon north yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 05 dic 2003
    Consegnato il 19 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    85 leeds road harrogate north yorkshire HG2 8BE l/H. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 09 giu 2001
    Consegnato il 30 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 4 westgate ripon. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 mag 2001
    Consegnato il 12 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 apr 1998
    Consegnato il 29 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of goodwill
    Creato il 18 set 1995
    Consegnato il 20 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and every interest in or over the goodwill of R.S.marsden (chemist) limited together with the full benefit of all licences and permissions in connection with the business of chemists and pharmacists carried on by the company from 4 westgate ripon north yorkshire and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 giu 1995
    Consegnato il 27 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    4 westgate ripon north yorkshire inc, fixtures & fittings (other than trade) plant & machinery and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 giu 1995
    Consegnato il 27 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    85 leeds road harrogate inc, fixtures & fittings (other than trade) plant & machinery with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 31 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 mag 1990
    Consegnato il 30 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 4 westgate ripon north yorkshire and/or the proceeds of the sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 mag 1990
    Consegnato il 30 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 4 westgate ripon north yorkshire and/or the proceeds of the sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 mag 1990
    Consegnato il 24 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 lug 1980
    Consegnato il 10 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 266 gleadless road, sheffield, south yorkshire title no syk 8852.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0