COUNTRY GARDEN CENTRES LIMITED

COUNTRY GARDEN CENTRES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTRY GARDEN CENTRES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01201436
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTRY GARDEN CENTRES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova COUNTRY GARDEN CENTRES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wyevale Garden Centres Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Middlesex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COUNTRY GARDEN CENTRES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BEACON GARDEN CENTRES LIMITED24 feb 197524 feb 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRY GARDEN CENTRES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRY GARDEN CENTRES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Justin Matthew King come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2015

    9 pagineAA

    Seconda presentazione per la cessazione di Nils Olin Steinmeyer come amministratore

    4 pagineRP04TM01

    Seconda presentazione per la cessazione di Kevin Michael Bradshaw come amministratore

    4 pagineRP04TM01

    Nomina di Mr Justin Matthew King come amministratore in data 18 ago 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 18 ago 2016

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Gerald Jones il 22 lug 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mag 2016

    Stato del capitale al 18 mag 2016

    • Capitale: GBP 1.2
    SH01

    Nomina di Mr Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Roger Mclaughlan come amministratore in data 10 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nils Olin Steinmeyer come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    22 set 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016

    Cessazione della carica di Kevin Michael Bradshaw come amministratore in data 10 mar 2016

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    22 set 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016

    Nomina di Mr Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 23 feb 2016

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2014

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nils Olin Steinmeyer il 07 apr 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 mag 2015

    Stato del capitale al 22 mag 2015

    • Capitale: GBP 1.2
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Garden Centre Group Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 22 mag 2015

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2013

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mag 2014

    Stato del capitale al 20 mag 2014

    • Capitale: GBP 1.2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di COUNTRY GARDEN CENTRES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCfo212265950001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCeo206428840001
    FORREST, David Mervyn
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    Segretario
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    British50457500001
    JONES, Anthony David
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    Segretario
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant73622510001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Segretario
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishCompany Director8690590001
    PEARCE, Patrick John
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    Segretario
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    BritishChartered Accountant28975060001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Segretario
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    BritishFinance Director76162020001
    SPENCER SMITH, Thomas Peter
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    Segretario
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    British1470160001
    BOOTH, Neville Edwin
    Mayville East Lane
    Chieveley
    RG16 8UY Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Mayville East Lane
    Chieveley
    RG16 8UY Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director53128670001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCompany Director124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector Of Retail Operation195802400001
    CAUNCE, John Geoffrey
    16 Beaconsfield Road
    Claygate
    KT10 0PW Esher
    Surrey
    Amministratore
    16 Beaconsfield Road
    Claygate
    KT10 0PW Esher
    Surrey
    BritishCompany Director1470170001
    EDWARDS, Sophia Anne
    Hyde End Mill Hyde End Lane
    Brimpton
    RG7 4RJ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Hyde End Mill Hyde End Lane
    Brimpton
    RG7 4RJ Reading
    Berkshire
    BritishFinance Director25038730001
    FAVELL, Gary Alan
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    Amministratore
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    United KingdomBritishChief Executive107699240001
    FORREST, David Mervyn
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    Amministratore
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    BritishCompany Director50457500001
    GOOD, David Reginald
    Westmorland House Station Road
    Kintbury
    RG17 9UP Hungerford
    Berkshire
    Amministratore
    Westmorland House Station Road
    Kintbury
    RG17 9UP Hungerford
    Berkshire
    BritishCompany Director26778380004
    HEWITT, Robert John
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    Amministratore
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director15486070002
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Amministratore
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director606430001
    HOPE, Susan Mary
    Farthing Hall
    Sprigs Holly Lane
    OX39 4BY Chinnor
    Oxfordshire
    Amministratore
    Farthing Hall
    Sprigs Holly Lane
    OX39 4BY Chinnor
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director109922130001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishInvestment Banker72128340003
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishDirector213157990001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCommercial Director111439220001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    Amministratore
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishCompany Director8690590001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishChairman207509410001
    PEARCE, Patrick John
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    EnglandBritishChartered Accountant28975060001
    PIERPOINT, David Julian
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    Amministratore
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    EnglandBritishDirector138653690001
    PRICE, Glyn John
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    Amministratore
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director73470720001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Amministratore
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director76162020001
    SPENCER SMITH, Thomas Peter
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    Amministratore
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    BritishCompany Director1470160001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomGermanFinancial Director211578220001
    STEVENSON, Barry John
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director102595670001
    VAUGHAN, David John
    Bryn Cain
    Penpergwm
    NP7 9AE Abergavenny
    Gwent
    Amministratore
    Bryn Cain
    Penpergwm
    NP7 9AE Abergavenny
    Gwent
    United KingdomBritishSolicitor44521810001

    COUNTRY GARDEN CENTRES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 24 feb 2009
    Consegnato il 04 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transazioni
    • 04 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a debenture
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 07 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property being wyevale garden centre hatton bank lane blackhill stratford upon avon, the f/h property at hythe road willesborough ashford kent, the l/h property at pield heath road hillingdon middlesex the l/h property at eridge road tunbridge wells kent,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent for the Finance Parties (Security Agent)
    Transazioni
    • 07 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 25 apr 1997
    Consegnato il 01 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a schedule to a transfer of even date
    Brevi particolari
    Land at hythe road sevington ashford kent transferred to county garden centres limited by the transfer dated 25 april 1997 and made between wilfred batt and wendy carole batt of the one part and county garden centres limited of the other part with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on such land. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilfred Batt and Wendy Carole Batt
    Transazioni
    • 01 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1997
    Consegnato il 12 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a river view garden centre stopham road pulborough west sussex t/n WSX141895 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1997
    Consegnato il 12 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h propety k/a whiteleggs garden centre main road knockholt sevenoaks kent and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1997
    Consegnato il 12 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a beauchamp clark garden centre mersham ashford kent and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1997
    Consegnato il 11 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a rosemead garden centre 44 wraysbury road staines middlesex and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1997
    Consegnato il 11 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a ongar garden centre langford bridge ongar road chipping ongar essex.t/no.EX560849 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 giu 1993
    Consegnato il 03 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC (as security trustee) and the secured parties as defined in a composite guarantee and mortgage debenture dated 08 12/92
    Brevi particolari
    Charge by way of legal morgage over all the l/h property k/a chalcraft nurseries punchbowl lane reigate road dorking surrey t/n SY582400, charge by way of legal mortgage over the f/h property k/a the lodge,bartons road,havant hampshire t/n SHP257542 and HP173533. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westinster Bank Plcas Security Trustee.
    Transazioni
    • 03 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 08 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever as security trustee for itself and on behalf of other banks (as defined)
    Brevi particolari
    See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 dic 1989
    Consegnato il 03 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining limpsfield road chelsham l/borough of croydon and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1990Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 dic 1989
    Consegnato il 03 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land k/a chalcraft nurseries punchbowl lane reigate road dorking surrey and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 28 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 feb 1988
    Consegnato il 16 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a bill and ben's garden centre blackhill warwick road stratford upon avon and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 dic 1987
    Consegnato il 31 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a telkamp garden centre limpsfield road chelsham warlingham surrey and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 1987
    Consegnato il 07 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barns garden centre, alcester road, burcot, bromsgrove t/n hw 50267 and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 feb 1987
    Consegnato il 09 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 31 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 set 1986
    Consegnato il 30 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and every interest of the company in or over property known as medland nurseries hordham road, alfold nr. Cranleigh surrey. Title no sy 369348 and/or the proceeds of sale thereof floating charge over all movable plant machinery ilements utensils furniture for equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 16 nov 1992Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 set 1986
    Consegnato il 27 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and every interest of beacon garden centres limited in or over the property k/a the nurseries, bath road eddington, hungerford title no bk 184381 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 ago 1986
    Consegnato il 19 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and every interest of beacon garden centres limited in or over the property k/a terrings nursery, hangleton lane. Ferring west sussex title no wsx 48695 and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 21 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 mar 1986
    Consegnato il 20 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H boxhill garden cartre, reigate road, dorking and/or the proceeds of sale theeof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 ago 1985
    Consegnato il 10 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property appx. 7 acres forming part of standbridge view farm, slaugham, sussex. And/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 11 apr 1985
    Consegnato il 26 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property known as casbah turnpike road thatchem berks and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 mar 1985
    Consegnato il 30 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H boxhill garden centre reigate road dorking. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 29 mar 1985
    Consegnato il 30 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H butchers nurseries, wickham road croydon. T/ns sgl 195751 & sy 295900. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 feb 1985
    Consegnato il 28 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000 and all monies due or to become due from the company to the chargees.
    Brevi particolari
    F/H andover garden centre, in the parish of abbotts ann.
    Persone aventi diritto
    • W.A. Liddell & D. Heckson.
    Transazioni
    • 28 feb 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0