PROCON ENGINEERING LIMITED

PROCON ENGINEERING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROCON ENGINEERING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01201645
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROCON ENGINEERING LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Stonedale Road
    Oldends Lane Industrial Estate
    GL10 3RQ Stonehouse
    Gloucestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DEFIANT WEIGHING LIMITED26 feb 197526 feb 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Alastair James Fleming come amministratore in data 31 ago 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Scott Reid come amministratore in data 09 lug 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 gen 2016

    Stato del capitale al 26 gen 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mr Robbert Oudendijk come amministratore in data 30 set 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Paul O'neil come amministratore in data 30 set 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher Paul O'neil il 22 lug 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2015

    Stato del capitale al 04 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Vestry Estate Otford Road Sevenoaks Kent TN14 5EL a Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ in data 30 ott 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2014

    Stato del capitale al 28 gen 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher Paul O'neil il 07 nov 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Alastair James Fleming il 07 nov 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Alastair James Fleming come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Valentine come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SLOAN, Alison May
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Segretario
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    180812090001
    OUDENDIJK, Robbert
    2806 Hh Gouda
    Tobias Asserstraat 1
    Netherlands
    Amministratore
    2806 Hh Gouda
    Tobias Asserstraat 1
    Netherlands
    NetherlandsDutch201609020001
    REID, Simon Scott
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Amministratore
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    ScotlandBritish248254430001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Segretario
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    163576240001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    Segretario
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    British140841820001
    ROBINSON, Keith Marshall
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    Segretario
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    British8282250001
    STEVENS, Michael Graham
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    Segretario
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    British24187010001
    STEVENS, Michael Graham
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    Segretario
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    British24187010001
    AUSTREID, Arne
    Pilehagen 1
    4250 Kopervik
    Norway
    Amministratore
    Pilehagen 1
    4250 Kopervik
    Norway
    Norwegian64646880001
    BADHAM, Philip Michael
    Yew Tree Cottage
    Tin Tern Gwent
    NP6 6SL
    Gwent
    Amministratore
    Yew Tree Cottage
    Tin Tern Gwent
    NP6 6SL
    Gwent
    British24187020001
    BAKKE, Knut Artur
    Andrenbakken 29
    1392 Vettre
    FOREIGN Norway
    Amministratore
    Andrenbakken 29
    1392 Vettre
    FOREIGN Norway
    Norwegian41654480001
    BERGSVIK, Eirik
    Ringveien 4
    Asker
    1386
    Norway
    Amministratore
    Ringveien 4
    Asker
    1386
    Norway
    Norwegian70953110001
    BOYLE, Thomas Douglas
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    Amministratore
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    UkBritish61611910001
    CHRISTIANSEN, Stig
    9b Brattliu
    FOREIGN Stavanger
    4020
    Norway
    Amministratore
    9b Brattliu
    FOREIGN Stavanger
    4020
    Norway
    Norwegian71135890001
    EIDE, Svein Inge
    Gamle Austrattvei 43
    4300 Sandnes
    Norway
    Amministratore
    Gamle Austrattvei 43
    4300 Sandnes
    Norway
    Norwegian49784670001
    FEILDEN, Michael Oswald
    Lubborn House
    Baltonsborough
    BA6 8QP Glastonbury
    Somerset
    Amministratore
    Lubborn House
    Baltonsborough
    BA6 8QP Glastonbury
    Somerset
    British11004750001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Amministratore
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    ScotlandBritish180854890001
    FOLVIK, Anne Marie
    Kirkeveien 175a
    Asker
    1370
    Norway
    Amministratore
    Kirkeveien 175a
    Asker
    1370
    Norway
    Norwegian75305350001
    FORWARD, Peter John
    12 Windmill Drive
    BR2 6BT Keston
    Kent
    Amministratore
    12 Windmill Drive
    BR2 6BT Keston
    Kent
    British24187000001
    HALLAS, Roy Olav
    Madlaforen 60
    Hafrsfjord, N-4042
    FOREIGN Norway
    Amministratore
    Madlaforen 60
    Hafrsfjord, N-4042
    FOREIGN Norway
    Norwegian67101840001
    HENRIKSEN, Bjorn Eie
    Austioattbanen 8
    4300 Sandnes
    Norway
    Amministratore
    Austioattbanen 8
    4300 Sandnes
    Norway
    Norweigian68672310001
    HJORT, Erik
    P O Box 36
    N 0321
    FOREIGN Oslo
    Norway
    Amministratore
    P O Box 36
    N 0321
    FOREIGN Oslo
    Norway
    Norweigan55612920002
    KEENER, David James
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    Amministratore
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    NetherlandsUsa161469350001
    KELLY, John Peter
    Rushcliffe
    Camp Road
    CR3 7LH Woldingham
    Surrey
    Amministratore
    Rushcliffe
    Camp Road
    CR3 7LH Woldingham
    Surrey
    British29155190001
    LUND, Reidar
    Melingsiden 26
    N-4056
    N-4056 Tananger
    Norway
    Amministratore
    Melingsiden 26
    N-4056
    N-4056 Tananger
    Norway
    Norweigian5325810001
    MALCOLM, Bryan Andrew
    Woodland Cottage St Johns Road
    TN6 1RT Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    Woodland Cottage St Johns Road
    TN6 1RT Crowborough
    East Sussex
    British6112110001
    MAXWELL-SCOTT, Ian
    Pondtail House
    West Hill Bank
    RH8 9JD Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Pondtail House
    West Hill Bank
    RH8 9JD Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish34876790001
    MELSTVEIT, Jan Erik
    Mvklabergveien 11
    Sandnes
    Rogaland 4314
    Norway
    Amministratore
    Mvklabergveien 11
    Sandnes
    Rogaland 4314
    Norway
    Norwegian118250360001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish162062160001
    ROOTS, Roy Alan
    25 Southridge Road
    TN6 1NG Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    25 Southridge Road
    TN6 1NG Crowborough
    East Sussex
    EnglandBritish44704570001
    SKEIE, Birger
    Hvetevein 1
    4635 Kristiansand
    Amministratore
    Hvetevein 1
    4635 Kristiansand
    Norwegian3206040001
    SKRETTING, Hakon
    Meiseveien 20
    4360 Varhaug
    FOREIGN Norway
    Amministratore
    Meiseveien 20
    4360 Varhaug
    FOREIGN Norway
    Norwegian40153840001
    STEVENS, Michael Graham
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish24187010001
    STEVENS, Michael Graham
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Bungalow
    Routs Green
    HP14 4BB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish24187010001
    VALENTINE, Steven Grenville
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    Amministratore
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    EnglandBritish92773870002

    Chi sono le persone con controllo significativo di PROCON ENGINEERING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Oldends Lane Industrial Estate
    GL10 3RQ Stonehouse
    Stonedale Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Oldends Lane Industrial Estate
    GL10 3RQ Stonehouse
    Stonedale Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03121604
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PROCON ENGINEERING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Single debenture
    Creato il 20 giu 1990
    Consegnato il 22 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 18 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 giu 1989
    Consegnato il 29 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Banque Arabe Et International D'investissement
    Transazioni
    • 29 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 gen 1985
    Consegnato il 21 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 09 dic 1981
    Consegnato il 17 dic 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,000 & all other monies due or to become due from the company to the charge
    Brevi particolari
    Block 1, units 1, 2 & 3 vestry estate, oxford, kent.
    Persone aventi diritto
    • Jermyn Group Services LTD.
    Transazioni
    • 17 dic 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0