PROCON ENGINEERING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PROCON ENGINEERING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01201645 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PROCON ENGINEERING LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse Gloucestershire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DEFIANT WEIGHING LIMITED | 26 feb 1975 | 26 feb 1975 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Alastair James Fleming come amministratore in data 31 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Scott Reid come amministratore in data 09 lug 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Robbert Oudendijk come amministratore in data 30 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Paul O'neil come amministratore in data 30 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Christopher Paul O'neil il 22 lug 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Vestry Estate Otford Road Sevenoaks Kent TN14 5EL a Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ in data 30 ott 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Christopher Paul O'neil il 07 nov 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Alastair James Fleming il 07 nov 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Alastair James Fleming come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven Valentine come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOAN, Alison May | Segretario | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 180812090001 | |||||||
| OUDENDIJK, Robbert | Amministratore | 2806 Hh Gouda Tobias Asserstraat 1 Netherlands | Netherlands | Dutch | 201609020001 | |||||
| REID, Simon Scott | Amministratore | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 248254430001 | |||||
| FLEMING, Alastair James | Segretario | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 163576240001 | |||||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Segretario | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire | British | 140841820001 | ||||||
| ROBINSON, Keith Marshall | Segretario | 15 Green Lane Oxhey WD19 4NL Watford | British | 8282250001 | ||||||
| STEVENS, Michael Graham | Segretario | The Old Bungalow Routs Green HP14 4BB Bledlow Ridge Buckinghamshire | British | 24187010001 | ||||||
| STEVENS, Michael Graham | Segretario | The Old Bungalow Routs Green HP14 4BB Bledlow Ridge Buckinghamshire | British | 24187010001 | ||||||
| AUSTREID, Arne | Amministratore | Pilehagen 1 4250 Kopervik Norway | Norwegian | 64646880001 | ||||||
| BADHAM, Philip Michael | Amministratore | Yew Tree Cottage Tin Tern Gwent NP6 6SL Gwent | British | 24187020001 | ||||||
| BAKKE, Knut Artur | Amministratore | Andrenbakken 29 1392 Vettre FOREIGN Norway | Norwegian | 41654480001 | ||||||
| BERGSVIK, Eirik | Amministratore | Ringveien 4 Asker 1386 Norway | Norwegian | 70953110001 | ||||||
| BOYLE, Thomas Douglas | Amministratore | Lanark Old Inn Road, Findon Portlethen AB12 3RT Aberdeen | Uk | British | 61611910001 | |||||
| CHRISTIANSEN, Stig | Amministratore | 9b Brattliu FOREIGN Stavanger 4020 Norway | Norwegian | 71135890001 | ||||||
| EIDE, Svein Inge | Amministratore | Gamle Austrattvei 43 4300 Sandnes Norway | Norwegian | 49784670001 | ||||||
| FEILDEN, Michael Oswald | Amministratore | Lubborn House Baltonsborough BA6 8QP Glastonbury Somerset | British | 11004750001 | ||||||
| FLEMING, Alastair James | Amministratore | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 180854890001 | |||||
| FOLVIK, Anne Marie | Amministratore | Kirkeveien 175a Asker 1370 Norway | Norwegian | 75305350001 | ||||||
| FORWARD, Peter John | Amministratore | 12 Windmill Drive BR2 6BT Keston Kent | British | 24187000001 | ||||||
| HALLAS, Roy Olav | Amministratore | Madlaforen 60 Hafrsfjord, N-4042 FOREIGN Norway | Norwegian | 67101840001 | ||||||
| HENRIKSEN, Bjorn Eie | Amministratore | Austioattbanen 8 4300 Sandnes Norway | Norweigian | 68672310001 | ||||||
| HJORT, Erik | Amministratore | P O Box 36 N 0321 FOREIGN Oslo Norway | Norweigan | 55612920002 | ||||||
| KEENER, David James | Amministratore | 4819 Xp Rijsbergen Oranjestraat 33 Netherlands | Netherlands | Usa | 161469350001 | |||||
| KELLY, John Peter | Amministratore | Rushcliffe Camp Road CR3 7LH Woldingham Surrey | British | 29155190001 | ||||||
| LUND, Reidar | Amministratore | Melingsiden 26 N-4056 N-4056 Tananger Norway | Norweigian | 5325810001 | ||||||
| MALCOLM, Bryan Andrew | Amministratore | Woodland Cottage St Johns Road TN6 1RT Crowborough East Sussex | British | 6112110001 | ||||||
| MAXWELL-SCOTT, Ian | Amministratore | Pondtail House West Hill Bank RH8 9JD Oxted Surrey | United Kingdom | British | 34876790001 | |||||
| MELSTVEIT, Jan Erik | Amministratore | Mvklabergveien 11 Sandnes Rogaland 4314 Norway | Norwegian | 118250360001 | ||||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Amministratore | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire United Kingdom | United Kingdom | British | 162062160001 | |||||
| ROOTS, Roy Alan | Amministratore | 25 Southridge Road TN6 1NG Crowborough East Sussex | England | British | 44704570001 | |||||
| SKEIE, Birger | Amministratore | Hvetevein 1 4635 Kristiansand | Norwegian | 3206040001 | ||||||
| SKRETTING, Hakon | Amministratore | Meiseveien 20 4360 Varhaug FOREIGN Norway | Norwegian | 40153840001 | ||||||
| STEVENS, Michael Graham | Amministratore | The Old Bungalow Routs Green HP14 4BB Bledlow Ridge Buckinghamshire | United Kingdom | British | 24187010001 | |||||
| STEVENS, Michael Graham | Amministratore | The Old Bungalow Routs Green HP14 4BB Bledlow Ridge Buckinghamshire | United Kingdom | British | 24187010001 | |||||
| VALENTINE, Steven Grenville | Amministratore | 4 Barnes Close Haslington CW1 5ZG Crewe | England | British | 92773870002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PROCON ENGINEERING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydralift Holdings Uk Limited | 06 apr 2016 | Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse Stonedale Road Gloucestershire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PROCON ENGINEERING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Single debenture | Creato il 20 giu 1990 Consegnato il 22 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 giu 1989 Consegnato il 29 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 09 gen 1985 Consegnato il 21 gen 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 09 dic 1981 Consegnato il 17 dic 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £10,000 & all other monies due or to become due from the company to the charge | |
Brevi particolari Block 1, units 1, 2 & 3 vestry estate, oxford, kent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0