WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED
Panoramica
Nome della società | WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01202465 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Unit A Brook Park East Road Shirebrook NG20 8RY Mansfield Nottinghamshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
O.E. COMPONENT SERVICE LIMITED | 05 mar 1975 | 05 mar 1975 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 28 apr 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 28 apr 2019 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Cameron John Olsen come segretario in data 01 lug 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Thomas James Piper come segretario in data 01 lug 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alastair Peter Orford Dick il 01 mag 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alastair Peter Orford Dick come amministratore in data 14 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rachel Isabel Lilian Stockton come amministratore in data 14 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 29 apr 2018 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 apr 2017 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 24 apr 2016 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Miss Rachel Isabel Lilian Stockton come amministratore in data 14 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Adedotun Ademola Adegoke come amministratore in data 14 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Karen Byers come amministratore in data 14 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Michael Forsey come amministratore in data 14 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gaynor Willis come amministratore in data 06 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Andrew Sear come amministratore in data 06 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 apr 2015 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPER, Thomas James | Segretario | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 260011470001 | |||||||
ADEGOKE, Adedotun Ademola | Amministratore | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | Senior Buyer | 203129860001 | ||||
DICK, Alastair Peter Orford | Amministratore | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 256598390002 | ||||
OLSEN, Cameron John | Segretario | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 183513300001 | |||||||
ORANGE, Jennifer Margaret | Segretario | Hill View Moleskinhill Sharpenhoe Road Sharpenhoe MK45 4SH Bedford | British | Co-Director | 6109100003 | |||||
TYLEE-BIRDSALL, Rebecca Louise | Segretario | Brook Park East Road Shirebrook NG20 8RY Mansfield Unit A Nottinghamshire United Kingdom | 177119510001 | |||||||
WILLIS, Gaynor | Segretario | Putnoe Lane MK41 9AE Bedford 4 United Kingdom | British | 117342490003 | ||||||
BISHOP, Cliff Brian | Amministratore | Hill View Moleskinhill Sharpenhoe Road Sharpenhoe MK45 4SH Bedford | United Kingdom | British | Managing Director | 14023670002 | ||||
BONHAM, Anne Margaret | Amministratore | 15 Bigthan Road LU5 4HX Dunstable Bedfordshire | Gb-Eng | British | Director | 113022580001 | ||||
BONHAM, Anne Margaret | Amministratore | 15 Bigthan Road LU5 4HX Dunstable Bedfordshire | Gb-Eng | British | Finance | 113022580001 | ||||
BYERS, Karen | Amministratore | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 97609710003 | ||||
FORSEY, David Michael | Amministratore | Brook Park East Road Shirebrook NG20 8RY Mansfield Unit A Nottinghamshire England | England | British | Director | 147207580002 | ||||
LEACH, Barry John | Amministratore | Brook Park East Road Shirebrook NG20 8RY Mansfield Unit A Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 69943870013 | ||||
ORANGE, Jennifer Margaret | Amministratore | Hill View Moleskinhill Sharpenhoe Road Sharpenhoe MK45 4SH Bedford | United Kingdom | British | Co-Director | 6109100003 | ||||
SEAR, Mark Andrew | Amministratore | Dencora Way LU3 3HP Luton 3 England | England | British | Coo | 177292240001 | ||||
STOCKTON, Rachel Isabel Lilian | Amministratore | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Customs And Vat | 245592990001 | ||||
TAYLOR, Lindsey Kathryn | Amministratore | 141 Avenue Des Eucclyptus Biot Alpes Maritime 06410 France | British | Marketing | 113022570001 | |||||
WILLIS, Gaynor | Amministratore | Putnoe Lane MK41 9AE Bedford 4 Bedfordshire | Gb-Eng | British | Director | 117342490004 | ||||
WILLIS, Simon Anthony | Amministratore | Timber Lane MK17 9PL Woburn 41 Buckinghamshire | England | British | Director | 79968100005 | ||||
WILSON, Charles Gordon | Amministratore | 124 Goldington Road MK40 3EA Bedford Bedfordshire | British | Swimming Coach | 20520030001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Of Service Limited | 06 apr 2016 | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
All assets debenture | Creato il 06 nov 2009 Consegnato il 12 nov 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of keyman life policy | Creato il 13 dic 2007 Consegnato il 28 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Anne margaret bonham scottish equitable policy no L0194635203 dated 18/10/2007 for £250000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of keyman life policy | Creato il 13 dic 2007 Consegnato il 28 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Simon anthony willis scottish equitable policy no L0196294203 dated 17/10/2007 for £500000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 23 mar 2007 Consegnato il 29 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company (formerly known as O.E. component service limited) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 06 mar 1986 Consegnato il 12 mar 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the interest of the company in the land & premises subject matter of the licence agreement & form of lease dated 28-11-1985 relating to land situate at albert road luton forming the sites of 52-58 (even) albert rd, being 566 square metres. (For full details see doc M29). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 04 ott 1982 Consegnato il 13 ott 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on all book & other debts floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those above) uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0