WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED

WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01202465
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit A Brook Park East Road
    Shirebrook
    NG20 8RY Mansfield
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    O.E. COMPONENT SERVICE LIMITED05 mar 197505 mar 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 apr 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 28 apr 2019

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Cameron John Olsen come segretario in data 01 lug 2019

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Thomas James Piper come segretario in data 01 lug 2019

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alastair Peter Orford Dick il 01 mag 2019

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Alastair Peter Orford Dick come amministratore in data 14 mar 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Rachel Isabel Lilian Stockton come amministratore in data 14 mar 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 29 apr 2018

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 apr 2017

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 24 apr 2016

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Miss Rachel Isabel Lilian Stockton come amministratore in data 14 ott 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Adedotun Ademola Adegoke come amministratore in data 14 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Karen Byers come amministratore in data 14 ott 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Michael Forsey come amministratore in data 14 ott 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gaynor Willis come amministratore in data 06 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Andrew Sear come amministratore in data 06 lug 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 apr 2015

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 nov 2015

    Stato del capitale al 03 nov 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PIPER, Thomas James
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Segretario
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    260011470001
    ADEGOKE, Adedotun Ademola
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Amministratore
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    United KingdomBritishSenior Buyer203129860001
    DICK, Alastair Peter Orford
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Amministratore
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector256598390002
    OLSEN, Cameron John
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Segretario
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    183513300001
    ORANGE, Jennifer Margaret
    Hill View Moleskinhill
    Sharpenhoe Road Sharpenhoe
    MK45 4SH Bedford
    Segretario
    Hill View Moleskinhill
    Sharpenhoe Road Sharpenhoe
    MK45 4SH Bedford
    BritishCo-Director6109100003
    TYLEE-BIRDSALL, Rebecca Louise
    Brook Park East Road
    Shirebrook
    NG20 8RY Mansfield
    Unit A
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Brook Park East Road
    Shirebrook
    NG20 8RY Mansfield
    Unit A
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    177119510001
    WILLIS, Gaynor
    Putnoe Lane
    MK41 9AE Bedford
    4
    United Kingdom
    Segretario
    Putnoe Lane
    MK41 9AE Bedford
    4
    United Kingdom
    British117342490003
    BISHOP, Cliff Brian
    Hill View Moleskinhill
    Sharpenhoe Road Sharpenhoe
    MK45 4SH Bedford
    Amministratore
    Hill View Moleskinhill
    Sharpenhoe Road Sharpenhoe
    MK45 4SH Bedford
    United KingdomBritishManaging Director14023670002
    BONHAM, Anne Margaret
    15 Bigthan Road
    LU5 4HX Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    15 Bigthan Road
    LU5 4HX Dunstable
    Bedfordshire
    Gb-EngBritishDirector113022580001
    BONHAM, Anne Margaret
    15 Bigthan Road
    LU5 4HX Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    15 Bigthan Road
    LU5 4HX Dunstable
    Bedfordshire
    Gb-EngBritishFinance113022580001
    BYERS, Karen
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Amministratore
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector97609710003
    FORSEY, David Michael
    Brook Park East Road
    Shirebrook
    NG20 8RY Mansfield
    Unit A
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    Brook Park East Road
    Shirebrook
    NG20 8RY Mansfield
    Unit A
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritishDirector147207580002
    LEACH, Barry John
    Brook Park East Road
    Shirebrook
    NG20 8RY Mansfield
    Unit A
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Brook Park East Road
    Shirebrook
    NG20 8RY Mansfield
    Unit A
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69943870013
    ORANGE, Jennifer Margaret
    Hill View Moleskinhill
    Sharpenhoe Road Sharpenhoe
    MK45 4SH Bedford
    Amministratore
    Hill View Moleskinhill
    Sharpenhoe Road Sharpenhoe
    MK45 4SH Bedford
    United KingdomBritishCo-Director6109100003
    SEAR, Mark Andrew
    Dencora Way
    LU3 3HP Luton
    3
    England
    Amministratore
    Dencora Way
    LU3 3HP Luton
    3
    England
    EnglandBritishCoo177292240001
    STOCKTON, Rachel Isabel Lilian
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Amministratore
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Customs And Vat245592990001
    TAYLOR, Lindsey Kathryn
    141 Avenue Des Eucclyptus
    Biot
    Alpes Maritime 06410
    France
    Amministratore
    141 Avenue Des Eucclyptus
    Biot
    Alpes Maritime 06410
    France
    BritishMarketing113022570001
    WILLIS, Gaynor
    Putnoe Lane
    MK41 9AE Bedford
    4
    Bedfordshire
    Amministratore
    Putnoe Lane
    MK41 9AE Bedford
    4
    Bedfordshire
    Gb-EngBritishDirector117342490004
    WILLIS, Simon Anthony
    Timber Lane
    MK17 9PL Woburn
    41
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Timber Lane
    MK17 9PL Woburn
    41
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector79968100005
    WILSON, Charles Gordon
    124 Goldington Road
    MK40 3EA Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    124 Goldington Road
    MK40 3EA Bedford
    Bedfordshire
    BritishSwimming Coach20520030001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06020729
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WORLD OF SERVICE INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 06 nov 2009
    Consegnato il 12 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 12 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 13 dic 2007
    Consegnato il 28 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Anne margaret bonham scottish equitable policy no L0194635203 dated 18/10/2007 for £250000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 13 dic 2007
    Consegnato il 28 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Simon anthony willis scottish equitable policy no L0196294203 dated 17/10/2007 for £500000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 mar 2007
    Consegnato il 29 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as O.E. component service limited) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2008
    • 30 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 06 mar 1986
    Consegnato il 12 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the interest of the company in the land & premises subject matter of the licence agreement & form of lease dated 28-11-1985 relating to land situate at albert road luton forming the sites of 52-58 (even) albert rd, being 566 square metres. (For full details see doc M29).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 04 ott 1982
    Consegnato il 13 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book & other debts floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0