A.C. ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | A.C. ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01204867 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di A.C. ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova A.C. ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 2 Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DY Warwick Warwickshire United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di A.C. ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| A.C. ELECTRICAL WHOLESALE PLC | 19 nov 1982 | 19 nov 1982 |
| POOLE A.C. ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED | 24 mar 1975 | 24 mar 1975 |
Quali sono gli ultimi bilanci di A.C. ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 lug 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per A.C. ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 lug 2022 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 dic 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 25 lug 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Wolseley Uk Directors Limited il 04 feb 2022 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio modificato redatto al 31 lug 2021 | 15 pagine | AAMD | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 lug 2021 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 lug 2020 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Katherine Mary Mccormick come segretario in data 04 dic 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Nicky Paul Randle come segretario in data 04 dic 2020 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 lug 2019 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di A.C. Electrical Holdings Limited come persona con controllo significativo il 03 dic 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Wolseley Uk Directors Limited il 03 dic 2018 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Wolseley Center Harrison Way Leamington Spa CV31 3HH a 2 Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill Warwick Warwickshire CV34 6DY in data 03 dic 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di A.C. ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANDLE, Nicky Paul | Segretario | Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DY Warwick 2 Warwickshire United Kingdom | 277600800001 | |||||||||||
| GRAY, Simon | Amministratore | Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DY Warwick 2 Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | 243497760001 | |||||||||
| WOLSELEY DIRECTORS LIMITED | Amministratore | Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DY Warwick 2 Warwickshire United Kingdom |
| 190186170003 | ||||||||||
| BELL, David Robert | Segretario | 1 Dunkeld Road BH3 7EN Bournemouth Dorset | British | 1577630001 | ||||||||||
| FRENCH, Vanessa | Segretario | Harrison Way CV31 3HH Leamington Spa The Wolseley Center United Kingdom | 179444360001 | |||||||||||
| MCCORMICK, Katherine Mary | Segretario | Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DY Warwick 2 Warwickshire United Kingdom | 247119130001 | |||||||||||
| MIDDLEMISS, Graham | Segretario | 20 Spindle Lane Dickens Heath B90 1RP Solihull West Midlands | British | 100701940002 | ||||||||||
| BELL, David Robert | Amministratore | 1 Dunkeld Road BH3 7EN Bournemouth Dorset | British | 1577630001 | ||||||||||
| HANCOX, Elizabeth Louise, Dr | Amministratore | Harrison Way CV31 3HH Leamington Spa The Wolseley Center United Kingdom | United Kingdom | British | 210216760001 | |||||||||
| HARDING, Derek John | Amministratore | The Wolseley Center Harrison Way CV31 3HH Leamington Spa | United Kingdom | British | 152377500001 | |||||||||
| HODGES, Stewart Neville | Amministratore | 83 Luddington Road CV37 9SG Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 53099300001 | ||||||||||
| JONES, Keith Harold Davenport | Amministratore | The Wolseley Center Harrison Way CV31 3HH Leamington Spa | England | British | 95915810001 | |||||||||
| KELLY, John Joseph | Amministratore | Roselawn Coppice Merley Park Road Ashington BH21 3DB Wimborne Dorset | England | British | 2168620003 | |||||||||
| MIDDLEMISS, Graham | Amministratore | 20 Spindle Lane Dickens Heath B90 1RP Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 100701940002 | |||||||||
| MORRIS, Anthony Charles | Amministratore | Cunningham Drive LE17 4YR Lutterworth 62 Leics | United Kingdom | British | 133752480001 | |||||||||
| NEVILLE, Matthew James | Amministratore | 9 The Brickall Long Marston CV37 8QL Stratford Upon Avon Warwickshire | England | British | 85093360003 | |||||||||
| RICHARDSON, Harold Bevan | Amministratore | Galteemore Cahir Holtwood BH21 7DX Wimborne Dorset | British | 42555600001 | ||||||||||
| RONCHETTI, Marc Arthur | Amministratore | Harrison Way CV31 3HH Leamington Spa The Wolseley Center United Kingdom | England | British | 247980780001 | |||||||||
| ROSE, Richard Sidney | Amministratore | Ivonbrook 27 Totteridge Village N20 8PN London | England | British | 20113670001 | |||||||||
| SQUIRES, Ian Stanley | Amministratore | 91 Dunyeats Road BH18 8AF Broadstone Dorset | British | 13686990001 | ||||||||||
| TILLOTSON, Ian | Amministratore | The Ashes 16 Hughes Hill CV35 7AS Shrewley Warwickshire | United Kingdom | British | 109050510001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di A.C. ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C. Electrical Holdings Limited | 06 apr 2016 | Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DY Warwick 2 Warwickshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
A.C. ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Single debenture | Creato il 16 feb 1994 Consegnato il 25 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 16 dic 1991 Consegnato il 24 dic 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & premises k/a part of t/n wm 15665 on the south west side of cheapside birmingham & buildings & fixtures & goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 16 nov 1990 Consegnato il 28 nov 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Amberlay house, new street, ringwood hampshire, with a:- & goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 gen 1986 Consegnato il 31 gen 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Inc heritable property and assets in scotland. (See doc M8). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0