CHARNWOOD FOODS LIMITED

CHARNWOOD FOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHARNWOOD FOODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01205129
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    • Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BUTTERKUP FOODS LIMITED28 ago 198628 ago 1986
    SAMAC FOOD SERVICES LIMITED26 mar 197526 mar 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 set 2012

    Stato del capitale al 25 set 2012

    • Capitale: GBP 1,500,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Nomina di Emmett Mcevoy come amministratore in data 20 apr 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Antony David Smith come amministratore in data 20 apr 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Andrew Mcdonald come amministratore in data 15 nov 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Suzanne Elizabeth Wise come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Avviso di rimozione della restrizione sullo statuto sociale

    2 pagineCC02

    Risoluzioni

    Resolutions
    34 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Antony David Smith come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Peeler come amministratore

    2 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Michael Peeler il 05 giu 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Suzanne Elizabeth Wise il 05 giu 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Simon Nicholas Wilbraham il 05 giu 2011

    1 pagineCH03

    Nomina di Mr Simon Nicholas Wilbraham come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Segretario
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Segretario
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Segretario
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Segretario
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Amministratore
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Amministratore
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Amministratore
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    GRANT, Brian John
    The Light House
    North Street Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    The Light House
    North Street Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish64875090001
    HARGREAVES, Stephen John
    Stable House
    Smeeton Road
    LE8 0QT Saddington
    Leicestershire
    Amministratore
    Stable House
    Smeeton Road
    LE8 0QT Saddington
    Leicestershire
    Great BritainBritish99437380001
    HODSON, Mark Anthony
    Orchard Barn
    Bulby
    PE10 0RU Bourne
    Lincolnshire
    Amministratore
    Orchard Barn
    Bulby
    PE10 0RU Bourne
    Lincolnshire
    EnglandBritish142364940001
    KELLY, Timothy Geoffrey
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    Amministratore
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    EnglandBritish92817300001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Amministratore
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    British84644240002
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    OAKLEY, Christopher Richard
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124625030001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Amministratore
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish87359710001
    PICKERING, Alistair Neil
    13 Upper Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7UW Bristol
    Amministratore
    13 Upper Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7UW Bristol
    United KingdomBritish83785410002
    QUICK, Nigel Robert
    Autumn Cottage
    8 Gladstone Street
    LE8 0HL Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    Amministratore
    Autumn Cottage
    8 Gladstone Street
    LE8 0HL Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    British36629900001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish98350001
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Amministratore
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish42065200002
    SIMMONS, Alex Thomas
    39 Pedmore Lane
    Pedmore
    DY9 0SY Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    39 Pedmore Lane
    Pedmore
    DY9 0SY Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish105865430001
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147725160001
    SWEENEY, Brendan John
    Long Owl Barn
    Coed Y Paen
    NP4 0TB Pontypool
    Gwent
    Amministratore
    Long Owl Barn
    Coed Y Paen
    NP4 0TB Pontypool
    Gwent
    British Irish79007350001
    WHITING, Timothy James
    57 Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    57 Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    Warwickshire
    British44028500002
    WIGNALL, Howard Ernest Edwin
    62 Garland
    Rothley
    LE7 7RG Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    62 Garland
    Rothley
    LE7 7RG Leicester
    Leicestershire
    British32234150001

    CHARNWOOD FOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 26 lug 2004
    Consegnato il 06 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Loweth woods magna road south wigston leicester f/h, de montford (garage) magna road south wigston leicester f/H. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 06 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    Creato il 11 set 2000
    Consegnato il 23 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    Transazioni
    • 23 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 lug 1981
    Consegnato il 23 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital & all buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 20 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit of deeds without instrument
    Creato il 20 set 1979
    Consegnato il 24 set 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Lease of premises at carpenters place, london SW4.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 20 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit of deeds without instrument
    Creato il 20 set 1979
    Consegnato il 24 set 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H premises known as unit A3, park hall road trading estate, london SE21.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 20 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0