COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED

COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01208652
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Composites House
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Derbyshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 21 dic 2016

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Authority to have minimum number of directors as one 12/12/2016
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prm a/c 12/12/2016
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Roy Douglas Smith come amministratore in data 30 ago 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Daniel George Darazsdi come amministratore in data 30 ago 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Alison Murphy come segretario in data 30 ago 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Roy Douglas Smith come segretario in data 30 ago 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Adrianus Laurentius Schiebroek come amministratore in data 30 ago 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 giu 2016

    Stato del capitale al 07 giu 2016

    • Capitale: GBP 640,100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 giu 2015

    Stato del capitale al 03 giu 2015

    • Capitale: GBP 640,100
    SH01

    Nomina di Mr Daniel George Darazsdi come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Daniel George Darazsdi come amministratore in data 01 nov 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David M Drillock come amministratore in data 31 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 giu 2014

    Stato del capitale al 10 giu 2014

    • Capitale: GBP 640,100
    SH01

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MURPHY, Alison
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Segretario
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    214334930001
    SCHIEBROEK, Adrianus Laurentius
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    NetherlandsDutchTax Manager214317980001
    BOWERS, Steven John
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    British61929330004
    LEE, Maurice Milson
    90 Giffords Cross Road
    SS17 7QQ Corringham
    Essex
    Segretario
    90 Giffords Cross Road
    SS17 7QQ Corringham
    Essex
    British115467610001
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Segretario
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    171432740001
    BEAUMONT, Richard John Kirby
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishAccountant98953190001
    BOWERS, Steven John
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Amministratore
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Secretary176189250001
    CULNANE, Paul Alexander
    21 Oxhouse Court
    Shenley Brook End
    MK5 7GL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    21 Oxhouse Court
    Shenley Brook End
    MK5 7GL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    UkBritishDirector107502650001
    DARAZSDI, Daniel George
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    UsaAmericanChief Financial Officer195049720001
    DRILLOCK, David M
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    United StatesAmericanAccountant170878740001
    GREEN, Paul Andrew
    2 Jubilee Villas
    Dassels
    SG11 2RW Braughing
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Jubilee Villas
    Dassels
    SG11 2RW Braughing
    Hertfordshire
    United KingdomBritishMarketing Director109248560001
    HART, David John
    18 Farrow Gardens
    RM16 2EU Grays
    Essex
    Amministratore
    18 Farrow Gardens
    RM16 2EU Grays
    Essex
    BritishSales Director68384420001
    HASLEHURST, Peter Joseph Kinder
    Old Crowholt Farm
    Cowbrook Lane Gawsworth
    SK11 0JH Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Old Crowholt Farm
    Cowbrook Lane Gawsworth
    SK11 0JH Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director39820040001
    HAWKINS, Ian Roger
    The Old Colley Farm
    Coppice Lane
    RH2 9JE Reigate
    Surrey
    Amministratore
    The Old Colley Farm
    Coppice Lane
    RH2 9JE Reigate
    Surrey
    BritishCompany Director15991450002
    HOBBS, Jeffrey Jacques
    1 Cedar Copse
    BR1 2NY Bromley
    Kent
    Amministratore
    1 Cedar Copse
    BR1 2NY Bromley
    Kent
    BritishCompany Director3252730001
    LEE, Maurice Milson
    90 Giffords Cross Road
    SS17 7QQ Corringham
    Essex
    Amministratore
    90 Giffords Cross Road
    SS17 7QQ Corringham
    Essex
    BritishDirector115467610001
    LIDDLE, Matthew
    54 High Street
    MK45 5DY Flitton
    Bedfordshire
    Amministratore
    54 High Street
    MK45 5DY Flitton
    Bedfordshire
    United KingdomBritishCompany Director35090550001
    LONG, Peter Terence
    43 Kelso Close
    Worth
    RH10 7XH Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    43 Kelso Close
    Worth
    RH10 7XH Crawley
    West Sussex
    BritishOperations Director68384400001
    MARTIN, David Barrington
    6 Copse Lane The Copse
    Hamble
    SO31 4QH Southampton
    Amministratore
    6 Copse Lane The Copse
    Hamble
    SO31 4QH Southampton
    BritishCompany Director44386840006
    MCKNIGHT, William John
    75 Ashley Road
    KT18 5BN Epsom
    Surrey
    Amministratore
    75 Ashley Road
    KT18 5BN Epsom
    Surrey
    BritishCompany Director6788940001
    MOSS, Andrew Brian
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Amministratore
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector161928410001
    PARKINSON, John
    7 Stourton Mews
    Stourton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 Stourton Mews
    Stourton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director10307790001
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Amministratore
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector123487130001
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    UsaUsaAttorney170877010001
    SNOWDON, Clive John
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director32242700001
    WALKER, Joan Elizabeth
    3 Meadow View
    Bicknacre
    CM3 4HR Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    3 Meadow View
    Bicknacre
    CM3 4HR Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director28418730001
    WALKER, John Siddall
    The Thatched Barn Eye Road
    IP21 5BA Hoxne
    Suffolk
    Amministratore
    The Thatched Barn Eye Road
    IP21 5BA Hoxne
    Suffolk
    EnglishCompany Director10306840004
    WHYTE, James Stevenson
    9 Palmers Croft
    CM2 6SR Chelmsford
    Amministratore
    9 Palmers Croft
    CM2 6SR Chelmsford
    BritishDirector97922850002

    COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 11 dic 2009
    Consegnato il 30 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement 27TH october 1997,
    Creato il 23 nov 2006
    Consegnato il 29 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/10/1997
    Creato il 16 lug 2004
    Consegnato il 22 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 13 feb 1996
    Consegnato il 01 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Compstock house, london road, stanford le hope by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 17 giu 1994
    Consegnato il 23 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 mag 1994
    Consegnato il 06 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 06 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further charge and mortgage
    Creato il 22 dic 1989
    Consegnato il 05 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20,000 and all other monies due or to become due from the company and/or ian robert hawkins to the chargee
    Brevi particolari
    F/H compstock house, london road stanford le hope essex. Title no ex 226930.
    Persone aventi diritto
    • Sun Alliance and London Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 05 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 18 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 15 nov 1988
    Consegnato il 17 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H compstock house london road stanford le hope essex title no. Ex 226930.
    Persone aventi diritto
    • Sun Alliance and London Assurance Co. LTD.
    Transazioni
    • 17 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 set 1988
    Consegnato il 04 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings k/a compstock house, lying on the north side of london road, stanford le-hope, essex title no: ex 226930.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 giu 1987
    Consegnato il 09 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    Further charge and mortgage and deed of variation
    Creato il 05 ott 1984
    Consegnato il 10 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Varies the amount secured by the mortgage dated 14TH december 1979 to £150,000
    Brevi particolari
    All that land & office building k/a compstock house london road stanford-le-hope in the county of essex with freehold title absolute under title no. EX226930 (nb: formerly k/a steadeal house).
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Assurance Public Limited Company
    Transazioni
    • 10 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 06 apr 1984
    Consegnato il 16 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over book & other debts floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts (exc those mentioned aove) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Deed of variation
    Creato il 08 ago 1980
    Consegnato il 09 ago 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Varies the amount secured by the mortgage d/d 14/12/78 to £50,000 regd 9/8/80.
    Brevi particolari
    Varying terms of a mortgage d/d 14/12/78 so as to limit the sum of money charged by the mortgage to £50,000.
    Persone aventi diritto
    • Brown Shipley & Co LTD
    Transazioni
    • 09 ago 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 20 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0