COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED
Panoramica
Nome della società | COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01208652 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Composites House Sinclair Close DE75 7SP Heanor Derbyshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 21 dic 2016
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Roy Douglas Smith come amministratore in data 30 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Daniel George Darazsdi come amministratore in data 30 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Alison Murphy come segretario in data 30 ago 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Roy Douglas Smith come segretario in data 30 ago 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Adrianus Laurentius Schiebroek come amministratore in data 30 ago 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Mr Daniel George Darazsdi come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Daniel George Darazsdi come amministratore in data 01 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di David M Drillock come amministratore in data 31 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Varie Section 519 | 2 pagine | MISC | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2012 | 9 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURPHY, Alison | Segretario | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire | 214334930001 | |||||||
SCHIEBROEK, Adrianus Laurentius | Amministratore | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire | Netherlands | Dutch | Tax Manager | 214317980001 | ||||
BOWERS, Steven John | Segretario | Thornbury Cottage Chalkhill Coleshill HP7 0LY Amersham Buckinghamshire | British | 61929330004 | ||||||
LEE, Maurice Milson | Segretario | 90 Giffords Cross Road SS17 7QQ Corringham Essex | British | 115467610001 | ||||||
SMITH, Roy Douglas | Segretario | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire England | 171432740001 | |||||||
BEAUMONT, Richard John Kirby | Amministratore | 10 Milverton Terrace CV32 5BA Leamington Spa Warwickshire | British | Accountant | 98953190001 | |||||
BOWERS, Steven John | Amministratore | Warwick New Road CV32 5JG Leamington Spa Concorde House Warwickshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 176189250001 | ||||
CULNANE, Paul Alexander | Amministratore | 21 Oxhouse Court Shenley Brook End MK5 7GL Milton Keynes Buckinghamshire | Uk | British | Director | 107502650001 | ||||
DARAZSDI, Daniel George | Amministratore | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire | Usa | American | Chief Financial Officer | 195049720001 | ||||
DRILLOCK, David M | Amministratore | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire England | United States | American | Accountant | 170878740001 | ||||
GREEN, Paul Andrew | Amministratore | 2 Jubilee Villas Dassels SG11 2RW Braughing Hertfordshire | United Kingdom | British | Marketing Director | 109248560001 | ||||
HART, David John | Amministratore | 18 Farrow Gardens RM16 2EU Grays Essex | British | Sales Director | 68384420001 | |||||
HASLEHURST, Peter Joseph Kinder | Amministratore | Old Crowholt Farm Cowbrook Lane Gawsworth SK11 0JH Macclesfield Cheshire | England | British | Company Director | 39820040001 | ||||
HAWKINS, Ian Roger | Amministratore | The Old Colley Farm Coppice Lane RH2 9JE Reigate Surrey | British | Company Director | 15991450002 | |||||
HOBBS, Jeffrey Jacques | Amministratore | 1 Cedar Copse BR1 2NY Bromley Kent | British | Company Director | 3252730001 | |||||
LEE, Maurice Milson | Amministratore | 90 Giffords Cross Road SS17 7QQ Corringham Essex | British | Director | 115467610001 | |||||
LIDDLE, Matthew | Amministratore | 54 High Street MK45 5DY Flitton Bedfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 35090550001 | ||||
LONG, Peter Terence | Amministratore | 43 Kelso Close Worth RH10 7XH Crawley West Sussex | British | Operations Director | 68384400001 | |||||
MARTIN, David Barrington | Amministratore | 6 Copse Lane The Copse Hamble SO31 4QH Southampton | British | Company Director | 44386840006 | |||||
MCKNIGHT, William John | Amministratore | 75 Ashley Road KT18 5BN Epsom Surrey | British | Company Director | 6788940001 | |||||
MOSS, Andrew Brian | Amministratore | Warwick New Road CV32 5JG Leamington Spa Concorde House Warwickshire | England | British | Director | 161928410001 | ||||
PARKINSON, John | Amministratore | 7 Stourton Mews Stourton Road LS29 9BQ Ilkley West Yorkshire | British | Company Director | 10307790001 | |||||
ROBERTSON, Douglas Grant | Amministratore | Blackmore Grange Blackmore End WR8 0EE Hanley Swan Worcestershire | England | British | Director | 123487130001 | ||||
SMITH, Roy Douglas | Amministratore | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire England | Usa | Usa | Attorney | 170877010001 | ||||
SNOWDON, Clive John | Amministratore | New End Barn Spernall Lane Great Alne B49 6JD Alcester Warwickshire | United Kingdom | British | Company Director | 32242700001 | ||||
WALKER, Joan Elizabeth | Amministratore | 3 Meadow View Bicknacre CM3 4HR Chelmsford Essex | British | Company Director | 28418730001 | |||||
WALKER, John Siddall | Amministratore | The Thatched Barn Eye Road IP21 5BA Hoxne Suffolk | English | Company Director | 10306840004 | |||||
WHYTE, James Stevenson | Amministratore | 9 Palmers Croft CM2 6SR Chelmsford | British | Director | 97922850002 |
COMPSTOCK ELECTRONICS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 11 dic 2009 Consegnato il 30 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement 27TH october 1997, | Creato il 23 nov 2006 Consegnato il 29 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/10/1997 | Creato il 16 lug 2004 Consegnato il 22 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 13 feb 1996 Consegnato il 01 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Compstock house, london road, stanford le hope by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Single debenture | Creato il 17 giu 1994 Consegnato il 23 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 04 mag 1994 Consegnato il 06 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Further charge and mortgage | Creato il 22 dic 1989 Consegnato il 05 gen 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £20,000 and all other monies due or to become due from the company and/or ian robert hawkins to the chargee | |
Brevi particolari F/H compstock house, london road stanford le hope essex. Title no ex 226930. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 15 nov 1988 Consegnato il 17 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £200,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari F/H compstock house london road stanford le hope essex title no. Ex 226930. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 27 set 1988 Consegnato il 04 ott 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land & buildings k/a compstock house, lying on the north side of london road, stanford le-hope, essex title no: ex 226930. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 01 giu 1987 Consegnato il 09 giu 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Further charge and mortgage and deed of variation | Creato il 05 ott 1984 Consegnato il 10 ott 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Varies the amount secured by the mortgage dated 14TH december 1979 to £150,000 | |
Brevi particolari All that land & office building k/a compstock house london road stanford-le-hope in the county of essex with freehold title absolute under title no. EX226930 (nb: formerly k/a steadeal house). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 06 apr 1984 Consegnato il 16 apr 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over book & other debts floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts (exc those mentioned aove) uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of variation | Creato il 08 ago 1980 Consegnato il 09 ago 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Varies the amount secured by the mortgage d/d 14/12/78 to £50,000 regd 9/8/80. | |
Brevi particolari Varying terms of a mortgage d/d 14/12/78 so as to limit the sum of money charged by the mortgage to £50,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0