TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED

TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01212935
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    West Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DARLINGTON CHARTER FREIGHT SERVICES LIMITED16 mag 197516 mag 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Dettagli del segretario cambiati per Plant Nominees Limited il 11 ago 2014

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Plant Nominees Limited il 11 ago 2014

    1 pagineCH02

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Grayston Central Services Limited il 11 ago 2014

    1 pagineCH02

    Stato del capitale al 13 dic 2013

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Stato del capitale al 11 set 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Kenneth Johnson come amministratore in data 20 apr 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Cessazione della carica di Petar Cvetkovic come amministratore in data 30 ago 2009

    1 pagineTM01

    Nomina di Plant Nominees Limited come amministratore in data 29 nov 2011

    3 pagineAP02

    Cessazione della carica di Alexandra Jane Laan come segretario in data 29 nov 2011

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Paul Griffiths come amministratore in data 29 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Grayston Central Services Limited come amministratore in data 22 ago 2011

    3 pagineAP02

    Chi sono gli amministratori di TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PLANT NOMINEES LIMITED
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Segretario
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1045604
    162779680001
    LAAN, Alexandra Jane
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    Amministratore
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    United KingdomBritish89963780002
    GRAYSTON CENTRAL SERVICES LIMITED
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Amministratore
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione906194
    163144170001
    PLANT NOMINEES LIMITED
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Amministratore
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1045604
    165159470001
    BROWN, Gareth Trevor
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    Segretario
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    British15885460002
    COTTERILL, Mark Bernard
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    British9541300002
    JOHNSON, Kenneth
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    Segretario
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    British56853980002
    LAAN, Alexandra Jane
    Hartington Close
    Reigate Hill
    RH2 9NL Reigate
    14
    Surrey
    Segretario
    Hartington Close
    Reigate Hill
    RH2 9NL Reigate
    14
    Surrey
    British89963780002
    MITCHELL, James Keith
    Castle Cob
    Kingswood
    WA6 6JJ Warrington
    Cheshire
    Segretario
    Castle Cob
    Kingswood
    WA6 6JJ Warrington
    Cheshire
    British44040160001
    BROOM, Keith
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    Amministratore
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    British42112330008
    COOKE, Michael Andrew
    Somerley Middle Drive
    TN22 2HG Maresfield Park
    East Sussex
    Amministratore
    Somerley Middle Drive
    TN22 2HG Maresfield Park
    East Sussex
    British58733830001
    COTTERILL, Mark Bernard
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish9541300002
    CVETKOVIC, Petar
    Target Express House
    Woodlands Park, Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Amministratore
    Target Express House
    Woodlands Park, Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    British59602020005
    CVETKOVIK, Petar
    Brookledge Lane
    SK10 4JU Adlington
    Highlands
    Cheshire
    Amministratore
    Brookledge Lane
    SK10 4JU Adlington
    Highlands
    Cheshire
    British129068030001
    GODMAN, Stuart
    Appletree Road
    OX17 1LW Chipping Warden
    18
    Oxfordshire
    Amministratore
    Appletree Road
    OX17 1LW Chipping Warden
    18
    Oxfordshire
    UkBritish132540700001
    GRIFFITHS, Paul
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    Amministratore
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    EnglandBritish11329830003
    GRIFFITHS, Raymond Gordon
    248 Burnley Road
    Weir
    OL13 8QR Bacup
    Lancashire
    Amministratore
    248 Burnley Road
    Weir
    OL13 8QR Bacup
    Lancashire
    British5115700001
    HARRISON, Michael Glyn
    Flat 1
    70 Tottenham Road
    N1 4ER London
    Amministratore
    Flat 1
    70 Tottenham Road
    N1 4ER London
    British110257110001
    JENKINS, Brian Michael
    Oakenshaw House
    Oakenshaw View, Whitworth
    OL12 8SP Rochdale
    Amministratore
    Oakenshaw House
    Oakenshaw View, Whitworth
    OL12 8SP Rochdale
    British56957130004
    JOHNSON, Kenneth
    29 Patch Croft Road Peel Hall
    Wythenshawe
    M22 5JR Manchester
    Amministratore
    29 Patch Croft Road Peel Hall
    Wythenshawe
    M22 5JR Manchester
    British56853980001
    KENYON, Martin
    44 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    44 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    EnglandUnited Kingdom58648840001
    MITCHELL, James Keith
    Castle Cob
    Kingswood
    WA6 6JJ Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Castle Cob
    Kingswood
    WA6 6JJ Warrington
    Cheshire
    British44040160001
    MURRAY, Paul
    High Point
    Tirley Lane Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    High Point
    Tirley Lane Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    British56957060002
    NEUMARK, Peter Stephen
    Netherdale Carriage Drive
    Frodsham
    WA6 6EB Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Netherdale Carriage Drive
    Frodsham
    WA6 6EB Warrington
    Cheshire
    British78079880001
    SHARP, Iain George
    Glan Yr Afon Hall
    Llanferres
    CH7 5SB Mold
    Clwyd
    Amministratore
    Glan Yr Afon Hall
    Llanferres
    CH7 5SB Mold
    Clwyd
    British53447160001
    TYLER, Colin James
    7 Green Park
    HP16 0PZ Prestwood
    Buckinghamshire
    Amministratore
    7 Green Park
    HP16 0PZ Prestwood
    Buckinghamshire
    EnglandBritish53150030001
    WILSON, David John
    4 Eldon Avenue
    Shirley
    CR0 8SD Croydon
    Surrey
    Amministratore
    4 Eldon Avenue
    Shirley
    CR0 8SD Croydon
    Surrey
    British110257220001

    TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 05 set 2006
    Consegnato il 15 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h premises k/a land at merrivale road okehampton devon (also k/a land at exeter road industrial estate okehampton devon) t/n DN412848. The l/h premises k/a barley castle trading estate barley castle lane appleton warrington cheshire t/n CH340963 (also k/a land lying to the south-east of lyncastle road appleton) the l/h premises k/a 22 eastbury road the london industrial park beckton london t/n EGL300427. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Corporate Finance Bank Sas, London Branch
    Transazioni
    • 15 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture between target express holdings limited, target express limited, target express parcels limited, target international logistics limited and mizuho corporate bank LTD., As security agent for itself and each of the secured parties
    Creato il 11 ott 2002
    Consegnato il 25 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank LTD., as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 25 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture between target express holdings limited,target express limited,target express parcels limited,target international logistics limited (and each company which becomes a party to the debenture by executing a deed of accession) and the fuji bank,limited as agent and trustee for itself and each of the lenders
    Creato il 18 feb 2000
    Consegnato il 03 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) and the mezzanine finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Fuji Bank,Limited
    Transazioni
    • 03 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture between target international logistics limited, target express parcels limited and broomco (1437) limited (together the chargors) and the fuji bank limited as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (the security agent)
    Creato il 02 feb 1998
    Consegnato il 11 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) and the mezzanine finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Fuji Bank Limited
    Transazioni
    • 11 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 set 1989
    Consegnato il 03 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit B356 hornvale avenue, aycliffe industrial estate, newton aycliffe, sedge field, county durham. Title nos du 129787 and du 137150.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 feb 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc ma). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0