HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED

HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01220754
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    H.L. FOODS LIMITED01 feb 199101 feb 1991
    HILLSDOWN LIMITED25 lug 197525 lug 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Cessazione della carica di Jim Hepburn come amministratore in data 05 apr 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Nicholas Wilbraham come amministratore in data 05 apr 2015

    2 pagineAP01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    GAZ1(A)

    Nomina di Mr Duncan Neil Leggett come amministratore in data 12 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Emmett Mcevoy come amministratore in data 12 gen 2015

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 012207540019 in pieno

    4 pagineMR04

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 15 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 set 2014

    Stato del capitale al 30 set 2014

    • Capitale: GBP 21,822,100
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2014 al 31 mar 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 012207540019

    188 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 set 2013

    Stato del capitale al 16 set 2013

    • Capitale: GBP 21,822,100
    SH01

    Chi sono gli amministratori di HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    LEGGETT, Duncan Neil
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish194179970001
    MCDONALD, Andrew John
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Segretario
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    HUNT, Barry Thomas
    Barmadel Gorefield Road
    Leverington
    PE13 5BB Wisbech
    Cambridgeshire
    England
    Segretario
    Barmadel Gorefield Road
    Leverington
    PE13 5BB Wisbech
    Cambridgeshire
    England
    British142070001
    MACKEE, Stephen Patrick
    101 Gayton Road
    PE30 4EW Kings Lynn
    Norfolk
    Segretario
    101 Gayton Road
    PE30 4EW Kings Lynn
    Norfolk
    British29126720002
    BOWEN, Charles John
    Isington Mill
    GU34 4PW Alton
    Hants
    Amministratore
    Isington Mill
    GU34 4PW Alton
    Hants
    British801170002
    CAMPBELL, Rosalind Ilona
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    British58191970001
    CLARE, Nigel John Richard
    The Tower House
    Danesfield
    SL7 2EU Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Tower House
    Danesfield
    SL7 2EU Marlow
    Buckinghamshire
    British79912700001
    DE BAKKER, Cornelis Gerardus
    Sparrenlaan 15
    3735 Mx
    FOREIGN Bosch En Duin
    Netherlands
    Amministratore
    Sparrenlaan 15
    3735 Mx
    FOREIGN Bosch En Duin
    Netherlands
    Dutch38672120002
    GARDENER, Nigel William
    4 Sudeley Drive
    South Cerney
    GL7 5XN Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    4 Sudeley Drive
    South Cerney
    GL7 5XN Cirencester
    Gloucestershire
    British52911930001
    HEPBURN, Jim
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    ScotlandScottish162125080001
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Amministratore
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    HUNT, Barry Thomas
    Barmadel Gorefield Road
    Leverington
    PE13 5BB Wisbech
    Cambridgeshire
    England
    Amministratore
    Barmadel Gorefield Road
    Leverington
    PE13 5BB Wisbech
    Cambridgeshire
    England
    British142070001
    LAND, Sian Louise
    11 Clover Drive
    Pickmere
    WA16 0WF Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    11 Clover Drive
    Pickmere
    WA16 0WF Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish86278210001
    LAPEYRE, Bernard
    3 Chemin Neuf
    69570 Dardilly
    Amministratore
    3 Chemin Neuf
    69570 Dardilly
    French40996690001
    LEACH, Paul Alan
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136797430001
    LEACH, Paul Alan
    20 Malvern Road
    SL6 7RH Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    20 Malvern Road
    SL6 7RH Maidenhead
    Berkshire
    British60788330001
    LILLINGTON, Keith William
    The Old Bowling Green
    Broad Lane Moulton Chapel
    PE12 6PN Spalding
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Old Bowling Green
    Broad Lane Moulton Chapel
    PE12 6PN Spalding
    Lincolnshire
    British803140001
    LYONS, Colim Fionbar
    14 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin
    Amministratore
    14 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin
    British32152010001
    MACKEE, Stephen Patrick
    101 Gayton Road
    PE30 4EW Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    101 Gayton Road
    PE30 4EW Kings Lynn
    Norfolk
    United KingdomBritish29126720002
    MCEVOY, Emmett
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrish168590540001
    NICHOLS, John Ellis
    353 Hills Road
    CB2 2QT Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    353 Hills Road
    CB2 2QT Cambridge
    Cambridgeshire
    British7351450001
    O'NEILL, Anthony Christopher
    1 Ballyhannon Lane
    Portadown
    BT63 5YF County Armagh
    Northern Ireland
    Amministratore
    1 Ballyhannon Lane
    Portadown
    BT63 5YF County Armagh
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish146393340001
    ORCHARD, Stephen William
    The Orchards
    Meadow Lane Houghton
    PE17 2BP Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Orchards
    Meadow Lane Houghton
    PE17 2BP Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish36964770001
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish87359710001
    RITCHIE, Alexander George Malcolm
    Orchard House 29 Burwell Road
    Reach
    CB5 0JH Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Orchard House 29 Burwell Road
    Reach
    CB5 0JH Cambridge
    Cambridgeshire
    British144538120001
    ROSEN, Andrew Scott
    60 Karens Lane
    NJ 07632 Englewood Cliffs
    Usa
    Amministratore
    60 Karens Lane
    NJ 07632 Englewood Cliffs
    Usa
    American64268220002
    SCHOFIELD, Robert John
    Hunterswood
    Saint Johns Road
    HP15 7QS Hazlemere
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hunterswood
    Saint Johns Road
    HP15 7QS Hazlemere
    Buckinghamshire
    British80018490001
    SIMPSON, Edward Thomas Stephen
    Tilson House 64 Station Road
    Long Sutton
    PE12 9BS Spalding
    Lincolnshire
    Amministratore
    Tilson House 64 Station Road
    Long Sutton
    PE12 9BS Spalding
    Lincolnshire
    British7350120001
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147725160001
    SOLOMON, Harry, Sir
    7 Inverforth House
    North End Way
    NW3 7EU London
    Amministratore
    7 Inverforth House
    North End Way
    NW3 7EU London
    United KingdomBritish59789810004
    THOMAS, Paul
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    British29218800002
    TYLEY, Gwynfor Paul
    12 Prospect Road
    AL1 2AX St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    12 Prospect Road
    AL1 2AX St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish66169120001

    HILLSDOWN AMBIENT FOODS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 apr 2014
    Consegnato il 17 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Agent and Trustee for the Senior Secured Creditors)
    Transazioni
    • 17 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An english law security agreement
    Creato il 30 mar 2012
    Consegnato il 04 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all rights in respect of key brand ipr including any interest by way of licence in any such key brand ipr by way of first legal mortgage all the shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Expanded Secured Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 30 mar 2012
    Consegnato il 04 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the additional shares. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC, as Agent and Trustee for the Expanded Secured Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 27 mar 2009
    Consegnato il 03 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The real property all buildings fixtures and fittings (for details of properties charged please refer to the form 395) all the shares owned and first floating charge against all assets not at any time otherwise effectively mortgage charged or assigned under the deed see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 12 gen 2009
    Consegnato il 22 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge the real property land lying to the south of bridge road, long sutton and land lying to the south of bridge road, long sutton t/n's LL294571 and LL294436 all buildings fixtures and fittings plant and machinery the benefit of any covenants intellectual property a first floating charge all its assets. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group debenture
    Creato il 28 feb 2008
    Consegnato il 10 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and all property and assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 10 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group debenture
    Creato il 16 mar 2007
    Consegnato il 03 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge its undertaking and allits property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, including any of its property and as. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security over shares
    Creato il 16 mar 2007
    Consegnato il 03 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares owned and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group debenture
    Creato il 06 giu 2005
    Consegnato il 13 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, including any of its property and assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group debenture
    Creato il 16 ago 2004
    Consegnato il 27 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property at glenthorn farm whittlesey road march cambridge t/no CB231846, f/h land and buildings on the east and west sides of marriott way melton constable t/nos NK243931 & NK239582, f/h land on the north west side of fenton way slade end chatteris and land lying to the north east of A142 chatteris and land lying to the east of the A141 chatteris t/nos CB207119, CB198960 and CB198959. For details of further properties charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 27 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group debenture
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 15 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 15 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of pledge
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 09 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The existing shares the further shares and all other rights assets or property (including dividends and all other distributions and bonus or scrip rights). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transazioni
    • 09 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security dated 07/10/99 which was presented for registration in scotland on 13/10/99
    Creato il 13 ott 1999
    Consegnato il 19 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and hl foods limited to the chargee under the finance documents
    Brevi particolari
    Property k/a that area or piece of ground lying to the south of the loch of forfar in the royal burgh and parish of forfar and county of angus extending to 4.77 acres or thereby but excepting therefrom that plot or area of ground extending to 0.005 acres and that area or piece of ground extending to 2,725 square metres at orchardbank industrial estate forfar in the county of angus.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited as Agent and Security Agent for and on Behalf of Thefinance Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 19 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 10 ago 1999
    Consegnato il 26 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or each obligor company (as defined) to the chargee and/or the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuantto the Facilities Agreement
    Transazioni
    • 26 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of pledge
    Creato il 10 ago 1999
    Consegnato il 24 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents and/or any deed or documents supplemental thereto
    Brevi particolari
    Pledges the existing shares or further shares and any other secured assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited
    Transazioni
    • 24 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 24 ago 1981
    Consegnato il 28 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond
    Brevi particolari
    1. 4. 77 acres and 0.817 acres part of orchard bank ind.site forfar. Angus 2. 55 glamis rd, forfar. Angus 3. briar cottage glamis rd forfar angus.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 26 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 ago 1981
    Consegnato il 11 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lockwood canning factory, long sutton, lincs. About 4 acres, 1936 sq. Yds at sutton bridge, lincs. Adderley house, long sutton, lincs. Land & buildings at bull lane, long sutton, lincs.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 ago 1981
    Consegnato il 11 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 4 acres adjoining canning factory at long sutton, lincs.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 28 lug 1981
    Consegnato il 11 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 5 acres adjoining canning factory at long sutton, lincs.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0