FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED
Panoramica
Nome della società | FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01222422 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?
- fabbricazione di altri prodotti in plastica (22290) / Industrie manifatturiere
Dove si trova FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 1 Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley County Durham England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 21 mar 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione di Stuart Clive Ward come persona con controllo significativo il 13 dic 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Clive Ward come amministratore in data 13 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin David Parker il 01 apr 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Louis-Marie Allain il 01 apr 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Fearby Road Masham Ripon North Yorkshire HG4 4ES a 1 Greencroft Industrial Park Stanley County Durham DH9 7YA in data 19 nov 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin David Parker come amministratore in data 15 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAIN, Louis-Marie | Segretario | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | British | 173519410001 | ||||||
PARKER, Kevin David | Amministratore | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | England | British | Finance Director | 176767670001 | ||||
HALL, Stephen | Segretario | Whitcliffe Lane HG4 2JL Ripon 14 North Yorkshire | British | Accountant | 8374520006 | |||||
HATTERSLEY, Jane Margaret | Segretario | The Bell House Southtown TQ6 9BU Dartmouth Devon | British | 25206800002 | ||||||
TOBIN, John | Segretario | High Hoyland Lane High Hoyland S75 4AY Barnsley Friezland House South Yorkshire | 146592720001 | |||||||
TOBIN, John | Segretario | High Hoyland Lane High Hoyland S75 4AY Barnsley Friezland House South Yorkshire | 146638930001 | |||||||
ALLEN, Alice Caroline | Amministratore | Spring Croft Sibbertoft LE16 9UA Market Harborough Leicestershire | British | Scientist | 5617810002 | |||||
COWAN, Andrew Thomas Douglas | Amministratore | 17 Thatchmeadow Drive LE16 7XH Market Harborough Leicestershire | England | British | Co Director | 119734740001 | ||||
HADWIN, Ian Rex | Amministratore | Fearby Road Masham HG4 4ES Ripon North Yorkshire | New Zealand | New Zealander | Director | 200837880001 | ||||
HALL, Stephen | Amministratore | Whitcliffe Lane HG4 2JL Ripon 14 North Yorkshire | England | British | Accountant | 8374520006 | ||||
HATTERSLEY, Bruce Sean, Dr | Amministratore | 3 Golf Lane Church Brampton NN6 8AY Northampton | British | Scientist | 84370340001 | |||||
HATTERSLEY, Robert Merlin | Amministratore | The Bell House Southtown TQ6 9BU Dartmouth Devon | British | General Manager | 34435280002 | |||||
MAXWELL-SCOTT, Ian | Amministratore | Pondtail House West Hill Bank RH8 9JD Oxted Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 34876790001 | ||||
MUIR, Gregory John | Amministratore | Fearby Road Masham HG4 4ES Ripon North Yorkshire | New Zealand | New Zealander | Director | 153595780002 | ||||
TOBIN, John | Amministratore | High Hoyland Lane High Hoyland S75 4AY Barnsley Friezland House South Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 2317870002 | ||||
WARD, Stuart Clive | Amministratore | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | United Kingdom | British | Managing Director | 176383190001 | ||||
WILDRIDGE, Stephen Michael | Amministratore | Fearby Road Masham HG4 4ES Ripon North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 64854610001 | ||||
WILLS HILL MARQUESS OF DOWNSHIRE, Arthur Francis Nicholas, Lord | Amministratore | Clifton Castle Clifton HG4 4AB Ripon North Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 60546920001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mr Stuart Clive Ward | 06 apr 2016 | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
Mr Kevin David Parker | 06 apr 2016 | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
Mr Louis-Marie Allain | 06 apr 2016 | Greencroft Industrial Park DH9 7YA Stanley 1 County Durham England | No |
Nazionalità: French Paese di residenza: France | |||
Natura del controllo
|
FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 17 set 2010 Consegnato il 29 set 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 14 gen 2008 Consegnato il 18 gen 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 01 giu 2006 Consegnato il 20 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 28 giu 2001 Consegnato il 06 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monie due or to become due from the company and or ritchey tagg limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 22 lug 1993 Consegnato il 03 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0