FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED

FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01222422
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in plastica (22290) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    County Durham
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 mar 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione di Stuart Clive Ward come persona con controllo significativo il 13 dic 2017

    1 paginePSC07

    Cessazione della carica di Stuart Clive Ward come amministratore in data 13 dic 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    26 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 apr 2016

    Stato del capitale al 01 apr 2016

    • Capitale: GBP 1,275
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin David Parker il 01 apr 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Louis-Marie Allain il 01 apr 2016

    1 pagineCH03

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Indirizzo della sede legale modificato da Fearby Road Masham Ripon North Yorkshire HG4 4ES a 1 Greencroft Industrial Park Stanley County Durham DH9 7YA in data 19 nov 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    25 pagineAA

    Nomina di Mr Kevin David Parker come amministratore in data 15 apr 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2015

    Stato del capitale al 08 apr 2015

    • Capitale: GBP 1,275
    SH01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    26 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2014

    Stato del capitale al 31 mar 2014

    • Capitale: GBP 1,275
    SH01

    Chi sono gli amministratori di FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALLAIN, Louis-Marie
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    Segretario
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    British173519410001
    PARKER, Kevin David
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    Amministratore
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    EnglandBritishFinance Director176767670001
    HALL, Stephen
    Whitcliffe Lane
    HG4 2JL Ripon
    14
    North Yorkshire
    Segretario
    Whitcliffe Lane
    HG4 2JL Ripon
    14
    North Yorkshire
    BritishAccountant8374520006
    HATTERSLEY, Jane Margaret
    The Bell House
    Southtown
    TQ6 9BU Dartmouth
    Devon
    Segretario
    The Bell House
    Southtown
    TQ6 9BU Dartmouth
    Devon
    British25206800002
    TOBIN, John
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    Segretario
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    146592720001
    TOBIN, John
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    Segretario
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    146638930001
    ALLEN, Alice Caroline
    Spring Croft
    Sibbertoft
    LE16 9UA Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Spring Croft
    Sibbertoft
    LE16 9UA Market Harborough
    Leicestershire
    BritishScientist5617810002
    COWAN, Andrew Thomas Douglas
    17 Thatchmeadow Drive
    LE16 7XH Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    17 Thatchmeadow Drive
    LE16 7XH Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritishCo Director119734740001
    HADWIN, Ian Rex
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    New ZealandNew ZealanderDirector200837880001
    HALL, Stephen
    Whitcliffe Lane
    HG4 2JL Ripon
    14
    North Yorkshire
    Amministratore
    Whitcliffe Lane
    HG4 2JL Ripon
    14
    North Yorkshire
    EnglandBritishAccountant8374520006
    HATTERSLEY, Bruce Sean, Dr
    3 Golf Lane
    Church Brampton
    NN6 8AY Northampton
    Amministratore
    3 Golf Lane
    Church Brampton
    NN6 8AY Northampton
    BritishScientist84370340001
    HATTERSLEY, Robert Merlin
    The Bell House
    Southtown
    TQ6 9BU Dartmouth
    Devon
    Amministratore
    The Bell House
    Southtown
    TQ6 9BU Dartmouth
    Devon
    BritishGeneral Manager34435280002
    MAXWELL-SCOTT, Ian
    Pondtail House
    West Hill Bank
    RH8 9JD Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Pondtail House
    West Hill Bank
    RH8 9JD Oxted
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director34876790001
    MUIR, Gregory John
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    New ZealandNew ZealanderDirector153595780002
    TOBIN, John
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    Amministratore
    High Hoyland Lane
    High Hoyland
    S75 4AY Barnsley
    Friezland House
    South Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant2317870002
    WARD, Stuart Clive
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    Amministratore
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    United KingdomBritishManaging Director176383190001
    WILDRIDGE, Stephen Michael
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Fearby Road
    Masham
    HG4 4ES Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director64854610001
    WILLS HILL MARQUESS OF DOWNSHIRE, Arthur Francis Nicholas, Lord
    Clifton Castle
    Clifton
    HG4 4AB Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Clifton Castle
    Clifton
    HG4 4AB Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector60546920001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Stuart Clive Ward
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    06 apr 2016
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr Kevin David Parker
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    06 apr 2016
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr Louis-Marie Allain
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    06 apr 2016
    Greencroft Industrial Park
    DH9 7YA Stanley
    1
    County Durham
    England
    No
    Nazionalità: French
    Paese di residenza: France
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    FEARING INTERNATIONAL (STOCK-AIDS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 17 set 2010
    Consegnato il 29 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Asb Bank Limited
    Transazioni
    • 29 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 gen 2008
    Consegnato il 18 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 giu 2006
    Consegnato il 20 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 giu 2001
    Consegnato il 06 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monie due or to become due from the company and or ritchey tagg limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 lug 1993
    Consegnato il 03 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0