OVAL OF BATH LIMITED

OVAL OF BATH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOVAL OF BATH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01224006
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OVAL OF BATH LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Vendita al dettaglio di autovetture usate (45112) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Manutenzione e riparazione di autoveicoli (45200) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio al dettaglio di parti e accessori per autoveicoli (45320) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova OVAL OF BATH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    16 Lower Road
    Churchfields
    SP2 7QD Salisbury
    Wiltshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OVAL OF BATH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WINDSOR GARAGE (BATH) LIMITED26 ago 197526 ago 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di OVAL OF BATH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per OVAL OF BATH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di John Richard Cook come amministratore in data 01 mar 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Christopher Walsh come amministratore in data 01 mar 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard Luis Neulaender come amministratore in data 01 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Richard Cook come segretario in data 01 mar 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 gen 2016

    Stato del capitale al 04 gen 2016

    • Capitale: GBP 31,166
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Nomina di Mr John Richard Cook come segretario in data 07 lug 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Kevin Ian Makepeace come segretario in data 07 lug 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 feb 2015

    Stato del capitale al 13 feb 2015

    • Capitale: GBP 31,166
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 gen 2014

    Stato del capitale al 13 gen 2014

    • Capitale: GBP 31,166
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di OVAL OF BATH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NEULAENDER, Richard Luis
    Lower Road
    Churchfields
    SP2 7QD Salisbury
    16
    Wiltshire
    Amministratore
    Lower Road
    Churchfields
    SP2 7QD Salisbury
    16
    Wiltshire
    EnglandBritish117461400002
    WALSH, John Christopher
    Lower Road
    Churchfields
    SP2 7QD Salisbury
    16
    Wiltshire
    Amministratore
    Lower Road
    Churchfields
    SP2 7QD Salisbury
    16
    Wiltshire
    EnglandBritish76089450002
    COOK, John Richard
    Lower Road
    Churchfields
    SP2 7QD Salisbury
    16
    Wiltshire
    Segretario
    Lower Road
    Churchfields
    SP2 7QD Salisbury
    16
    Wiltshire
    199167710001
    MAKEPEACE, Kevin Ian
    Lower Road
    Churchfields
    SP2 7QD Salisbury
    16
    Wiltshire
    England
    Segretario
    Lower Road
    Churchfields
    SP2 7QD Salisbury
    16
    Wiltshire
    England
    British105075150001
    MCLAREN, Ian George
    Inverallen
    Fyfield Road Weyhill
    SP11 8DJ Andover
    Hampshire
    Segretario
    Inverallen
    Fyfield Road Weyhill
    SP11 8DJ Andover
    Hampshire
    British29799910001
    QUIGGIN, Roger Frederick
    Durham House 5 Hamilton Road
    Lansdown
    BA1 5SB Bath
    Avon
    Segretario
    Durham House 5 Hamilton Road
    Lansdown
    BA1 5SB Bath
    Avon
    British14173410001
    ROBERTS, Charles Thomas
    28 Church Street
    Southwick
    BA14 9RA Trowbridge
    Wiltshire
    Segretario
    28 Church Street
    Southwick
    BA14 9RA Trowbridge
    Wiltshire
    British38678820001
    COOK, John Richard
    Lower Road
    Churchfields
    SP2 7QD Salisbury
    16
    Wiltshire
    England
    Amministratore
    Lower Road
    Churchfields
    SP2 7QD Salisbury
    16
    Wiltshire
    England
    EnglandBritish37813270005
    GARRITY, David John
    Elmar House
    34a Hilperton Road
    BA14 7JD Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    Elmar House
    34a Hilperton Road
    BA14 7JD Trowbridge
    Wiltshire
    British14173420001
    QUIGGIN, Roger Frederick
    Stoneleigh Lodge
    Lansdown Road
    BA1 5TJ Bath
    Avon
    Amministratore
    Stoneleigh Lodge
    Lansdown Road
    BA1 5TJ Bath
    Avon
    British14173410002
    ROBERTS, Charles Thomas
    28 Church Street
    Southwick
    BA14 9RA Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    28 Church Street
    Southwick
    BA14 9RA Trowbridge
    Wiltshire
    United KingdomBritish38678820001

    Chi sono le persone con controllo significativo di OVAL OF BATH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Heitage Automotive Limited
    Lower Road
    SP2 7QD Salisbury
    16
    England
    06 apr 2016
    Lower Road
    SP2 7QD Salisbury
    16
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione03142712
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    OVAL OF BATH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 21 mar 2003
    Consegnato il 26 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings at upper bristol road bath BA1 3AS t/n st 199022.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mar 2003
    Consegnato il 21 mar 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south side of upper bristol road bath t/no: ST199022. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited, Peugeot Motor Company PLC or Psa Finance PLC
    Transazioni
    • 21 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 giu 2000
    Consegnato il 16 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee peugeot motor company PLC or psa finance PLC on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on south side of upper bristol road bath BA1 3AS t/no.ST182878 and all buildings fixtures fixed plant and machinery fixed charge over all moneys payable under present and future contracts or policies of insurance and the benefit of an option contained in a lease dated 22.12.99.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 16 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1999
    Consegnato il 19 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The oval service station upper bristol road bath county of bath & north east somerset t/no: ST174953.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Used vehicle charge
    Creato il 20 dic 1993
    Consegnato il 21 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its interest (if any) in any used and unused vehicles from time to time (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 21 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 nov 1993
    Consegnato il 27 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 27 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 feb 1992
    Consegnato il 25 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Windsor service station, upper bristol road, bath, avon title number: AV1864.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 feb 1992
    Consegnato il 25 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures- see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 dic 1990
    Consegnato il 02 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 350,000 and all othre monies due or to become due from the company to the chargee, under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    L/H-windsor garage upper bristol road bath avon BA1 3AS.
    Persone aventi diritto
    • Texaco Limited
    Transazioni
    • 02 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General charge mortgage
    Creato il 24 dic 1990
    Consegnato il 02 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H windsor garage upper bristol road bath avon BA1 3AS.
    Persone aventi diritto
    • Texaco Limited
    Transazioni
    • 02 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 09 ott 1990
    Consegnato il 15 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a consignment agreement dated 9/10/90
    Brevi particolari
    All the chargors interest (if any) in any vehicle delivered to it under the terms of the said assignment agreement and any monies received therefor.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 15 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 apr 1990
    Consegnato il 26 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the l/h property known as or being windsor windsor service station bristol bath avon including the entirety of the property comprised in title number av 1864 together with all buildings and fixtures thereon and goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 1992Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 12 apr 1990
    Consegnato il 26 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 1992Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 12 apr 1990
    Consegnato il 26 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property known as or being a garage site upper bristol road bath avon including the entirety of the property comprised in a lease dated 23/11/82 between bath city council (1) windsor garage (bath) LTD together with all buildings thereonand goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 24 gen 1986
    Consegnato il 27 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a consignment agreement dated 24-1-86 on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the chargor's interest (if any) in any vehicle delivered to it the the terms of the said consignment agreement and any monies received therefor.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 27 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 03 apr 1985
    Consegnato il 04 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 102,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H windsor service station, upper bristol road, bath avon with the goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Esso Petroleum Company Limited
    Transazioni
    • 04 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 23 feb 1984
    Consegnato il 24 feb 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over all the company's present and future stock of new motor vehicles & all the proceeds of sale of such motor vehicles.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 24 feb 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 25 gen 1980
    Consegnato il 01 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Windsor service station, upper bristol road, bath avon, title no AV1864.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0