BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED

BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01226552
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLAKES HAULAGE LIMITED16 set 197516 set 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 nov 2013

    Stato del capitale al 27 nov 2013

    • Capitale: GBP 601,984
    SH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 18 giu 2013

    • Capitale: GBP 601,984
    4 pagineSH01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 giu 2013

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jan Egtved Pedersen il 06 dic 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Lauritzen il 06 dic 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Tanjot Soar il 06 dic 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    Chi sono gli amministratori di BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SOAR, Tanjot
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Segretario
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    British123350000001
    LAURITZEN, Peter
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    EnglandDanish123354600001
    PEDERSEN, Jan Egtved
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    EnglandDanish123347470001
    BLAKE, Michael James
    3 Arthur Road
    CV37 6SJ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    3 Arthur Road
    CV37 6SJ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British59309560001
    BLAKE, Simon Charles
    19 Albany Road
    CV37 6PG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    19 Albany Road
    CV37 6PG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British45144840001
    MORTIMER, Robert Eric
    173 Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    173 Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British20909910001
    PRICE, John Philip
    20 Rossmore Court
    Park Road
    NW1 6XX London
    Segretario
    20 Rossmore Court
    Park Road
    NW1 6XX London
    British51592560002
    BLAKE, Geoffrey Donald
    Nelson House Banbury Road
    Ettington
    CV37 7SN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Nelson House Banbury Road
    Ettington
    CV37 7SN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British20972610003
    BLAKE, Mary
    The Garden House
    Edstone
    B95 6DH Wootton Wawen
    Solihull West Midlands
    Amministratore
    The Garden House
    Edstone
    B95 6DH Wootton Wawen
    Solihull West Midlands
    British20909950001
    BLAKE, Norman Charles
    The Garden House
    Edstone
    B95 6DH Wootton Wawen
    Solihull West Midlands
    Amministratore
    The Garden House
    Edstone
    B95 6DH Wootton Wawen
    Solihull West Midlands
    British20972620001
    BLAKE, Patricia Margaret
    Nelson House 9 Banbury Road
    Ettington
    CV37 7SN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Nelson House 9 Banbury Road
    Ettington
    CV37 7SN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British20909940002
    BLAKE, Simon Charles
    The Hayloft
    Manor Barn Abberton
    Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    The Hayloft
    Manor Barn Abberton
    Pershore
    Worcestershire
    British45144840003
    BOWN, Simon Edgar
    Highfield Court Highfield Park
    Creaton
    NN6 8NT Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Highfield Court Highfield Park
    Creaton
    NN6 8NT Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish59309710001
    CLARK, Stephen John
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    British49702240002
    GILBERT, Martin James
    10 Knowle Green
    S17 3AP Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    10 Knowle Green
    S17 3AP Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish65655390002
    HODGE, Jeremy Spencer Carlton
    Highbury Bank Cottage
    Berkswell Road
    CV7 7LB Meriden
    West Midlands
    Amministratore
    Highbury Bank Cottage
    Berkswell Road
    CV7 7LB Meriden
    West Midlands
    British53503460001
    MACAULAY, Stephen William
    309 Luton Road
    AL5 3LW Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    309 Luton Road
    AL5 3LW Harpenden
    Hertfordshire
    British64938250001
    MORTIMER, Robert Eric
    173 Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    173 Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish20909910001
    MURPHY, Simon Alexander
    Cocksparrow Hall Coleshill Road
    Maxstoke
    B46 2QE Birmingham
    Amministratore
    Cocksparrow Hall Coleshill Road
    Maxstoke
    B46 2QE Birmingham
    United KingdomBritish24085730002
    PEET, Nigel David
    49 Heworth Village
    YO31 1AE York
    Amministratore
    49 Heworth Village
    YO31 1AE York
    United KingdomBritish26623160002
    SMITH, Timothy John
    Swanland Lodge
    West End, Swanland
    HU14 3PE Hull
    East Yorkshire
    Amministratore
    Swanland Lodge
    West End, Swanland
    HU14 3PE Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritish84729640001
    WHITFIELD, Paul
    Manor Farm
    Brampton
    LN1 2EG Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    Manor Farm
    Brampton
    LN1 2EG Lincoln
    Lincolnshire
    British89057170001
    WILKINS, Timothy Richard
    10 Croxall Drive
    Shustoke Coleshill
    B46 2BH Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    10 Croxall Drive
    Shustoke Coleshill
    B46 2BH Birmingham
    West Midlands
    British56023420001
    WRIGHT, Peter Brian
    3 The Rowans
    Harvington
    WR11 5SX Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    3 The Rowans
    Harvington
    WR11 5SX Evesham
    Worcestershire
    British20909920001
    YEOMANS, Richard David
    Sandwood Curlew Drive
    West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    Amministratore
    Sandwood Curlew Drive
    West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    British35983360002

    BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattel mortgage supplemental to a mortgage debenture dated 8 july 1997 issued by the company
    Creato il 21 apr 1999
    Consegnato il 07 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assignment of the items listed below (the equipment) including any part or parts thereof and all additional alterations and accessories replacements and renewals of component parts thereto together with the benefit of all obligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the equipment and all other obligations and warranties given by any other party in respect of the equipment to or in favour of the company and without prejudice to the generality of the foregoing the benefit of all maintenance agreements entered into between the company and any such third party; items: trailer no. T126, trailer type - norfrig thermoking fridge unit sbii (see continuation sheet to form 395 for full details). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 nov 1998
    Consegnato il 30 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1210 europa boulevard gemini business park warrington cheshire t/no.CH343012. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 25TH november 1998
    Creato il 29 ott 1998
    Consegnato il 09 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole the subjects on the south south east side of main street plains by airdrie t/no: LAN72995.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 21 august 1998 and
    Creato il 12 ago 1998
    Consegnato il 07 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Subject lying on the south side of mossburn avenue harthill t/n LAN98408.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 lug 1997
    Consegnato il 16 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as abbey mills alcester heath alcester warwickshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 lug 1997
    Consegnato il 14 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 giu 1991
    Consegnato il 25 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a "chudleigh", birmingham road, kings coughton, alcester, warwickshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 25 apr 1990
    Consegnato il 02 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 09 mar 1987
    Consegnato il 17 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H abbey mills alcester warwickshire and assigns the goodwill of the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 16 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 mar 2014Data di scioglimento
    19 giu 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0