FOUR COUNTIES NEWSPAPERS LIMITED

FOUR COUNTIES NEWSPAPERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOUR COUNTIES NEWSPAPERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01229102
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOUR COUNTIES NEWSPAPERS LIMITED?

    • Edizione di giornali (58130) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova FOUR COUNTIES NEWSPAPERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unex House - Suite B
    Bourges Boulevard
    PE1 1NG Peterborough
    Cambridgeshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FOUR COUNTIES NEWSPAPERS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WILLIAMS-ROPER PUBLICATIONS (U.K.) LIMITED08 ott 197508 ott 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOUR COUNTIES NEWSPAPERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FOUR COUNTIES NEWSPAPERS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FOUR COUNTIES NEWSPAPERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 lug 2015

    Stato del capitale al 16 lug 2015

    • Capitale: GBP 16,560
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2013

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John King il 01 lug 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Peter Mccall il 01 lug 2014

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ashley Gilroy Mark Highfield il 01 lug 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Johnston Publishing Ltd Oundle Road Woodston Peterborough PE2 9QR a Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG in data 24 lug 2014

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 16 lug 2013

    SH01

    Nomina di Mr David John King come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Grant Murray come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Daniel Cammiade come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di John Fry come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2011

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Grant Murray come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Daniel Cammiade come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stuart Paterson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di FOUR COUNTIES NEWSPAPERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCALL, Peter
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Segretario
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    146753430001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish164400440001
    KING, David John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish179020430001
    BELL, Anita Marie
    Kelso House Staple Road
    Wingham
    CT3 1AL Canterbury
    Kent
    Segretario
    Kelso House Staple Road
    Wingham
    CT3 1AL Canterbury
    Kent
    British50687450002
    CHEVIN-HALL, Nigel Clive
    Longridge House
    Church Lane Church Brampton
    NN6 8AT Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Longridge House
    Church Lane Church Brampton
    NN6 8AT Northampton
    Northamptonshire
    British60595360001
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Segretario
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    British474360001
    COMYN, Paul Fergus
    23 St James Avenue
    TW12 1HH Hampton Hill
    Middlesex
    Segretario
    23 St James Avenue
    TW12 1HH Hampton Hill
    Middlesex
    Irish3889300001
    COOPER, Philip Richard
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    Segretario
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    British131295290001
    WILLIAMS, Michael Lee
    Clarborough Hall
    Clarborough
    DN22 9NH Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    Clarborough Hall
    Clarborough
    DN22 9NH Retford
    Nottinghamshire
    British3554180001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Amministratore
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritish37521870002
    BROADLEY, Robert
    Abbeydale
    48 Chiselhurst Road
    BR7 5LD Chiselhurst
    Kent
    Amministratore
    Abbeydale
    48 Chiselhurst Road
    BR7 5LD Chiselhurst
    Kent
    British13726050001
    BURNETT, Neil John Main
    4 Marsham Court Road
    B91 2ET Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    4 Marsham Court Road
    B91 2ET Solihull
    West Midlands
    British32240020002
    CAMMIADE, Danny
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Amministratore
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    EnglandBritish251394160001
    CHEVIN-HALL, Nigel Clive
    Longridge House
    Church Lane Church Brampton
    NN6 8AT Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Longridge House
    Church Lane Church Brampton
    NN6 8AT Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish60595360001
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Amministratore
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    ScotlandBritish474360001
    CLARK, Gareth Peter Andrew
    Burdenshot House
    Burdenshott Hill, Worplesdon
    GU3 3RL Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Burdenshot House
    Burdenshott Hill, Worplesdon
    GU3 3RL Guildford
    Surrey
    British69163560001
    COMYN, Paul Fergus
    23 St James Avenue
    TW12 1HH Hampton Hill
    Middlesex
    Amministratore
    23 St James Avenue
    TW12 1HH Hampton Hill
    Middlesex
    Irish3889300001
    EDWARDSON, Geoffrey
    50 Southridge Drive
    NG18 4RL Mansfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    50 Southridge Drive
    NG18 4RL Mansfield
    Nottinghamshire
    British15853220001
    FORDHAM, David Sidney
    Copper Beeches
    Leckhampstead Road
    MK18 5HG Akeley
    Buckingham
    Amministratore
    Copper Beeches
    Leckhampstead Road
    MK18 5HG Akeley
    Buckingham
    United KingdomBritish,German84247970002
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Amministratore
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritish136914890001
    FULLER, Michael Albert
    Kelso Far Back Lane
    Farnsfield
    NG22 8JX Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Kelso Far Back Lane
    Farnsfield
    NG22 8JX Newark
    Nottinghamshire
    British35721290001
    HOLDEN, Barrie Leslie
    Brick Hill Farm Brickhill Lane
    Newborough
    DE13 8SW Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Brick Hill Farm Brickhill Lane
    Newborough
    DE13 8SW Burton On Trent
    Staffordshire
    British54528020004
    HOLLYHEAD, John Christopher
    43 Saint Peters Drive
    WR6 6QZ Martley
    Worcester
    Amministratore
    43 Saint Peters Drive
    WR6 6QZ Martley
    Worcester
    British73264540001
    KHANGURA, Gurmeet Singh
    1 Haverley
    85 Worple Road
    SW19 4JH London
    Amministratore
    1 Haverley
    85 Worple Road
    SW19 4JH London
    British82822740002
    LAMBERT, Harry Paul
    Le Park Palace E534
    Impasse De La Fontaine
    Mc98000
    Monaco
    Amministratore
    Le Park Palace E534
    Impasse De La Fontaine
    Mc98000
    Monaco
    British2359770006
    LUSBY, Martin Alan
    Broad Meadows
    Barford Hill, Barford
    CV35 8BZ Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    Broad Meadows
    Barford Hill, Barford
    CV35 8BZ Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish64847950001
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Amministratore
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritish159877110001
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish64281400001
    ROPER, Norman Stanley
    Meadow Farm High Street
    Elkesley
    DN22 8AJ Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Meadow Farm High Street
    Elkesley
    DN22 8AJ Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritish32478890001
    WILLIAMS, Michael Lee
    Clarborough Hall
    Clarborough
    DN22 9NH Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Clarborough Hall
    Clarborough
    DN22 9NH Retford
    Nottinghamshire
    British3554180001

    FOUR COUNTIES NEWSPAPERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed to a debenture dated 29TH june 1999
    Creato il 08 nov 1999
    Consegnato il 20 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bnak PLC for Itself and as Security Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 20 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 gen 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 gen 1997
    Consegnato il 29 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a westbourne house newcastle street worksop nottinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 gen 1997
    Consegnato il 29 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 18 carolgate retford nottingham and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 feb 1996
    Consegnato il 07 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 ott 1988
    Consegnato il 15 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    35A cartergate, newark notts.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 07 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 giu 1984
    Consegnato il 08 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 gen 1984
    Consegnato il 24 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H westbourne house, newcastle street, worksop, nottinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 gen 1981
    Consegnato il 30 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 18 carolgate, retford, nottinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0