ATLAS KNOWLEDGE LIMITED

ATLAS KNOWLEDGE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàATLAS KNOWLEDGE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01231037
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ATLAS KNOWLEDGE LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ATLAS KNOWLEDGE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Martin's Courtyard Riverside Europe Partners Llp
    Slingsby Place - 5th Floor
    WC2E 9AB London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ATLAS KNOWLEDGE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ATLAS INTERACTIVE LTD04 mag 199504 mag 1995
    SHERINGTON-ZODIAC LIMITED24 ott 197524 ott 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di ATLAS KNOWLEDGE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per ATLAS KNOWLEDGE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione di Hg Pooled Management Limited come persona con controllo significativo il 29 nov 2019

    1 paginePSC07

    Soddisfazione dell'onere 012310370006 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 dic 2019

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2019 al 31 dic 2019

    1 pagineAA01

    Iscrizione dell'ipoteca 012310370007, creata il 10 lug 2019

    21 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 012310370006, creata il 17 giu 2019

    16 pagineMR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2018

    12 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Level 13 the Broadgate Tower Primrose Street London EC2A 2EW a St Martin's Courtyard Riverside Europe Partners Llp Slingsby Place - 5th Floor London WC2E 9AB in data 17 dic 2018

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Gareth Gilbert come amministratore in data 09 nov 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Scott Irving Kerr come amministratore in data 09 nov 2018

    2 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    14 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Harry Van Der Vossen come amministratore in data 08 nov 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    29 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name08 set 2017

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 07 set 2017

    RES15

    Bilancio redatto al 30 set 2016

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di ATLAS KNOWLEDGE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACKIE, Ian Alan
    Riverside Europe Partners Llp
    Slingsby Place - 5th Floor
    WC2E 9AB London
    St Martin's Courtyard
    England
    Segretario
    Riverside Europe Partners Llp
    Slingsby Place - 5th Floor
    WC2E 9AB London
    St Martin's Courtyard
    England
    197709940001
    GILBERT, Gareth
    Riverside Europe Partners Llp
    Slingsby Place - 5th Floor
    WC2E 9AB London
    St Martin's Courtyard
    England
    Amministratore
    Riverside Europe Partners Llp
    Slingsby Place - 5th Floor
    WC2E 9AB London
    St Martin's Courtyard
    England
    ScotlandBritishCompany Director242710920001
    KERR, Scott Irving
    Riverside Europe Partners Llp
    Slingsby Place - 5th Floor
    WC2E 9AB London
    St Martin's Courtyard
    England
    Amministratore
    Riverside Europe Partners Llp
    Slingsby Place - 5th Floor
    WC2E 9AB London
    St Martin's Courtyard
    England
    NorwayAmericanCompany Director253161410001
    MACKIE, Ian Alan
    Riverside Europe Partners Llp
    Slingsby Place - 5th Floor
    WC2E 9AB London
    St Martin's Courtyard
    England
    Amministratore
    Riverside Europe Partners Llp
    Slingsby Place - 5th Floor
    WC2E 9AB London
    St Martin's Courtyard
    England
    ScotlandBritishChartered Accountant73715520002
    SHORT, Kevin Hugh
    Riverside Europe Partners Llp
    Slingsby Place - 5th Floor
    WC2E 9AB London
    St Martin's Courtyard
    England
    Amministratore
    Riverside Europe Partners Llp
    Slingsby Place - 5th Floor
    WC2E 9AB London
    St Martin's Courtyard
    England
    United KingdomBritishN/A173740350001
    CARR, Vivienne Scott
    Elm Tree Cottage Riverside Road West
    Newton Ferrers
    PL8 1AD Plymouth
    Devon
    Segretario
    Elm Tree Cottage Riverside Road West
    Newton Ferrers
    PL8 1AD Plymouth
    Devon
    British17059530001
    CHRISTIE, Sarah
    Arthrath Farmhouse
    Arthrath
    AB41 8YN Ellon
    Segretario
    Arthrath Farmhouse
    Arthrath
    AB41 8YN Ellon
    BritishFinance & Hr Manager99625340002
    MACKAY, Kelly
    20 Pennan Road
    AB41 8AT Ellon
    Aberdeenshire
    Segretario
    20 Pennan Road
    AB41 8AT Ellon
    Aberdeenshire
    BritishBusiness Mgr68526040002
    MCCANN, James
    65a Imperial Road
    SL4 3RU Windsor
    Berkshire
    Segretario
    65a Imperial Road
    SL4 3RU Windsor
    Berkshire
    BritishDirector126410730001
    PARK, George Graeme
    The Broadgate Tower
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13
    United Kingdom
    Segretario
    The Broadgate Tower
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13
    United Kingdom
    178504540001
    WATKINS, Christopher Benedict
    44 Laurel Wynd
    Danestone
    AB22 8XX Aberdeen
    Segretario
    44 Laurel Wynd
    Danestone
    AB22 8XX Aberdeen
    BritishDirector20950700004
    BENNETT, Jamieson Robert Forrest
    Brooklands Of Ardoe
    South Deeside Road, Blairs
    AB12 5YP Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Brooklands Of Ardoe
    South Deeside Road, Blairs
    AB12 5YP Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishCeo126420410001
    BENNETT, Jamieson Robert Forrest
    Brooklands Of Ardoe
    South Deeside Road, Blairs
    AB12 5YP Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Brooklands Of Ardoe
    South Deeside Road, Blairs
    AB12 5YP Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishCompany Director126420410001
    CARR, Ronald
    Elm Tree Cottage Riverside Road West
    Newton Ferrers
    PL8 1AD Plymouth
    Devon
    Amministratore
    Elm Tree Cottage Riverside Road West
    Newton Ferrers
    PL8 1AD Plymouth
    Devon
    United KingdomBritishCompany Director17059540001
    CARR, Vivienne Scott
    Elm Tree Cottage Riverside Road West
    Newton Ferrers
    PL8 1AD Plymouth
    Devon
    Amministratore
    Elm Tree Cottage Riverside Road West
    Newton Ferrers
    PL8 1AD Plymouth
    Devon
    BritishCompany Director17059530001
    CLARK, James Anderson
    15 Earlspark Road
    Bieldside
    AB15 9BZ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    15 Earlspark Road
    Bieldside
    AB15 9BZ Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishCompany Director2203720001
    IMRIE, Andrew William
    Hilview Road
    AB15 9HB Cults
    14
    Aberdeen
    Amministratore
    Hilview Road
    AB15 9HB Cults
    14
    Aberdeen
    ScotlandBritishDirector170201690001
    LOVE, Timothy Frank
    Oaklands St Johns Wood
    South Deeside Road Maryculter
    AB12 5GE Aberdeen
    Amministratore
    Oaklands St Johns Wood
    South Deeside Road Maryculter
    AB12 5GE Aberdeen
    ScotlandBritishDirector873740003
    MCCANN, James
    65a Imperial Road
    SL4 3RU Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    65a Imperial Road
    SL4 3RU Windsor
    Berkshire
    EnglandBritishDirector126410730001
    PARK, George Graeme
    The Broadgate Tower
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13
    United Kingdom
    Amministratore
    The Broadgate Tower
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector101338970002
    ROWLEY, John Timothy
    Grove Park Terrace
    Chiswick
    W4 3QG London
    14
    United Kingdom
    Amministratore
    Grove Park Terrace
    Chiswick
    W4 3QG London
    14
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector81506700001
    SINCLAIR, Thomas Robert
    Tighsith
    Holm
    KW17 2RX Orkney
    Isle Of Orkney
    Amministratore
    Tighsith
    Holm
    KW17 2RX Orkney
    Isle Of Orkney
    ScotlandBritishBusinessman68525930001
    VAN DER VOSSEN, Harry
    Deeside Cottage
    Blairs
    AB12 5YP Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Deeside Cottage
    Blairs
    AB12 5YP Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomDutchDirector122556870001
    WATKINS, Christopher Benedict
    44 Laurel Wynd
    Danestone
    AB22 8XX Aberdeen
    Amministratore
    44 Laurel Wynd
    Danestone
    AB22 8XX Aberdeen
    BritishDirector20950700004

    Chi sono le persone con controllo significativo di ATLAS KNOWLEDGE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hg Pooled Management Limited
    More London Riverside
    SE1 2AP London
    2
    England
    06 apr 2016
    More London Riverside
    SE1 2AP London
    2
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company Acting In Its Capacity As Manager Of Hgcapital Funds
    Autorità legaleEngland And Wales
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    ATLAS KNOWLEDGE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 10 lug 2019
    Consegnato il 12 lug 2019
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Nordea Bank Abp, Filial I Norge
    Transazioni
    • 12 lug 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 17 giu 2019
    Consegnato il 18 giu 2019
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 lug 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 05/12/2007 and
    Creato il 28 nov 2007
    Consegnato il 18 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Offshore house bridge of don aberdeen t/no ABN92301.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 nov 2007
    Consegnato il 12 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 12/06/2007 and
    Creato il 11 mag 2007
    Consegnato il 28 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sub tenants interest in the subjects k/a offshore house aberdeen science & energy park bridge of don aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 nov 2000
    Consegnato il 28 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 apr 1997
    Consegnato il 02 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0