AIR 2000 AVIATION LIMITED

AIR 2000 AVIATION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAIR 2000 AVIATION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01232085
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    • Trasporto aereo passeggeri non programmato (51102) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OWNERS ABROAD AVIATION LIMITED11 lug 198411 lug 1984
    OWNERS ABROAD WHOLESALE LIMITED 03 nov 197503 nov 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 mag 2012

    Stato del capitale al 22 mag 2012

    • Capitale: GBP 2,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Joyce Walter il 09 mag 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Christine Margaret Browne il 15 ott 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Christine Margaret Browne il 16 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Joyce Walter il 24 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs. Joyce Walter il 24 giu 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    3 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    3 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WALTER, Joyce
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Segretario
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    British76169540002
    BROWNE, Christine Margaret
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish79573340002
    WALTER, Joyce
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish76169540003
    BUCKLEY, Peter Eric
    Pine Lodge
    Worthing Road Southwater
    RH13 9AT Horsham
    West Sussex
    Segretario
    Pine Lodge
    Worthing Road Southwater
    RH13 9AT Horsham
    West Sussex
    English14052080002
    STARLING, Rebecca Jean Godwin
    11 Rossdale Road
    Putney
    SW15 1AD London
    Segretario
    11 Rossdale Road
    Putney
    SW15 1AD London
    British45381850004
    ADDISON SMITH, Nigel
    49 Fullerton Road
    Wandsworth
    SW18 1BU London
    Amministratore
    49 Fullerton Road
    Wandsworth
    SW18 1BU London
    British46750900002
    ALLARD, Roger Jeffrey
    4a Elystan Street
    SW3 3NS London
    Amministratore
    4a Elystan Street
    SW3 3NS London
    United KingdomEnglish81122260002
    BRYANT, Robert David
    Dorill
    Church Road, Buxted
    TN22 4LT Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Dorill
    Church Road, Buxted
    TN22 4LT Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritish152320790001
    BUNN, James Richard
    Great Lime Kiln
    RH13 9JL Southwater
    28
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Lime Kiln
    RH13 9JL Southwater
    28
    West Sussex
    United Kingdom
    British98013270002
    GILL, David Alan
    5 Chanctonbury Drive
    SL5 9PT Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    5 Chanctonbury Drive
    SL5 9PT Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritish37437870002
    HEALD, Malcolm Barclay
    Summerley House
    Ellwood Road
    HP9 1EN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Summerley House
    Ellwood Road
    HP9 1EN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish1605080001
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    HUMPHRIES, Michael
    3 Paget Close
    RH13 6HD Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    3 Paget Close
    RH13 6HD Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish38432430001
    KLEIN, Howard Malcolm
    14 Claybury Hall
    Repton Park
    IG8 8RW Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    14 Claybury Hall
    Repton Park
    IG8 8RW Woodford Green
    Essex
    British105173540001
    MAY, Iain Richard Campbell
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    GbrBritish32619030002
    MOIR, Lance Stuart
    86 Riversdale Road
    N5 2JZ London
    Amministratore
    86 Riversdale Road
    N5 2JZ London
    British51082180002
    SALMON, Tina
    31 Waverley Avenue
    Chingford
    E4 8HS London
    Amministratore
    31 Waverley Avenue
    Chingford
    E4 8HS London
    British28958240001
    SEMPLE, Alan Haig
    Foxley House 20 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    Foxley House 20 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    British67061580001
    SINCLAR, Vari
    8 Bethune Close
    Worth
    RH10 7WB Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    8 Bethune Close
    Worth
    RH10 7WB Crawley
    West Sussex
    British38474450001
    SMITH, Kenneth William
    10 Martello Mews
    BN25 1JT Seaford
    East Sussex
    Amministratore
    10 Martello Mews
    BN25 1JT Seaford
    East Sussex
    British87819940001
    STEVENS, Robert
    4 Chiltenhurst
    TN8 5PJ Edenbridge
    Kent
    Amministratore
    4 Chiltenhurst
    TN8 5PJ Edenbridge
    Kent
    EnglandBritish83941990001
    STONE, Geofrey George
    7 Harcourt Manor
    Harcourt Terrace
    SP2 7SA Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    7 Harcourt Manor
    Harcourt Terrace
    SP2 7SA Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish44562670002

    AIR 2000 AVIATION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed relating to netting and payment arrangements
    Creato il 28 feb 1997
    Consegnato il 12 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Any obligation for the payment or repayment of money, whether actual or contingent, present or future, joint or several and whether incurred as principal or surety, including principal, interest, commission, fees and other lawful charges and expenses for which a participant (as defined) may be or become liable to the chargee (in its capacity as security trustee) and the banks (as defined)
    Brevi particolari
    By clause 3.1 of the deed, the company agreed that each bank may, at any time or times on or after the enforcement date (as defined in the inter-creditor agreement) without notice, set off any or all sums of money now or subsequently standing to the credit of the company (including any unmatured deposit or any deposit in respect of which the appropriate call notice has not been given) against all or such part of such indebtedness as such bank may determine (whether presently payable or not).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit
    Creato il 30 ott 1990
    Consegnato il 19 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 30/10/90 and/or this charge
    Brevi particolari
    The aggregate amount at any relevant time standing to the credit of the blocked deposit account in the name of the company opened, or as the code may be, to be opened in the books of mars nominees LTD. (Please see 395 M82 for details).
    Persone aventi diritto
    • Guinness & Mahon Limited
    Transazioni
    • 19 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 12 apr 1989
    Consegnato il 21 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a bond facility agreement dated 12/4/89 and this charge
    Brevi particolari
    All the companys right title and interest in and to all monies which wereat the date of assignment (see 395 & cont sheet m 125C for details).
    Persone aventi diritto
    • Guinness & Mahon Limited
    Transazioni
    • 21 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 20 ott 1988
    Consegnato il 09 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a bond facility agreement dated 20 oct 1988 and this charge.
    Brevi particolari
    All the companys rights title and interest in and to all moneys standing to the credit of the blocked deposit accounts in the name of the company.
    Persone aventi diritto
    • Guinness Mahon & Co Limited
    Transazioni
    • 09 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 28 set 1988
    Consegnato il 18 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement of even date and this charge
    Brevi particolari
    The aggregate amount standing to the credit of the blocked deposit account in the name of the company open or to be opened in the books of guinness mahon nominees limited ( see form 395 and continuation sheet relevant to the charge ).
    Persone aventi diritto
    • Guinness Mahon & Co Limited
    Transazioni
    • 18 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Aircraft mortgage
    Creato il 01 dic 1987
    Consegnato il 08 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,000,000 and other all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeverunder the terms of the charge
    Brevi particolari
    Boeing modle 727-217 reg. Mark g - nroa serial no- 21056 engines serial nos 686371, 688042 and 707910.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 23 feb 1987
    Consegnato il 26 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    1,000,000 and other all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One boeing 727-217 aircraft with reg. No g-nroa including all spare parts and all spare aircraft engines for the aircraft.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Agreement
    Creato il 23 mag 1986
    Consegnato il 31 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    An amount standing to the credit of a bank acount which shall not exceed a maximum amount of £300,000 together with the pull amount of any balance of sale proceeds relating to the sale of an aircraft remaining after any mortgages have been discharged in full.
    Brevi particolari
    A bank account and the balance of sale proceeds.
    Persone aventi diritto
    • Dan-Air Services Limited
    Transazioni
    • 31 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 18 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Aircraft mortgage
    Creato il 23 mag 1986
    Consegnato il 27 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/5/86
    Brevi particolari
    All the companys present & future lights benefite & interest in the boeing 727 -217 advanced net air craft & manufacturers serial number 21056. and UK registration mark g- nroa, its engines any replacement and equipment from time to time installed thereof the insurances (other than liability mcullances) and earnings of the aircraft.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific Eurofinance (UK) Limited
    Transazioni
    • 27 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 30 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Aircraft mortgage
    Creato il 23 mag 1986
    Consegnato il 27 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/5/86
    Brevi particolari
    All the companies rights title and interest to and in any monies payable to the company under an aircraft lease agreement dated 01/12/83. (see doc M27 for full details) and all the companies rights, title and interest to arain any monies whatsoever payable to the company under a guarantee issued on 25/05/86 by lloyds bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific Eurofinance (UK) Limited
    Transazioni
    • 27 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 mag 1986
    Consegnato il 27 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 03 feb 1986
    Consegnato il 06 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 27/11/85
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges on undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 01 dic 1983
    Consegnato il 02 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee following the termination in certain circumstances of an aircraft lease agreement dated 1-12-83
    Brevi particolari
    All the company's rights title and interest to the relevant proportion of the remaining net sales proceeds (all as defined in the said charge and/or aircraft lease agreement).
    Persone aventi diritto
    • Dan-Air Services Limited
    Transazioni
    • 02 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Deed
    Creato il 01 dic 1983
    Consegnato il 02 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30TH november 1983 and/or this deed and/or any subsitute mortgage.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges over the right title and interest in 1. boeing 727 - 217 aircraft serial no 21056 reg mark g-bkng. 3 pratt & whitney jt 8D-d engines serial nos 688044,688054 and 688065 2. the lease dated 1ST dec. 1983 and any sub lease. 3. bank guarantee. 4. the purchase agreement 5. all moneys in sterling current account no 51511022 at the banks cannon street branch. (Please see doc M23 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bank of America Nt & Sa
    Transazioni
    • 02 dic 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0