ECLIPSE PARK ACQUISITIONS LIMITED
Panoramica
Nome della società | ECLIPSE PARK ACQUISITIONS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01235951 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ECLIPSE PARK ACQUISITIONS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ECLIPSE PARK ACQUISITIONS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 15 Canada Square E14 5GL London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ECLIPSE PARK ACQUISITIONS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
VANGUARD INSURANCE SERVICES LIMITED | 18 ago 1986 | 18 ago 1986 |
BRIDGEND INSURANCE SERVICES LIMITED | 26 gen 1982 | 26 gen 1982 |
BRIDGEND INSURANCE BROKERS LIMITED | 02 dic 1975 | 02 dic 1975 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ECLIPSE PARK ACQUISITIONS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per ECLIPSE PARK ACQUISITIONS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Cessazione della carica di Geoffrey Costerton Gouriet come segretario in data 11 dic 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN a 15 Canada Square London E14 5GL in data 10 dic 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 03 ago 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Geoffrey Costerton Gouriet come segretario in data 03 ago 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 012359510005 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr Antonios Erotocritou come amministratore in data 02 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Stephen Mugge come amministratore in data 02 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David Christopher Ross come amministratore in data 20 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 20 dic 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jennifer Owens come segretario in data 01 mar 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Stephen Mugge il 25 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Scott Egan come amministratore in data 14 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ECLIPSE PARK ACQUISITIONS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EROTOCRITOU, Antonios | Amministratore | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | Cypriot | Deputy Cfo | 167795710001 | ||||
ROSS, David Christopher | Amministratore | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | Irish | Director | 222326970001 | ||||
BROWN, Ian William | Segretario | 36 Beech Wood Drive Tonyrefail CF39 8JE Rhondda Cynon Taff Mid Glamorgan | British | Company Director | 262382040001 | |||||
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Segretario | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | British | 117669700002 | ||||||
GOURIET, Geoffrey Costerton | Segretario | Canada Square E14 5GL London 15 | 249087790001 | |||||||
GREGORY, Jacqueline Anne | Segretario | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent | 221956320001 | |||||||
OWENS, Jennifer | Segretario | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | 183283190001 | |||||||
PHILLIPOU, Pamela Eileen | Segretario | 82 Dan Y Coed Road Cyncoed CF23 6NF Cardiff South Glamorgan | British | 81624140001 | ||||||
SMITH, Julie Ann | Segretario | 8 Ty Wern Avenue Rhiwbina CF14 6AW Cardiff South Glamorgan | British | 105414660001 | ||||||
BROWN, Ian William | Amministratore | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 130845560001 | ||||
BROWN, Roger Michael | Amministratore | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | England | British | Company Director | 134140540001 | ||||
CHARD, Michael Francis | Amministratore | 23 Knightsbridge Court CH1 1QG Chester | Uk | British | Chairman | 45725420009 | ||||
EGAN, Scott | Amministratore | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | British | Director | 170703910001 | ||||
HAGGETT, Linda | Amministratore | Graig Y Mynydd CF39 8FD Thomastown 51 Tonyrefail | United Kingdom | Welsh | Company Director | 137893590001 | ||||
HODGES, Mark Steven | Amministratore | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | United Kingdom | British | Director | 58444370003 | ||||
JOHNSON, Timothy David | Amministratore | The Green Westerham TN16 1AS Kent Nursery Cottage 3a | England | British | Company Director | 129538180001 | ||||
LYONS, Alastair David | Amministratore | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent | United Kingdom | British | Executive Chairman | 193683910001 | ||||
MUGGE, Mark Stephen | Amministratore | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent | England | British | Director | 162920630005 | ||||
PATRICK, Ian William James | Amministratore | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | United Kingdom | British | Director | 75028400004 | ||||
PHILIP, Timothy Duncan | Amministratore | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | United Kingdom | British | Director | 99066410001 | ||||
PHILLIPOU, Pamela Eileen | Amministratore | 82 Dan Y Coed Road Cyncoed CF23 6NF Cardiff South Glamorgan | British | Director | 81624140001 | |||||
PHILLIPOU, Peter John | Amministratore | 82 Dan Y Coed Road Cyncoed CF2 6NF Cardiff South Glamorgan | British | Insurance Broker | 12652860001 | |||||
PHLLIPOU, John Edward | Amministratore | 6 Edgerly Gardens Cosham PO6 2SX Portsmouth Hampshire | British | Finance Manager | 102828200001 | |||||
RAGAN, Paul Robert | Amministratore | Tregyrnog Farmhouse St. Brides-Super-Ely CF5 6EZ Cardiff Vale Of Glamorgan | United Kingdom | British | Company Director | 60263070005 | ||||
REA, Michael Peter | Amministratore | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | British | Director | 147194830001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ECLIPSE PARK ACQUISITIONS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towergate Insurance Limited | 06 apr 2016 | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
ECLIPSE PARK ACQUISITIONS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 02 apr 2015 Consegnato il 22 apr 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 10 mag 2013 Consegnato il 23 mag 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Pursuant to the charge:. The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security accession deed | Creato il 28 set 2012 Consegnato il 10 ott 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all f/h and l/h property and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security accession deed | Creato il 28 set 2012 Consegnato il 10 ott 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all f/h and l/h property and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 28 apr 2000 Consegnato il 29 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The freehold property known as 49 and 51 nolton street bridgend title number WA388129. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
ECLIPSE PARK ACQUISITIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0