BALLARD (KENT) LIMITED

BALLARD (KENT) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBALLARD (KENT) LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01237454
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di BALLARD (KENT) LIMITED?

    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova BALLARD (KENT) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One
    New Street
    BA5 2LA Wells
    Somerset
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BALLARD (KENT) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    E.W. BALLARD (KENT) LIMITED15 dic 197515 dic 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di BALLARD (KENT) LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 lug 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 apr 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BALLARD (KENT) LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al06 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma20 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al06 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per BALLARD (KENT) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione di Anna Elizabeth Gunning come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC07

    Notifica di E W Ballard Kent (1993) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 lug 2023

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 lug 2022

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 lug 2021, non revisionato

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 lug 2020, non revisionato

    9 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 012374540013 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 012374540012 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Anna Elizabeth Gunning il 09 nov 2020

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Mrs Anna Elizabeth Gunning come persona con controllo significativo il 09 nov 2020

    2 paginePSC04

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 lug 2019, non revisionato

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Anna Elizabeth Ballard il 17 giu 2019

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Anna Elizabeth Ballard il 17 giu 2019

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Mrs Anna Elizabeth Ballard come persona con controllo significativo il 17 giu 2019

    2 paginePSC04

    Bilancio abbreviato redatto al 31 lug 2018, non revisionato

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 lug 2017, non revisionato

    9 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di BALLARD (KENT) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GUNNING, Anna Elizabeth
    New Street
    BA5 2LA Wells
    One
    Somerset
    Segretario
    New Street
    BA5 2LA Wells
    One
    Somerset
    BritishNone96613550008
    GUNNING, Anna Elizabeth
    New Street
    BA5 2LA Wells
    One
    Somerset
    Amministratore
    New Street
    BA5 2LA Wells
    One
    Somerset
    EnglandBritishNone96613550011
    MOORE, William Frederick Henry
    New Street
    BA5 2LA Wells
    One
    Somerset
    Amministratore
    New Street
    BA5 2LA Wells
    One
    Somerset
    United KingdomBritishDirector131896560004
    BALLARD, John
    350 Wateringbury Road
    East Malling
    ME19 6JH West Malling
    Kent
    Segretario
    350 Wateringbury Road
    East Malling
    ME19 6JH West Malling
    Kent
    BritishBuilder63021550002
    BALLARD, Martyn
    4 Berkeley Close
    Dunkirk
    ME13 9TR Faversham
    Kent
    Segretario
    4 Berkeley Close
    Dunkirk
    ME13 9TR Faversham
    Kent
    British42919530001
    BALLARD, Martyn
    4 Berkeley Close
    Dunkirk
    ME13 9TR Faversham
    Kent
    Segretario
    4 Berkeley Close
    Dunkirk
    ME13 9TR Faversham
    Kent
    British42919530001
    JAMES, Julia
    Stablecroft, Watersmeet Farm
    Whetsted Road, Five Oak Green
    TN12 6SE Tonbridge
    Kent
    Segretario
    Stablecroft, Watersmeet Farm
    Whetsted Road, Five Oak Green
    TN12 6SE Tonbridge
    Kent
    BritishSecretary/Bookkeeper68865790001
    MOORE, Robert Alexander Joseph
    82 Warwick Park
    TN2 5EF Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    82 Warwick Park
    TN2 5EF Tunbridge Wells
    Kent
    British54454890001
    NEWTON, Jennifer Irene
    3 Avon Street
    TN1 2JG Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    3 Avon Street
    TN1 2JG Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Secretary60662910001
    ROMEO, Sandra
    6 Grove Avenue
    TN1 1UP Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    6 Grove Avenue
    TN1 1UP Tunbridge Wells
    Kent
    British40073070001
    BALLARD, Elizabeth
    Roosters Barn Bull Lane
    Newington
    ME9 7SJ Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    Roosters Barn Bull Lane
    Newington
    ME9 7SJ Sittingbourne
    Kent
    BritishSecretary11196540001
    BALLARD, John
    The Walls
    Edington
    TA7 9JU Bridgwater
    Church House
    Somerset
    United Kingdom
    Amministratore
    The Walls
    Edington
    TA7 9JU Bridgwater
    Church House
    Somerset
    United Kingdom
    EnglandBritishBuilder63021550013
    BALLARD, Roger
    Roosters Barn Bull Lane
    Newington
    ME9 7SJ Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    Roosters Barn Bull Lane
    Newington
    ME9 7SJ Sittingbourne
    Kent
    BritishBuilder3923480001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BALLARD (KENT) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Anna Elizabeth Gunning
    New Street
    BA5 2LA Wells
    One
    Somerset
    06 apr 2016
    New Street
    BA5 2LA Wells
    One
    Somerset
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    New Street
    BA5 2LA Wells
    One
    England
    06 apr 2016
    New Street
    BA5 2LA Wells
    One
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02818729
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BALLARD (KENT) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 mag 2013
    Consegnato il 25 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Flat 2 56 cranhurst road london. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 mag 2013
    Consegnato il 25 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Ground floor flat 177A woodhill woolwich london. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 mag 2013
    Consegnato il 11 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 ott 2007
    Consegnato il 08 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 29 ott 2007
    Consegnato il 13 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property known as 56B cranhurst road willesden green london t/n NGL412712,. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 02 apr 2004
    Consegnato il 20 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First floor flat 56 cranhurst road willesden green london NW2 t/n NGL412712. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge of licenced premises
    Creato il 22 lug 1998
    Consegnato il 31 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h land k/a heath farm 350 wateringbury road east malling and larkfield tonbridge and malling kent t/n K435105 the benefit of all justice exceise or other licences. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 lug 1998
    Consegnato il 31 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 27 mar 1998
    Consegnato il 03 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage 36 tintern road, allington park, maidstone, kent all covenants and rights affecting or concerning the property and any share from time to time held by the company in any landlord or management company of the property. By way of fixed charge the plant, machinery and fixtures and fittings, furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels, goodwill of any business and the proceeds of any insurance.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 16 apr 1997
    Consegnato il 23 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 2 14 lime hill road tunbridge wells kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1995
    Consegnato il 16 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/as 11 beaulieu rise medway rocester kent t/no K734533. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 17 mag 1995
    Consegnato il 20 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land/blds known as 30 woodhurst and garage chatham medway kent; t/no.K420656; the goodwill of business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1994
    Consegnato il 29 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at 66 high STREET5 tunbridge wells kent t/no K448662 with the goodwill of the business and A. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 1994
    Consegnato il 11 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:-land at chesley court,bull lane,newington kent t/n's K688898,K644771,K598635 and K726344 goodwill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0