THE TRIANGLE GROUP LIMITED

THE TRIANGLE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE TRIANGLE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01239031
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE TRIANGLE GROUP LIMITED?

    • (7440) /

    Dove si trova THE TRIANGLE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pembroke Building
    Kensington Village
    W14 8DG Avonmore Road
    London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE TRIANGLE GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRIANGLE COMMUNICATIONS LIMITED 30 giu 199430 giu 1994
    MARKETING TRIANGLE LIMITED(THE) 31 dic 197931 dic 1979
    T.H.H. SALES PROMOTION TRIANGLE LIMITED31 dic 197531 dic 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE TRIANGLE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per THE TRIANGLE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    1 pagine652a

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    17 pagineAA

    legacy

    7 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    17 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    7 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di THE TRIANGLE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EWING, Susanna
    72f Sinclair Road
    W14 0NJ London
    Segretario
    72f Sinclair Road
    W14 0NJ London
    British122102410001
    GONZALEZ-GOMEZ, Minna Katariina
    64 Elmhurst Mansions Edgeley Road
    SW4 6EU London
    Segretario
    64 Elmhurst Mansions Edgeley Road
    SW4 6EU London
    Finnish119965730001
    CAWLEY, Diana Pamela
    8 Huntingdon Street
    N1 1BU London
    Amministratore
    8 Huntingdon Street
    N1 1BU London
    British66621150004
    EDWARDS, Andrew Gwyn
    Prince Consort Drive
    SL5 8AW Ascot
    5
    Berkshire
    Amministratore
    Prince Consort Drive
    SL5 8AW Ascot
    5
    Berkshire
    United KingdomBritish121808440001
    FROST, Kevin Peter
    177 Broomwood Road
    Clapham Common
    SW11 6JX London
    Amministratore
    177 Broomwood Road
    Clapham Common
    SW11 6JX London
    British89075360001
    COLLINS, Andrew John
    84 Stanlake Road
    W12 7HJ London
    Segretario
    84 Stanlake Road
    W12 7HJ London
    British4006390001
    EARL, Elizabeth Louise Kiernan
    9 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    Segretario
    9 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    British105197540001
    HYSLOP, Roger Geoffrey
    Mermaid Cottage
    Hawridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Bucks
    Segretario
    Mermaid Cottage
    Hawridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Bucks
    British9340850001
    KURTZ, Catherine Elizabeth Strathmore
    6 Berkeley Road
    TN1 1YR Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    6 Berkeley Road
    TN1 1YR Tunbridge Wells
    Kent
    British54236170003
    LAWRENCE, Michael James
    50 Woodberry Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3LD London
    Segretario
    50 Woodberry Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3LD London
    British88140060001
    TOMSETT, Mark Anthony
    7 Avalon Road
    Earley
    RG6 7NS Reading
    Berkshire
    Segretario
    7 Avalon Road
    Earley
    RG6 7NS Reading
    Berkshire
    British51265530003
    TOPPIN, John Eric
    The Old Rectory
    Sutton Road
    ME17 3LY Langley
    Kent
    Segretario
    The Old Rectory
    Sutton Road
    ME17 3LY Langley
    Kent
    British62203080003
    WYLLIE, Alison
    Flat 2
    186 Ladbroke Grove
    W10 5LZ London
    Segretario
    Flat 2
    186 Ladbroke Grove
    W10 5LZ London
    British107811220001
    AXFORD, Christina
    Taverners
    Rush Green Hollybush Lane
    UB9 4HF Denham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Taverners
    Rush Green Hollybush Lane
    UB9 4HF Denham
    Buckinghamshire
    British75182500002
    BAKER, Elizabeth
    Fair Oak Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Fair Oak Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British21923390002
    BELTON, Patrick Lort
    40 Silvester Road
    SE22 9PB London
    Amministratore
    40 Silvester Road
    SE22 9PB London
    British89075270001
    BEVAN, Cerys
    50b Rossiter Road
    SW12 9RU London
    Amministratore
    50b Rossiter Road
    SW12 9RU London
    British71116450001
    CARLING, Thomas Wykeham
    6 The Rocks Road
    ME19 6AN East Malling
    Kent
    Amministratore
    6 The Rocks Road
    ME19 6AN East Malling
    Kent
    British98084860001
    CLARIDGE, Danny Arthur
    12 Carlina Gardens
    IG8 0BP Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    12 Carlina Gardens
    IG8 0BP Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish159527590001
    COLLINS, Andrew John
    84 Stanlake Road
    W12 7HJ London
    Amministratore
    84 Stanlake Road
    W12 7HJ London
    EnglandBritish4006390001
    DAVIES, Shelley Alexandra
    The Strand
    Quainton
    HP22 4AS Aylesbury
    2
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Strand
    Quainton
    HP22 4AS Aylesbury
    2
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish137205190001
    DUNN, Diana Pamela
    26 Thirlemere Road
    N10 2DN London
    Amministratore
    26 Thirlemere Road
    N10 2DN London
    British66621150001
    GRIFFITHS, Graham Mark Dilsmore
    Rowans 2 Marley Rise
    Ridgeway Road
    RH4 3BP Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Rowans 2 Marley Rise
    Ridgeway Road
    RH4 3BP Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish20173090002
    HEATH, Matthew Alexander
    The Old Forge
    South Stoke Road, Woodcote
    RG8 0PL Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Forge
    South Stoke Road, Woodcote
    RG8 0PL Reading
    Berkshire
    EnglandBritish93531810001
    HEBDON, Simon
    34 Telford Place
    CM1 7QZ Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    34 Telford Place
    CM1 7QZ Chelmsford
    Essex
    British72795050003
    HICKS, David Charles Francis
    6 Ernest Gardens
    W4 3QU London
    Amministratore
    6 Ernest Gardens
    W4 3QU London
    British68634660001
    HOADLEY, Nicholas Peter
    Primrose Cottage
    Wendover Road
    HP17 0TU Butlers Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Primrose Cottage
    Wendover Road
    HP17 0TU Butlers Cross
    Buckinghamshire
    British75180880002
    HOLGATE, Barbara
    4 The Chase
    AL6 0QT Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 The Chase
    AL6 0QT Welwyn
    Hertfordshire
    British66621160001
    HOWELL, Sarah
    Flat 4, 66 Elgin Avenue
    W9 2HA London
    Amministratore
    Flat 4, 66 Elgin Avenue
    W9 2HA London
    British71116370001
    HYSLOP, Elise Victoria Viviane
    George Street
    HP4 2EJ Berkhamsted
    99
    Hertfordshire
    Amministratore
    George Street
    HP4 2EJ Berkhamsted
    99
    Hertfordshire
    British89122880002
    HYSLOP, Roger Geoffrey
    Mermaid Cottage
    Hawridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Bucks
    Amministratore
    Mermaid Cottage
    Hawridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Bucks
    British9340850001
    MALCOLM, Frances Martha
    Flat 4
    29 St. James`S Gardens,Holland Park
    W11 4RF London
    Amministratore
    Flat 4
    29 St. James`S Gardens,Holland Park
    W11 4RF London
    British34057400002
    ORBELL, Andrew Mark
    Lindau Currant Hill
    South Bank
    TN16 1EN Westerham
    Kent
    Amministratore
    Lindau Currant Hill
    South Bank
    TN16 1EN Westerham
    Kent
    British20155470003
    PARRY, Christopher Douglas
    Dean Lodge
    16 Frieth Road
    SL7 2QT Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Dean Lodge
    16 Frieth Road
    SL7 2QT Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69601580002
    PRESLEY, Nicholas Ian
    Lobs House
    Fredley Park
    RH5 6DD Mickleham, Nr. Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Lobs House
    Fredley Park
    RH5 6DD Mickleham, Nr. Dorking
    Surrey
    EnglandBritish101807990001

    THE TRIANGLE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 09 giu 1999
    Consegnato il 24 giu 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 gen 1997
    Consegnato il 10 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or the triangle group limited and/or ocean marketing communications limited and/or eye ii eye communications limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 dic 1991
    Consegnato il 16 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Rear of second floor,17 newman street,london borough of city of westminster.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 dic 1991
    Consegnato il 15 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 feb 1990
    Consegnato il 21 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 lug 1988
    Consegnato il 04 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 maple mews london borough of city of westminster title no. Ngl 585430.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 mar 1988
    Consegnato il 31 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 nov 1984
    Consegnato il 04 dic 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 giu 1984
    Consegnato il 21 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Second floor, 17 newman street, (14A newman passage) westminster london.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 19 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 apr 1984
    Consegnato il 12 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold ground floor & basement 17, newman street, westminster, london W1.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 19 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 dic 1983
    Consegnato il 05 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0