COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED

COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOULSON HERON ASSOCIATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01239073
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Breakspear Park
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2021

    4 pagineAA

    Cessazione di James Douglas Mcfarlane come persona con controllo significativo il 14 dic 2021

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2020

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2019

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 nov 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 nov 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 11th Floor Two Snow Hill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6WR

    1 pagineAD03

    Notifica di Redsky It (Crick) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Notifica di James Douglas Mcfarlane come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC01

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 03 apr 2018

    2 paginePSC09

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2017

    4 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 012390730009, creata il 22 nov 2017

    83 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 dic 2015

    Stato del capitale al 07 dic 2015

    • Capitale: GBP 96,000
    SH01

    Cessazione della carica di Julian Richard Henwood come segretario in data 25 feb 2015

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2014

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCFARLANE, James Douglas
    730 Eyremount Drive
    West Vancouver
    Bc V76 2a4
    Canada
    Amministratore
    730 Eyremount Drive
    West Vancouver
    Bc V76 2a4
    Canada
    CanadaCanadian118810110004
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Segretario
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    British39034110001
    COTTRELL, Paul Alan
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    Segretario
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    British13754300002
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    HENWOOD, Julian Richard
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    Segretario
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    British65188860002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    BELLAMY, Paul Anthony
    9 Sadbury Close
    Worle
    BS22 0QP Weston Super Mare
    Avon
    Amministratore
    9 Sadbury Close
    Worle
    BS22 0QP Weston Super Mare
    Avon
    British34463620001
    BRADLEY, Michael John
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    Amministratore
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    British40818740003
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Amministratore
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    EnglandBritish39034110001
    EVANS, Robert Owen
    Hollybank
    32 Birches Lane
    CV8 2AD Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Hollybank
    32 Birches Lane
    CV8 2AD Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000001
    FLYNN, Thomas Desmond
    Larch Cottage 39 Bagley Wood Road
    Kennington
    OX1 5LY Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Larch Cottage 39 Bagley Wood Road
    Kennington
    OX1 5LY Oxford
    Oxfordshire
    British16993890001
    FOSTER, Michael
    The Ash Grove
    91 Bretby Lane
    DE15 0QP Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    The Ash Grove
    91 Bretby Lane
    DE15 0QP Burton On Trent
    Staffordshire
    British34463630001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    JONES, Nicholas David Brandon
    16 Dallington Park Road
    NN5 7AA Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    16 Dallington Park Road
    NN5 7AA Northampton
    Northamptonshire
    British16993910001
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British22190280002
    MATTHEW, Gordon John
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    Amministratore
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    EnglandBritish151547160001
    SINFIELD, Christopher
    Stonelea Cottage 24 Whiston Road
    Cogenhoe
    NN7 1NL Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Stonelea Cottage 24 Whiston Road
    Cogenhoe
    NN7 1NL Northampton
    Northamptonshire
    British37887830001
    SMITH, Gordon Saville
    32 St Peters Avenue
    NN16 0HA Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    32 St Peters Avenue
    NN16 0HA Kettering
    Northamptonshire
    British2436530001
    SUSSENS, John Gilbert
    25 Jordan Road
    B75 5AB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    25 Jordan Road
    B75 5AB Sutton Coldfield
    West Midlands
    British1442450001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    TEBBUTT, Arthur Mark
    26 Grange Road
    Geddington
    NN14 1AL Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    26 Grange Road
    Geddington
    NN14 1AL Kettering
    Northamptonshire
    United KingdomBritish2436540001
    WINGFIELD, Richard Alan
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    Amministratore
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    EnglandBritish76932830002

    Chi sono le persone con controllo significativo di COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr James Douglas Mcfarlane
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    06 apr 2016
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    Nazionalità: Canadian
    Paese di residenza: Canada
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    06 apr 2016
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02688394
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    07 nov 201603 apr 2018La società ha identificato una persona registrabile in relazione alla società, ma non sono stati confermati tutti i dati richiesti di tale persona.

    COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 nov 2017
    Consegnato il 29 nov 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada as Collateral Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 29 nov 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 gen 2015
    Consegnato il 03 feb 2015
    In corso
    Breve descrizione
    Coulson heron associates limited charges by way of fixed charge any right, title or interest which it has now or may subsequently acquire to or in any land (as defined in the debenture).. Coulson heron associates limited charges by way of legal mortgage the land at redsky house, eldon way, crick industrial estate, crick NN6 7SL with title number NN295077.. Coulson heron associates limited charges by way of first fixed charge all trade mark property, copyrights and related rights (as defined in the debenture), including all fees, royalties and other rights of every kind relating to or deriving from such rights.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transazioni
    • 03 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 gen 2014
    Consegnato il 07 feb 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Fixed charge over any right/ title/ interest which the company has or acquires over any other land.. Fixed charge over trade marks, any good will relating to a trade mark, any other right arising from, relating to, or associated with any trade mark or its use in a chargor’s business, copyrights and all other intellectual property rights (including all fees, royalties, and other rights). This applies to any intellectual property owned presently by the chargor or at any time between the date of the debenture (31 january 2014) and the date on which the security trustee is satisfied (acting reasonably) that all of the liabilities of the loan parties under each finance document are irrevocably discharged in full and no finance party has any commitment or liability, whether present or future, actual or contingent, in relation to the facility made available under the finance documents. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transazioni
    • 07 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Security agreement
    Creato il 21 dic 2010
    Consegnato il 05 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The collateral being all right in the accounts books chattel paper deposit accounts equipment and fixtures general intangibles inventory investment related property negotiable collateral supporting obligations, commercial tort claims, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transazioni
    • 05 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    General security agreement
    Creato il 21 dic 2010
    Consegnato il 05 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The collateral being all right in the undertaking and personal property which includes accounts chattel paper documents of title equipment goods instruments inventory investment property and money, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transazioni
    • 05 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2010
    Consegnato il 05 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transazioni
    • 05 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Copyright security agreement
    Creato il 21 dic 2010
    Consegnato il 05 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the copyrights and copyright intellectual property licences all renewals or extensions of the foregoing and all products and proceeds of the foregoing see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transazioni
    • 05 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Trademark security agreement
    Creato il 21 dic 2010
    Consegnato il 05 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its trademarks and trademark intellectual property licences all goodwill of the business and all products and proceeds of the foregoing see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada
    Transazioni
    • 05 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal mortgage
    Creato il 17 giu 1985
    Consegnato il 24 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold proeprty known as eldon way crick northamptonshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0