MEDIA AUDITS LIMITED

MEDIA AUDITS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMEDIA AUDITS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01242384
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MEDIA AUDITS LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova MEDIA AUDITS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MEDIA AUDITS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per MEDIA AUDITS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    legacy

    3 pagineMG02

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 Fenchurch Street London EC3M 3BD in data 08 giu 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 mar 2010

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 ago 2009

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 feb 2010

    Stato del capitale al 15 feb 2010

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del direttore cambiati per Patrick Brian Francis Rowe il 31 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Charles Thomlinson il 31 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Patrick Brian Francis Rowe il 31 dic 2009

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Alex Christou come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    26 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Simon Whitehouse come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Anthony Gerard Coughlan come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Robinson come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di MEDIA AUDITS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROWE, Patrick Brian Francis
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    Segretario
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    British140245520001
    COUGHLAN, Anthony Gerard
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    Amministratore
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    United KingdomIrish And AmericanPrincipal Accounting Officer146489390001
    ROWE, Patrick Brian Francis
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    Amministratore
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    EnglandBritishSolicitor140245520001
    THOMLINSON, David Charles
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    Amministratore
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    United KingdomBritishManagement Consultant115623850001
    CLUFF, Michael David Blake
    2 Percival Road
    East Sheen
    SW14 7QE London
    Segretario
    2 Percival Road
    East Sheen
    SW14 7QE London
    BritishCompany Director2019000002
    CLUFF, Michael David Blake
    2 Percival Road
    East Sheen
    SW14 7QE London
    Segretario
    2 Percival Road
    East Sheen
    SW14 7QE London
    BritishCompany Director2019000002
    KAYE, Carolyn Mary Naomi
    64 Whitehall Park
    N19 3TN London
    Segretario
    64 Whitehall Park
    N19 3TN London
    BritishFinance Director25447380003
    LAWRENCE, Stephen
    3 Thornton Street
    AL3 5JW St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Thornton Street
    AL3 5JW St. Albans
    Hertfordshire
    BritishAccountant70953080001
    LUGGERI, Anne Marion
    25 Grenville Gardens
    IG8 7AF Woodford Green
    Essex
    Segretario
    25 Grenville Gardens
    IG8 7AF Woodford Green
    Essex
    Irish22121890001
    MILES, James Bramwell Douglas
    1 Durham Road
    Manor Park
    E12 5AY London
    Segretario
    1 Durham Road
    Manor Park
    E12 5AY London
    British24855230001
    THORNTON, Alison
    21 Arlington Road
    KT6 6BW Surbiton
    Surrey
    Segretario
    21 Arlington Road
    KT6 6BW Surbiton
    Surrey
    British65307190001
    WALKER, Stephen Adrian
    198 Courthouse Road
    SL6 6HU Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    198 Courthouse Road
    SL6 6HU Maidenhead
    Berkshire
    BritishCompany Secretary13466600001
    ASTALL, Amanda Elisabeth
    White Hall
    Whitehough
    SK23 6EJ Chinley
    Derbyshire
    Amministratore
    White Hall
    Whitehough
    SK23 6EJ Chinley
    Derbyshire
    EnglandBritishManagement Consultant83767940001
    AYERS, Anthony
    The Mill House
    Chilton Foliat
    RG17 0TG Hungerford
    Berkshire
    Amministratore
    The Mill House
    Chilton Foliat
    RG17 0TG Hungerford
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer89840100001
    BARANGE, Guardiola Mauricio
    Font De Sant Burget
    No 17.121
    Monells
    Girona
    Spain
    Amministratore
    Font De Sant Burget
    No 17.121
    Monells
    Girona
    Spain
    SpanishCompany Director70328570001
    CHRISTOU, Alex, Dr
    Mount Vernon Frognal Rise
    Hampstead
    NW3 6PZ London
    8 Gainsborough House
    Amministratore
    Mount Vernon Frognal Rise
    Hampstead
    NW3 6PZ London
    8 Gainsborough House
    United KingdomBritishManagement Consultant128278420001
    CLUFF, Michael David Blake
    2 Percival Road
    East Sheen
    SW14 7QE London
    Amministratore
    2 Percival Road
    East Sheen
    SW14 7QE London
    BritishCompany Director2019000002
    CONSTANTINE, Paul
    11 Burland Road
    SW11 6SA London
    Amministratore
    11 Burland Road
    SW11 6SA London
    BritishAdvertising Consultant44029370001
    DAVIES, Michael
    Little Berwick
    Burton Bradstock
    DT6 4NE Bridport
    Dorset
    Amministratore
    Little Berwick
    Burton Bradstock
    DT6 4NE Bridport
    Dorset
    BritishNon Executive Director17794590001
    FODEN, Arthur John
    Worleys Hill
    Upper Culham
    RG10 8PA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Worleys Hill
    Upper Culham
    RG10 8PA Reading
    Berkshire
    BritishConsultant15337230003
    GRAHAM, Lynda Patricia
    7 Elystan Walk
    N1 0HJ London
    Amministratore
    7 Elystan Walk
    N1 0HJ London
    BritishMd Uk51728320001
    HOLMES, Peter David
    2a Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Amministratore
    2a Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    EnglandBritishDirector76233650001
    JOHNSON-MUNDAY, Joanne Erica
    Bird Brook Horseshoe Lane
    GU6 8QD Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    Bird Brook Horseshoe Lane
    GU6 8QD Cranleigh
    Surrey
    BritishAccount Director2019020001
    KAYE, Carolyn Mary Naomi
    64 Whitehall Park
    N19 3TN London
    Amministratore
    64 Whitehall Park
    N19 3TN London
    BritishFinance Director25447380003
    LARKIN, Michael James
    6 Watermans Mews
    The Mall
    W5 3TD London
    Amministratore
    6 Watermans Mews
    The Mall
    W5 3TD London
    EnglandBritishDirector66506730002
    LAWRENCE, Stephen
    3 Thornton Street
    AL3 5JW St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Thornton Street
    AL3 5JW St. Albans
    Hertfordshire
    BritishAccountant70953080001
    LUGGERI, Anne Marion
    25 Grenville Gardens
    IG8 7AF Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    25 Grenville Gardens
    IG8 7AF Woodford Green
    Essex
    IrishAccountant22121890001
    NOYS, Terry
    27 Draycot Road
    E11 2NX London
    Amministratore
    27 Draycot Road
    E11 2NX London
    BritishCompany Director79489440001
    POLLOCK, Gillian Anne
    84 Speer Road
    KT7 0PP Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    84 Speer Road
    KT7 0PP Thames Ditton
    Surrey
    BritishManaging Director Europe2019030001
    ROBINSON, Timothy James
    Gibson Square
    N1 0RA London
    59
    United Kingdom
    Amministratore
    Gibson Square
    N1 0RA London
    59
    United Kingdom
    BritishDirector53265180003
    SPOONER, Julian Robert Archer
    301 Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    301 Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishGroup Chief Executive117770880001
    STOREY, John Michael
    23 Albert Street
    NW1 7LU London
    Amministratore
    23 Albert Street
    NW1 7LU London
    BritishCompany Director2019040004
    STUBLEY, David Peter
    78 Mexfield Road
    Putney
    SW15 2RQ London
    Amministratore
    78 Mexfield Road
    Putney
    SW15 2RQ London
    BritishAccount Director2019050001
    THOMAS, Michael Stuart
    Milton Lodge
    Bangers Road South
    SL0 0AA Iver
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Milton Lodge
    Bangers Road South
    SL0 0AA Iver
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChairman2019060004
    THORNTON, Alison
    21 Arlington Road
    KT6 6BW Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    21 Arlington Road
    KT6 6BW Surbiton
    Surrey
    BritishAccountant65307190001

    MEDIA AUDITS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of deposit
    Creato il 17 gen 2005
    Consegnato il 20 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All interest standing to the credit of an interest bearing account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Standard Life Assurance Company
    Transazioni
    • 20 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of securities
    Creato il 17 apr 2001
    Consegnato il 21 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge any stocks shares bonds warrants or other securities (certificated or uncertificated) from time to time relating to media audits sa together with all income derived from and rights attaching to the same.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of securities
    Creato il 17 apr 2001
    Consegnato il 21 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge any stocks shares bonds warrants or other securities (certificated or uncertificated) from time to time relating to media audits sl together with all income derived from and rights attaching to the same.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of securities
    Creato il 17 apr 2001
    Consegnato il 21 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge any stocks shares bonds warrants or other securities (certificated or uncertificated) from time to time relating to media audits gmbh together with all income derived from and rights attaching to the same.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 apr 2001
    Consegnato il 21 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 2001
    Consegnato il 21 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a part of 16 dufor place london t/no NGL513849. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 giu 1999
    Consegnato il 10 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 nov 1995
    Consegnato il 17 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 gen 1988
    Consegnato il 08 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over undertaking and all propety and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital with all buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 04 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MEDIA AUDITS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 mar 2010Inizio della liquidazione
    30 nov 2010Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Francis F A Wessely
    81 Station Road
    Marlow
    SL7 1NS Bucks
    Praticante
    81 Station Road
    Marlow
    SL7 1NS Bucks
    Peter James Hughes-Holland
    Rsm Tenon Restructuring
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Praticante
    Rsm Tenon Restructuring
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0