SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED

SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01243319
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Mha Macintyre Hudson 6th Floor
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALAN FARROW GROUP LIMITED23 lug 198723 lug 1987
    ALAN FARROW (PAPER SALES) LIMITED06 feb 197606 feb 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 lug 2022

    8 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Kathryn Anne Davenport come segretario in data 04 gen 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 lug 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da Old Mills Drighlington Bradford West Yorkshire BD11 1BY a C/O Mha Macintyre Hudson 6th Floor 2 London Wall Place London EC2Y 5AU in data 03 ago 2021

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2020

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2019

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2018

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2017

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Anna Carina Heilborn come amministratore in data 15 feb 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Olof Hager come amministratore in data 15 feb 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 dic 2015

    Stato del capitale al 23 dic 2015

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Lars John Rutegard come amministratore in data 22 giu 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Anna Carina Heilborn come amministratore in data 22 giu 2015

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GYLLENHAMMAR, Peter Jan Patrik
    6th Floor
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    C/O Mha Macintyre Hudson
    England
    Amministratore
    6th Floor
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    C/O Mha Macintyre Hudson
    England
    SwedenSwedishCompany Director200856740001
    HAGER, John Olof
    6th Floor
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    C/O Mha Macintyre Hudson
    England
    Amministratore
    6th Floor
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    C/O Mha Macintyre Hudson
    England
    SwedenSwedishManaging Director224855100001
    DAVENPORT, Kathryn Anne
    6th Floor
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    C/O Mha Macintyre Hudson
    England
    Segretario
    6th Floor
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    C/O Mha Macintyre Hudson
    England
    154635000001
    FEARNS, David
    10 Prince Wood Lane
    HD2 2DG Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    10 Prince Wood Lane
    HD2 2DG Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishAccountant50694840002
    LEVIS, Sue Jane Holden
    23 Legh Road
    Prestbury
    SK10 4HX Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    23 Legh Road
    Prestbury
    SK10 4HX Macclesfield
    Cheshire
    British54558780002
    THORNTON, Richard James
    The Old Farm
    Nant Alyn Road Rhydymwyn
    CH7 5HQ Mold
    Flintshire
    Segretario
    The Old Farm
    Nant Alyn Road Rhydymwyn
    CH7 5HQ Mold
    Flintshire
    BritishAccountant57845280001
    WEATHERSTONE, Andrew Paul
    6 Spring Farm Applehaigh Lane
    Notton
    WF4 2PT Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    6 Spring Farm Applehaigh Lane
    Notton
    WF4 2PT Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector86724380003
    FARROW, Alan Charles
    White Gables 10 Howard Drive
    Hale
    WA15 0LT Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    White Gables 10 Howard Drive
    Hale
    WA15 0LT Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director24228450001
    FEARNS, David
    10 Prince Wood Lane
    HD2 2DG Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Prince Wood Lane
    HD2 2DG Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant50694840002
    FERGUSON, Michael Alexander
    Emmanuel House
    Brettargh Drive
    LA1 5BN Lancaster
    Lancashire
    Amministratore
    Emmanuel House
    Brettargh Drive
    LA1 5BN Lancaster
    Lancashire
    United KingdomBritishManaging Director66192260001
    GIDDENS, Keith
    Dunkirk Lane
    PR26 7SP Leyland
    204
    Lancashire
    Amministratore
    Dunkirk Lane
    PR26 7SP Leyland
    204
    Lancashire
    BritishTechnical Director129004170001
    GREEN, Joan
    The Grannary Reed Hall Court
    Hammond Drive
    PR2 2GB Read
    Lancashire
    Amministratore
    The Grannary Reed Hall Court
    Hammond Drive
    PR2 2GB Read
    Lancashire
    BritishCommercial Director54389240001
    GYLLENHAMMAR, Peter Jan Patrik Valentin
    Drighlington
    BD11 1BY Bradford
    Old Mills
    West Yorkshire
    Amministratore
    Drighlington
    BD11 1BY Bradford
    Old Mills
    West Yorkshire
    SwedenSwedishDirector76805000001
    HALSTEAD, Roger
    Myerscough Road
    Mellor Brook
    BB2 7LB Blackburn
    1 Hawthorn Cottage
    Lancashire
    Amministratore
    Myerscough Road
    Mellor Brook
    BB2 7LB Blackburn
    1 Hawthorn Cottage
    Lancashire
    BritishCommercial Director129004340001
    HEILBORN, Anna Carina
    Drighlington
    BD11 1BY Bradford
    Old Mills
    West Yorkshire
    Amministratore
    Drighlington
    BD11 1BY Bradford
    Old Mills
    West Yorkshire
    SwedenSwedishCompany Director200857260001
    KNIGHTON, Ian
    The Granary Read Hall Court
    Hammond Drive Read
    BB12 7RU Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    The Granary Read Hall Court
    Hammond Drive Read
    BB12 7RU Burnley
    Lancashire
    BritishCompany Director24228460005
    LECKIE, Brian
    Cherrytree Farm
    Briestfield Road, Briestfield
    WF12 0NR Dewsbury
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cherrytree Farm
    Briestfield Road, Briestfield
    WF12 0NR Dewsbury
    West Yorkshire
    United KingdomBritishGroup Chief Executive47711920002
    PICKERING, Alan
    Fox Clough Barn Birchenlee Lane
    BB8 8HL Colne
    Lancashire
    Amministratore
    Fox Clough Barn Birchenlee Lane
    BB8 8HL Colne
    Lancashire
    BritishChemist46502390001
    RUTEGARD, Lars John
    Drighlington
    BD11 1BY Bradford
    Old Mills
    West Yorkshire
    Amministratore
    Drighlington
    BD11 1BY Bradford
    Old Mills
    West Yorkshire
    SwedenSwedishDirector180685960001
    SCAIFE, Terence, Dr
    Fintry Fairmoor
    NE61 3JL Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Fintry Fairmoor
    NE61 3JL Morpeth
    Northumberland
    BritishDivisional Executive61529090001
    SHAW, Clive Michael
    Grey Cedars Cartworth Road
    Holmfirth
    HD7 1RQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Grey Cedars Cartworth Road
    Holmfirth
    HD7 1RQ Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director9522360001
    TURNER, Deborah
    Wisteria Drive
    Lower Darwen
    BB3 0QY Darwen
    31
    Lancashire
    Amministratore
    Wisteria Drive
    Lower Darwen
    BB3 0QY Darwen
    31
    Lancashire
    BritishAdministration Director129004000001
    WEATHERSTONE, Andrew Paul
    6 Spring Farm Applehaigh Lane
    Notton
    WF4 2PT Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Spring Farm Applehaigh Lane
    Notton
    WF4 2PT Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director86724380003
    WILLIAMS, Andrew John
    25 Palesides Avenue
    Ossett
    WF5 9NL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    25 Palesides Avenue
    Ossett
    WF5 9NL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant124172140001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Peter Gyllenhammar
    6th Floor
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    C/O Mha Macintyre Hudson
    England
    06 apr 2016
    6th Floor
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    C/O Mha Macintyre Hudson
    England
    No
    Nazionalità: Swedish
    Paese di residenza: Sweden
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 giu 2010
    Consegnato il 02 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A charge over shares
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 10 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the charged securities referred to in the schedule to the share charge namely 800 ordinary shares of £1 each held by the company in the share capital together with all related rights. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 10 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2008
    • 19 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 giu 2007
    Consegnato il 06 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 22 set 2008
    • 05 dic 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    Creato il 16 ott 2001
    Consegnato il 23 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The stocks, shares, bonds, debentures or other securities deposited with or transferred to the chargee or trustees for or nominees of the chargee being 1,999 £1 ordinary shares of blackburn gravure limited, 401,999 £1 ordinary shares of darwen coatings and adhesices limited, 2,000 £1 ordinary shares of speciality coatings (darwen) limited.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 nov 2000
    Consegnato il 20 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and all monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever except any moneys or liabilities due or to become due by such company as guarantor for the chargor.
    Brevi particolari
    F/H property at moorside and south end mills dewhurst street darwen t/nos LA590425 LA519762 and LA553274. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 06 ago 1996
    Consegnato il 14 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 14 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 22 set 2008
    Legal mortgage
    Creato il 09 feb 1988
    Consegnato il 16 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The whitemill and adjoining land and buildings off denhurst street darwen lincolnshire t/no la 519762 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 31 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 11 apr 1986
    Consegnato il 17 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/hold and l/hold properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefit of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 apr 2023Data prevista di scioglimento
    23 lug 2021Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Georgina Marie Eason
    Mha Macintyre Hudson Llp 6th Floor, 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Praticante
    Mha Macintyre Hudson Llp 6th Floor, 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Michael Colin John Sanders
    6th Floor, 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Praticante
    6th Floor, 2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0