SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED
Panoramica
Nome della società | SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01243319 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Mha Macintyre Hudson 6th Floor 2 London Wall Place EC2Y 5AU London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ALAN FARROW GROUP LIMITED | 23 lug 1987 | 23 lug 1987 |
ALAN FARROW (PAPER SALES) LIMITED | 06 feb 1976 | 06 feb 1976 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 lug 2022 | 8 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kathryn Anne Davenport come segretario in data 04 gen 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Old Mills Drighlington Bradford West Yorkshire BD11 1BY a C/O Mha Macintyre Hudson 6th Floor 2 London Wall Place London EC2Y 5AU in data 03 ago 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2020 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2019 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2018 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2017 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Anna Carina Heilborn come amministratore in data 15 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Olof Hager come amministratore in data 15 feb 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2016 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2015 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Lars John Rutegard come amministratore in data 22 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Anna Carina Heilborn come amministratore in data 22 giu 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLLENHAMMAR, Peter Jan Patrik | Amministratore | 6th Floor 2 London Wall Place EC2Y 5AU London C/O Mha Macintyre Hudson England | Sweden | Swedish | Company Director | 200856740001 | ||||
HAGER, John Olof | Amministratore | 6th Floor 2 London Wall Place EC2Y 5AU London C/O Mha Macintyre Hudson England | Sweden | Swedish | Managing Director | 224855100001 | ||||
DAVENPORT, Kathryn Anne | Segretario | 6th Floor 2 London Wall Place EC2Y 5AU London C/O Mha Macintyre Hudson England | 154635000001 | |||||||
FEARNS, David | Segretario | 10 Prince Wood Lane HD2 2DG Huddersfield West Yorkshire | British | Accountant | 50694840002 | |||||
LEVIS, Sue Jane Holden | Segretario | 23 Legh Road Prestbury SK10 4HX Macclesfield Cheshire | British | 54558780002 | ||||||
THORNTON, Richard James | Segretario | The Old Farm Nant Alyn Road Rhydymwyn CH7 5HQ Mold Flintshire | British | Accountant | 57845280001 | |||||
WEATHERSTONE, Andrew Paul | Segretario | 6 Spring Farm Applehaigh Lane Notton WF4 2PT Wakefield West Yorkshire | British | Director | 86724380003 | |||||
FARROW, Alan Charles | Amministratore | White Gables 10 Howard Drive Hale WA15 0LT Altrincham Cheshire | British | Company Director | 24228450001 | |||||
FEARNS, David | Amministratore | 10 Prince Wood Lane HD2 2DG Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 50694840002 | ||||
FERGUSON, Michael Alexander | Amministratore | Emmanuel House Brettargh Drive LA1 5BN Lancaster Lancashire | United Kingdom | British | Managing Director | 66192260001 | ||||
GIDDENS, Keith | Amministratore | Dunkirk Lane PR26 7SP Leyland 204 Lancashire | British | Technical Director | 129004170001 | |||||
GREEN, Joan | Amministratore | The Grannary Reed Hall Court Hammond Drive PR2 2GB Read Lancashire | British | Commercial Director | 54389240001 | |||||
GYLLENHAMMAR, Peter Jan Patrik Valentin | Amministratore | Drighlington BD11 1BY Bradford Old Mills West Yorkshire | Sweden | Swedish | Director | 76805000001 | ||||
HALSTEAD, Roger | Amministratore | Myerscough Road Mellor Brook BB2 7LB Blackburn 1 Hawthorn Cottage Lancashire | British | Commercial Director | 129004340001 | |||||
HEILBORN, Anna Carina | Amministratore | Drighlington BD11 1BY Bradford Old Mills West Yorkshire | Sweden | Swedish | Company Director | 200857260001 | ||||
KNIGHTON, Ian | Amministratore | The Granary Read Hall Court Hammond Drive Read BB12 7RU Burnley Lancashire | British | Company Director | 24228460005 | |||||
LECKIE, Brian | Amministratore | Cherrytree Farm Briestfield Road, Briestfield WF12 0NR Dewsbury West Yorkshire | United Kingdom | British | Group Chief Executive | 47711920002 | ||||
PICKERING, Alan | Amministratore | Fox Clough Barn Birchenlee Lane BB8 8HL Colne Lancashire | British | Chemist | 46502390001 | |||||
RUTEGARD, Lars John | Amministratore | Drighlington BD11 1BY Bradford Old Mills West Yorkshire | Sweden | Swedish | Director | 180685960001 | ||||
SCAIFE, Terence, Dr | Amministratore | Fintry Fairmoor NE61 3JL Morpeth Northumberland | British | Divisional Executive | 61529090001 | |||||
SHAW, Clive Michael | Amministratore | Grey Cedars Cartworth Road Holmfirth HD7 1RQ Huddersfield West Yorkshire | British | Company Director | 9522360001 | |||||
TURNER, Deborah | Amministratore | Wisteria Drive Lower Darwen BB3 0QY Darwen 31 Lancashire | British | Administration Director | 129004000001 | |||||
WEATHERSTONE, Andrew Paul | Amministratore | 6 Spring Farm Applehaigh Lane Notton WF4 2PT Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 86724380003 | ||||
WILLIAMS, Andrew John | Amministratore | 25 Palesides Avenue Ossett WF5 9NL Wakefield West Yorkshire | England | British | Accountant | 124172140001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mr Peter Gyllenhammar | 06 apr 2016 | 6th Floor 2 London Wall Place EC2Y 5AU London C/O Mha Macintyre Hudson England | No |
Nazionalità: Swedish Paese di residenza: Sweden | |||
Natura del controllo
|
SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 24 giu 2010 Consegnato il 02 lug 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A charge over shares | Creato il 30 ott 2008 Consegnato il 10 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of first fixed charge the charged securities referred to in the schedule to the share charge namely 800 ordinary shares of £1 each held by the company in the share capital together with all related rights. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 28 giu 2007 Consegnato il 06 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities | Creato il 16 ott 2001 Consegnato il 23 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The stocks, shares, bonds, debentures or other securities deposited with or transferred to the chargee or trustees for or nominees of the chargee being 1,999 £1 ordinary shares of blackburn gravure limited, 401,999 £1 ordinary shares of darwen coatings and adhesices limited, 2,000 £1 ordinary shares of speciality coatings (darwen) limited.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 10 nov 2000 Consegnato il 20 nov 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and all monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever except any moneys or liabilities due or to become due by such company as guarantor for the chargor. | |
Brevi particolari F/H property at moorside and south end mills dewhurst street darwen t/nos LA590425 LA519762 and LA553274. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 06 ago 1996 Consegnato il 14 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 09 feb 1988 Consegnato il 16 feb 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The whitemill and adjoining land and buildings off denhurst street darwen lincolnshire t/no la 519762 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 11 apr 1986 Consegnato il 17 apr 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all f/hold and l/hold properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefit of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0