DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED
Panoramica
Nome della società | DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01244813 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
- Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione
- Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
Dove si trova DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
NEXTIRAONE SERVICES LIMITED | 01 nov 2005 | 01 nov 2005 |
GFI INFORMATICS LIMITED | 02 gen 2001 | 02 gen 2001 |
ECS LIMITED | 20 mar 1991 | 20 mar 1991 |
ENGINEERING COMPUTER SERVICES LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
LOGELTA LIMITED | 17 feb 1976 | 17 feb 1976 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Anne Colette Jacqueline Thonon il 29 ago 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Paul Francis Cooper come amministratore in data 21 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Calvin Paul Wesley Goom come amministratore in data 21 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 30 set 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2014 al 30 set 2014 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Paul Francis Cooper come segretario in data 02 feb 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Calvin Paul Wesley Goom come amministratore in data 02 feb 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Steven Murray Skakel come amministratore in data 02 feb 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Steven Murray Skakel come segretario in data 02 feb 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed nextiraone services LIMITED\certificate issued on 24/04/14 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Anne Colette Thonon come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Andrew David Coulsen come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di David Winn come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOPER, Paul Francis | Segretario | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | 194607110001 | |||||||
COOPER, Paul Francis | Amministratore | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | England | British | Chief Operating Officer | 206909290001 | ||||
COULSEN, Andrew David | Amministratore | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | Switzerland | British | Chief Executive Officer, Europe | 87390090003 | ||||
THONON, Anne Colette Jacqueline | Amministratore | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | Luxembourg | Belgian | Chief Financial Officer, Europe | 146053560002 | ||||
JUGGINS, John Kenneth | Segretario | Sherbourne Old Forge Gardens Inn Lane DY11 7TA Hartlebury Worcestershire | British | 29806590001 | ||||||
PENTER, Nicholas Trevor | Segretario | 8 Cotsalls Fair Oak SO50 7HP Eastleigh Hampshire | British | Director | 81327550001 | |||||
SKAKEL, Steven Murray | Segretario | 29 Earlswood Road Dorridge B93 8RD Solihull West Midlands | British | Director | 29806610004 | |||||
DOWNIE, Ian Michael Stuart | Amministratore | Beech Hill Easton SO21 1ED Winchester Hampshire | United Kingdom | British | Director | 81327720001 | ||||
DUNACHIE, Robert | Amministratore | 32 Torrance Close Branston DE14 3GX Burton On Trent Staffordshire | British | Technical Director | 55063250001 | |||||
FOSTER, David | Amministratore | Hillside Farm Hoggrills End Coleshill B46 2DD Birmingham West Midlands | British | Director | 6796160001 | |||||
GIBBS, Simon Spencer | Amministratore | Weedon Lodge Farm House East End HP22 4NJ Weedon Buckinghamshire | England | British | Director | 90259420001 | ||||
GOOM, Calvin Paul Wesley | Amministratore | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | United Kingdom | British | Managing Director | 194584790001 | ||||
JUGGINS, John Kenneth | Amministratore | Sherbourne Old Forge Gardens Inn Lane DY11 7TA Hartlebury Worcestershire | United Kingdom | British | Director | 29806590001 | ||||
LAMB, Stephen Albert | Amministratore | 91a Milby Drive CV11 6GD Nuneaton Warwickshire | England | British | Director | 21645020002 | ||||
MUFFAT-ES-JACQUES, Philippe | Amministratore | 18 Chemin De La Faucillee 1291 Commueny Switzerland | French | Company Director | 64733550002 | |||||
PARKINSON, Andrew Michael Reay | Amministratore | Tadlow House Tadlow SG8 0EL Royston Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 3098750001 | |||||
PENTER, Nicholas Trevor | Amministratore | 8 Cotsalls Fair Oak SO50 7HP Eastleigh Hampshire | United Kingdom | British | Director | 81327550001 | ||||
ROE, Colin | Amministratore | 4 Axminster Close CV11 6YP Nuneaton Warwickshire | British | Operations Director | 55060400001 | |||||
SKAKEL, Steven Murray | Amministratore | 29 Earlswood Road Dorridge B93 8RD Solihull West Midlands | England | British | Director | 29806610004 | ||||
SKAKEL, Steven Murray | Amministratore | 29 Earlswood Road Dorridge B93 8RD Solihull West Midlands | England | British | Operations Director | 29806610004 | ||||
THOMAS, Aubrey John Christopher | Amministratore | Stirtloe House Stirtloe PE18 9XW Huntingdon Cambridgeshire | British | Chairman D C E O | 3747410001 | |||||
TORDJMAN, Jacques | Amministratore | 55 Avenue Simon Bolivar FOREIGN Paris 75019 France | French | Company Director | 64733720001 | |||||
WINN, David Charles | Amministratore | NL1016 Ex Amsterdam Keizersgracht 302 1v Netherlands | The Netherlands | Irish | None | 150733800001 | ||||
NEXTIRAONE EUROPE HOLDINGS BV | Amministratore | Laan Van's-Gravenmade 24 2495 Aj's Gravenhage Netherlands | 114409680001 | |||||||
RKO MANAGEMENT AND INVESTMENT B.V. | Amministratore | Laan Van `S-Gravenmade 24 `S-Gravenhage 2495 Aj Netherlands | 117640790001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension Data Communications Uk Limited | 06 apr 2016 | Lichfield South, Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Darwin House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 22 dic 2005 Consegnato il 29 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The real property any goodwill the shares all dividends interest and other monies the proceeds of insurance floating charge the companys undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security deposit deed | Creato il 12 mar 2002 Consegnato il 16 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The sum of £10,000.00 (including any replacement thereof or accretion thereto). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 dic 2000 Consegnato il 27 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 mag 1994 Consegnato il 25 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 mar 1994 Consegnato il 17 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Single debenture | Creato il 02 mar 1992 Consegnato il 06 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 nov 1986 Consegnato il 24 nov 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Buildings & fixtues. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 15 lug 1986 Consegnato il 24 lug 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of charge | Creato il 19 mar 1985 Consegnato il 09 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account of the company with the bank designated client account - teeside automation services limited no. 60354007. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental charge | Creato il 08 set 1982 Consegnato il 24 set 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the existanc, security docs. Specified in the second schedule to the charge | |
Brevi particolari Fixed charge on the book and other debts due and owing to the company both present & future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 18 gen 1980 Consegnato il 07 feb 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Fixed charge upon the 60 shares of £1 each in the capital of engineering computer services (fe) limited with the bonus shares which may be alloted to the holder thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 gen 1980 Consegnato il 21 gen 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, stock, uncalled capital, work in progress, pre payments investments and cash of the company together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery (please see doc m 23). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0