DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED

DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01244813
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?

    • Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione
    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NEXTIRAONE SERVICES LIMITED01 nov 200501 nov 2005
    GFI INFORMATICS LIMITED02 gen 200102 gen 2001
    ECS LIMITED20 mar 199120 mar 1991
    ENGINEERING COMPUTER SERVICES LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    LOGELTA LIMITED17 feb 197617 feb 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Anne Colette Jacqueline Thonon il 29 ago 2016

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Francis Cooper come amministratore in data 21 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Calvin Paul Wesley Goom come amministratore in data 21 mar 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 dic 2015

    Stato del capitale al 14 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 set 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2014 al 30 set 2014

    3 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Francis Cooper come segretario in data 02 feb 2015

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Calvin Paul Wesley Goom come amministratore in data 02 feb 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Murray Skakel come amministratore in data 02 feb 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven Murray Skakel come segretario in data 02 feb 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 nov 2014

    Stato del capitale al 14 nov 2014

    • Capitale: GBP 7,073,303
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed nextiraone services LIMITED\certificate issued on 24/04/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name24 apr 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 24 apr 2014

    RES15
    change-of-name24 apr 2014

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Nomina di Anne Colette Thonon come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Andrew David Coulsen come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Winn come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COOPER, Paul Francis
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    194607110001
    COOPER, Paul Francis
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishChief Operating Officer206909290001
    COULSEN, Andrew David
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    SwitzerlandBritishChief Executive Officer, Europe87390090003
    THONON, Anne Colette Jacqueline
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    LuxembourgBelgianChief Financial Officer, Europe146053560002
    JUGGINS, John Kenneth
    Sherbourne
    Old Forge Gardens Inn Lane
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    Segretario
    Sherbourne
    Old Forge Gardens Inn Lane
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    British29806590001
    PENTER, Nicholas Trevor
    8 Cotsalls
    Fair Oak
    SO50 7HP Eastleigh
    Hampshire
    Segretario
    8 Cotsalls
    Fair Oak
    SO50 7HP Eastleigh
    Hampshire
    BritishDirector81327550001
    SKAKEL, Steven Murray
    29 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    Segretario
    29 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    BritishDirector29806610004
    DOWNIE, Ian Michael Stuart
    Beech Hill
    Easton
    SO21 1ED Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Beech Hill
    Easton
    SO21 1ED Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector81327720001
    DUNACHIE, Robert
    32 Torrance Close
    Branston
    DE14 3GX Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    32 Torrance Close
    Branston
    DE14 3GX Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishTechnical Director55063250001
    FOSTER, David
    Hillside Farm Hoggrills End
    Coleshill
    B46 2DD Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Hillside Farm Hoggrills End
    Coleshill
    B46 2DD Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector6796160001
    GIBBS, Simon Spencer
    Weedon Lodge Farm House
    East End
    HP22 4NJ Weedon
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Weedon Lodge Farm House
    East End
    HP22 4NJ Weedon
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector90259420001
    GOOM, Calvin Paul Wesley
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    United KingdomBritishManaging Director194584790001
    JUGGINS, John Kenneth
    Sherbourne
    Old Forge Gardens Inn Lane
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    Amministratore
    Sherbourne
    Old Forge Gardens Inn Lane
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector29806590001
    LAMB, Stephen Albert
    91a Milby Drive
    CV11 6GD Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    91a Milby Drive
    CV11 6GD Nuneaton
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector21645020002
    MUFFAT-ES-JACQUES, Philippe
    18 Chemin De La Faucillee
    1291 Commueny
    Switzerland
    Amministratore
    18 Chemin De La Faucillee
    1291 Commueny
    Switzerland
    FrenchCompany Director64733550002
    PARKINSON, Andrew Michael Reay
    Tadlow House
    Tadlow
    SG8 0EL Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tadlow House
    Tadlow
    SG8 0EL Royston
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant3098750001
    PENTER, Nicholas Trevor
    8 Cotsalls
    Fair Oak
    SO50 7HP Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    8 Cotsalls
    Fair Oak
    SO50 7HP Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector81327550001
    ROE, Colin
    4 Axminster Close
    CV11 6YP Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    4 Axminster Close
    CV11 6YP Nuneaton
    Warwickshire
    BritishOperations Director55060400001
    SKAKEL, Steven Murray
    29 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    29 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector29806610004
    SKAKEL, Steven Murray
    29 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    29 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishOperations Director29806610004
    THOMAS, Aubrey John Christopher
    Stirtloe House Stirtloe
    PE18 9XW Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Stirtloe House Stirtloe
    PE18 9XW Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishChairman D C E O3747410001
    TORDJMAN, Jacques
    55 Avenue Simon Bolivar
    FOREIGN Paris
    75019
    France
    Amministratore
    55 Avenue Simon Bolivar
    FOREIGN Paris
    75019
    France
    FrenchCompany Director64733720001
    WINN, David Charles
    NL1016 Ex Amsterdam
    Keizersgracht 302 1v
    Netherlands
    Amministratore
    NL1016 Ex Amsterdam
    Keizersgracht 302 1v
    Netherlands
    The NetherlandsIrishNone150733800001
    NEXTIRAONE EUROPE HOLDINGS BV
    Laan Van's-Gravenmade 24
    2495 Aj's
    Gravenhage
    Netherlands
    Amministratore
    Laan Van's-Gravenmade 24
    2495 Aj's
    Gravenhage
    Netherlands
    114409680001
    RKO MANAGEMENT AND INVESTMENT B.V.
    Laan Van `S-Gravenmade 24
    `S-Gravenhage
    2495 Aj
    Netherlands
    Amministratore
    Laan Van `S-Gravenmade 24
    `S-Gravenhage
    2495 Aj
    Netherlands
    117640790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dimension Data Communications Uk Limited
    Lichfield South, Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Darwin House
    England
    06 apr 2016
    Lichfield South, Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Darwin House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House, England & Wales
    Numero di registrazione4036009
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 29 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The real property any goodwill the shares all dividends interest and other monies the proceeds of insurance floating charge the companys undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 29 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deposit deed
    Creato il 12 mar 2002
    Consegnato il 16 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £10,000.00 (including any replacement thereof or accretion thereto).
    Persone aventi diritto
    • Sir John Auld Mactaggart Bt & Lady Caroline Emma Mactaggart as Trustees of the Ian Mactaggarttrust and Sir John Auld Mactaggart Bt Trustees of the Mactaggart Third Fund
    Transazioni
    • 16 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 dic 2000
    Consegnato il 27 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 mag 1994
    Consegnato il 25 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mar 1994
    Consegnato il 17 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 02 mar 1992
    Consegnato il 06 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 nov 1986
    Consegnato il 24 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Buildings & fixtues.
    Persone aventi diritto
    • Robert Fleming & Co LTD.
    Transazioni
    • 24 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 15 lug 1986
    Consegnato il 24 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    Letter of charge
    Creato il 19 mar 1985
    Consegnato il 09 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account of the company with the bank designated client account - teeside automation services limited no. 60354007.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental charge
    Creato il 08 set 1982
    Consegnato il 24 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the existanc, security docs. Specified in the second schedule to the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge on the book and other debts due and owing to the company both present & future.
    Persone aventi diritto
    • Technical Development Capital Limited
    Transazioni
    • 24 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 18 gen 1980
    Consegnato il 07 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge upon the 60 shares of £1 each in the capital of engineering computer services (fe) limited with the bonus shares which may be alloted to the holder thereof.
    Persone aventi diritto
    • Technical Development Capital Limited
    Transazioni
    • 07 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 08 gen 1980
    Consegnato il 21 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, stock, uncalled capital, work in progress, pre payments investments and cash of the company together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery (please see doc m 23).
    Persone aventi diritto
    • Technical Development Capital Limited.
    Transazioni
    • 21 gen 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0