BAUER ADVERTISING LIMITED

BAUER ADVERTISING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBAUER ADVERTISING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01246778
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BAUER ADVERTISING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BAUER ADVERTISING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BAUER ADVERTISING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EMAP ADVERTISING LIMITED27 mar 200027 mar 2000
    EMAP CONSUMER ADVERTISING LIMITED08 feb 200008 feb 2000
    EMAP ADVERTISING SALES LIMITED22 dic 199922 dic 1999
    COACHMART LIMITED11 apr 198611 apr 1986
    RYLAND PUBLISHING GROUP LIMITED 31 dic 198331 dic 1983
    T.D.J.K. LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    K.I.T. CAR HIRE LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    RELCOLINE LIMITED02 mar 197602 mar 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di BAUER ADVERTISING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per BAUER ADVERTISING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 feb 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 07 ott 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Deidre Ann Ford come amministratore in data 19 set 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Jane Vickery il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Keenan il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Deidre Ann Ford il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Bauer Group Secretariat Limited il 25 set 2018

    1 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Gary Max Beddard come amministratore in data 19 mag 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Gary Max Beddard il 30 set 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Deidre Ann Ford il 30 set 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Jane Vickery il 30 set 2016

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Jane Vickery il 14 lug 2016

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di BAUER ADVERTISING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Segretario
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione00944753
    159023720001
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish119137220004
    ELLIOT, Richard Emmerson
    Cherry Trees
    Main Street
    PE9 3PA Wilsthorpe
    Lincolnshire
    Segretario
    Cherry Trees
    Main Street
    PE9 3PA Wilsthorpe
    Lincolnshire
    British40591070002
    ELSDON, Kate
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    Segretario
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    British107227940002
    FOLLAND, Nicholas James
    Strethall House
    Strethall
    CB11 4XJ Saffron Walden
    Essex
    Segretario
    Strethall House
    Strethall
    CB11 4XJ Saffron Walden
    Essex
    British73711450003
    HENSON, Mark Richard
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    Segretario
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    British104630800001
    NAREBOR, Torugbene Eniyekeye
    10 Portland Road
    ME7 2NP Gillingham
    Kent
    Segretario
    10 Portland Road
    ME7 2NP Gillingham
    Kent
    British120147010002
    RAY, Richard Bardrick
    9 Meadenvale
    Oxney Road
    PE1 5PN Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    9 Meadenvale
    Oxney Road
    PE1 5PN Peterborough
    Cambridgeshire
    British47986390001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    Sennen
    Grange Road
    MK43 7EU Felmersham
    North Bedfordshire
    Segretario
    Sennen
    Grange Road
    MK43 7EU Felmersham
    North Bedfordshire
    British16754910001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Segretario
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    38545840001
    BARKER, Caroline Jane
    43 Connaught Gardens
    Muswell Hill
    N10 3LG London
    Amministratore
    43 Connaught Gardens
    Muswell Hill
    N10 3LG London
    British68526560002
    BEDDARD, Gary Max
    15 Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    15 Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish127820580002
    BLEAKLEY, Tim James
    46 Gondar Gardens
    NW6 1HG London
    Amministratore
    46 Gondar Gardens
    NW6 1HG London
    United KingdomBritish153582240001
    COLIGAN, Theresa
    28 Nicholas Court
    Corney Reach Way Chiswick
    W4 2TS London
    Amministratore
    28 Nicholas Court
    Corney Reach Way Chiswick
    W4 2TS London
    British33081440002
    DUDLEY, John Mark
    124 Eagle Way
    Hampton Vale
    PE7 8EA Peterborough
    Amministratore
    124 Eagle Way
    Hampton Vale
    PE7 8EA Peterborough
    UkBritish101918420001
    ELLIOT, Richard Emmerson
    Cherry Trees
    Main Street
    PE9 3PA Wilsthorpe
    Lincolnshire
    Amministratore
    Cherry Trees
    Main Street
    PE9 3PA Wilsthorpe
    Lincolnshire
    British40591070002
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    United KingdomBritish109666380002
    GOODCHILD, David Paul
    3 Weston Park Close
    KT7 0HJ Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    3 Weston Park Close
    KT7 0HJ Thames Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish99824680001
    HARRIS, Julie Louise
    36 Glasslyn Road
    Crouch End
    N8 8RH London
    Uk
    Amministratore
    36 Glasslyn Road
    Crouch End
    N8 8RH London
    Uk
    British68748830001
    HIPKISS, David
    6 Woodgate Avenue
    EN6 4EW Coopers Lane Road
    Potters Bar
    Amministratore
    6 Woodgate Avenue
    EN6 4EW Coopers Lane Road
    Potters Bar
    United KingdomBritish192804770001
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Amministratore
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    UkBritish72256160002
    JOSEPH, David
    The Cottage Home Farm
    Leicester Road
    PE8 6NL Thornhaugh
    Amministratore
    The Cottage Home Farm
    Leicester Road
    PE8 6NL Thornhaugh
    United KingdomBritish99583300001
    KING, David Truman
    50 Bracken Avenue
    Balham
    SW12 8BH London
    Uk
    Amministratore
    50 Bracken Avenue
    Balham
    SW12 8BH London
    Uk
    British68825840003
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    British4250810002
    MCALEENAN, Patrick David
    78 Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    Amministratore
    78 Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    EnglandBritish14226510001
    MOLONEY, Thomas Charles
    20 Queen Elizabeths Walk
    N16 0HX London
    Amministratore
    20 Queen Elizabeths Walk
    N16 0HX London
    United KingdomBritish15672060004
    NEWBOLD, Stephen Anthony
    34 Kings Hall Road
    BR3 1LU Beckenham
    Kent
    Amministratore
    34 Kings Hall Road
    BR3 1LU Beckenham
    Kent
    British64832170001
    ORMSON, Andrew Forrester
    41 Chudleigh Road
    TW2 7QP Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    41 Chudleigh Road
    TW2 7QP Twickenham
    Middlesex
    British63113360002
    PHILLIPS, Alison Barbara
    The Gatehouse 1 Rhymers Gate
    Wyton
    PE17 2JR Huntingdon
    Amministratore
    The Gatehouse 1 Rhymers Gate
    Wyton
    PE17 2JR Huntingdon
    UkBritish61837750001
    RICH, Marcus Alvin
    Moor End
    Great Sampford
    CB10 2RQ Saffron Walden
    Whitehouse
    Essex
    Amministratore
    Moor End
    Great Sampford
    CB10 2RQ Saffron Walden
    Whitehouse
    Essex
    United KingdomBritish156496600001
    ROBERTS, Lorendana Elena
    5 Montpelier Rise
    NW11 9SS London
    Amministratore
    5 Montpelier Rise
    NW11 9SS London
    British68354410002
    SCHOONMAKER, Timothy
    62 Wimpole Street
    W1G 8AJ London
    Amministratore
    62 Wimpole Street
    W1G 8AJ London
    EnglandAmerican103614790001
    STANTON, Matthew Adam
    27 Meadway
    AL5 1JN Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    27 Meadway
    AL5 1JN Harpenden
    Hertfordshire
    British95140390001
    TOUMAZIS, Thomas
    1 Linnell Drive
    NW11 7LP London
    Amministratore
    1 Linnell Drive
    NW11 7LP London
    British59507190001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BAUER ADVERTISING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06 apr 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione08453545
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BAUER ADVERTISING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 22 nov 1984
    Consegnato il 29 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    64/74 holderness road hull and 6, 8 and 10 field st hull humberside t/n:- hs 92664.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 25 lug 1984
    Consegnato il 28 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargees
    Brevi particolari
    One new heidelburg four colour offset press model movp. (For full details see doc no M33).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    • Lloyds Bowmaker Leasing Limited
    • Lloyds Bowmaker Equipment Leasing Limited
    Transazioni
    • 28 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1983
    Consegnato il 02 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 22 & 23 queen street hull humberside title no:- hs 23135.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1983
    Consegnato il 02 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H. 33 humber street hull humberside title no:- hs 26283.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1983
    Consegnato il 02 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H. 27 queen street hull humberside title no;- hs 60980.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1983
    Consegnato il 02 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H. 24 queen street hull humberside title no. Hs 59724.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1983
    Consegnato il 02 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H. 22, 23 & 24 blackfriargate hull humberside title no:- hs 8361.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1983
    Consegnato il 02 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H. 25 & 26 queen street hull humberside title no:- hs 49454.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 giu 1983
    Consegnato il 07 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 11 feb 1983
    Consegnato il 16 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - 27 queen street hull, north humberside, T.n - hs 60980.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 11 feb 1983
    Consegnato il 16 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - 33 humber street, hull, north humberside T.n- hs 26283.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 ott 1981
    Consegnato il 19 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 24 queen street, hull north humberside title no hs 59724.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 set 1981
    Consegnato il 15 set 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 22 & 23 queen street, kingston upon hull. Hs 23135.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 set 1981
    Consegnato il 15 set 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 25 & 26 queen street, hull hs 49454.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0