CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED

CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01256947
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineF10.2

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2012 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 giu 2012

    Stato del capitale al 01 giu 2012

    • Capitale: GBP 600
    SH01

    Cessazione della carica di Nicholas Molyneux come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew Hannan come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Sean Emmett come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Joanna Boydell come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Chris Yates come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di David Cashman come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Hannan come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di William Rollason come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Cashman come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 nov 2009 al 31 dic 2009

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOYDELL, Joanna
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish164373820001
    EMMETT, Sean Robert
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish152701300001
    YATES, Chris Paul
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish152699330001
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    British48224770001
    FISHER, Raymond Keith
    10 Tewkesbury Close
    Abbey Court
    CW10 9HT Middlewich
    Cheshire
    Segretario
    10 Tewkesbury Close
    Abbey Court
    CW10 9HT Middlewich
    Cheshire
    British42200590001
    HOPE, Malcolm Peter
    The Hollies Dodds Green Lane
    Aston
    CW5 8DP Nantwich
    Cheshire
    Segretario
    The Hollies Dodds Green Lane
    Aston
    CW5 8DP Nantwich
    Cheshire
    British16903560001
    MOLYNEUX, Nicholas John
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    British93529300001
    CASHMAN, David Peter Charles
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish151553190001
    CHURCHILL, Roger
    61 Sapcote Road
    Burbage
    LE10 2AS Hinckley
    Leicestershire
    Amministratore
    61 Sapcote Road
    Burbage
    LE10 2AS Hinckley
    Leicestershire
    British48957720002
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish48224770001
    FISHER, Raymond Keith
    10 Tewkesbury Close
    Abbey Court
    CW10 9HT Middlewich
    Cheshire
    Amministratore
    10 Tewkesbury Close
    Abbey Court
    CW10 9HT Middlewich
    Cheshire
    United KingdomBritish42200590001
    GIDDINGS, Michael John
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    British105128310002
    HANNAN, Andrew
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish153976980001
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish116885790001
    HOPE, Eleanor Josephine
    The Hollies Dodds Green Lane
    Aston
    CW5 8DP Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Hollies Dodds Green Lane
    Aston
    CW5 8DP Nantwich
    Cheshire
    British26333700001
    HOPE, Malcolm Peter
    The Hollies Dodds Green Lane
    Aston
    CW5 8DP Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Hollies Dodds Green Lane
    Aston
    CW5 8DP Nantwich
    Cheshire
    British16903560001
    REDPATH, James
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    Amministratore
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    EnglandBritish123915050001
    RIORDAN, Peter Joseph
    73 Fairfax Avenue
    Ewell
    KT17 2QQ Epsom
    Surrey
    Amministratore
    73 Fairfax Avenue
    Ewell
    KT17 2QQ Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish106574800001
    ROLLASON, William Peter
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    United KingdomBritish67354680003
    YATES, Trevor
    11 Abingdon Close Telford Estate
    SY2 5XF Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    11 Abingdon Close Telford Estate
    SY2 5XF Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish25162190001

    CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 30 ago 2007
    Consegnato il 17 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land investments equipment book debts credit balanaces intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations in surances and other assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A supplemental deed
    Creato il 07 giu 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 apr 2007
    Consegnato il 19 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 lug 1998
    Consegnato il 28 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 lug 1998
    Consegnato il 28 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 ott 1982
    Consegnato il 29 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charge on undertaking and all property andassets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 lug 1981
    Consegnato il 24 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 265 edleston road, crewe, cheshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 10 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 lug 1981
    Consegnato il 24 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 263 edleston road, crewe, cheshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 10 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 lug 1981
    Consegnato il 24 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    76/78 prince's street stockport, greater manchester title no:- GM39143. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 10 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 apr 2013Data della petizione
    17 giu 2013Inizio della liquidazione
    31 mar 2014Conclusione della liquidazione
    07 lug 2014Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Leicester
    4th Floor
    Wellington House
    LE1 6HL Wellington Street
    Leicester
    Praticante
    4th Floor
    Wellington House
    LE1 6HL Wellington Street
    Leicester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0