PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED

PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01258241
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED?

    • (6521) /

    Dove si trova PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BSM LIMITED17 ott 200017 ott 2000
    BSM HOLDINGS LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    TAURUS VEHICLE LEASING LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    VAZMOSS LIMITED12 mag 197612 mag 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 gen 2016

    16 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 gen 2015

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 gen 2014

    14 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 gen 2013

    28 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 giu 2012

    20 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 dic 2011

    20 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 lug 2011

    27 pagine2.24B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed bsm LIMITED\certificate issued on 31/03/11
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name31 mar 2011

    Risoluzione di cambio di nome della società il 31 gen 2011

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Risultato della riunione dei creditori

    1 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B/2.14B

    7 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    65 pagine2.17B

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 31 gen 2011

    RES15

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 2Nd Floor Building 2610 the Quadrant Aztec West Bristol BS32 4TR* in data 09 feb 2011

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 lug 2010

    Stato del capitale al 28 lug 2010

    • Capitale: GBP 618,038.23
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Abu-Haris Shafi il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nikolai Kesting il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Willoughby Corporate Secretarial Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Chi sono gli amministratori di PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    80
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    80
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02691637
    68522760005
    KESTING, Nikolai
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    Amministratore
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    GermanyGerman137231520001
    SHAFI, Abu-Haris
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    Amministratore
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish137231430002
    ATKINSON, Paul Robert
    29 Longlands Road
    DA15 7LU Sidcup
    Kent
    Segretario
    29 Longlands Road
    DA15 7LU Sidcup
    Kent
    British5884180001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    Segretario
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    1278390005
    ATKINSON, Paul Robert
    4 Victoria Road
    DA15 7HD Sidcup
    Kent
    Amministratore
    4 Victoria Road
    DA15 7HD Sidcup
    Kent
    EnglandBritish5884180002
    CALDWELL, Findlay Martin
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GbBritish50777030001
    CAMP, Michael James
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritish12204760003
    DAUMANN, Christian
    Gam-Bischefsheim
    Rulaenderweg 11
    55296
    Germany
    Amministratore
    Gam-Bischefsheim
    Rulaenderweg 11
    55296
    Germany
    German132789860001
    DEAKIN, Janice
    Field Barn
    Broad Road
    IP20 0AZ Alburgh
    Norfolk
    Amministratore
    Field Barn
    Broad Road
    IP20 0AZ Alburgh
    Norfolk
    EnglandBritish238355920001
    EASTER, Philip Charles
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    Amministratore
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    EnglandBritish105999210001
    EGAN, Scott
    18 Broadmead Green
    Thorpe End
    NR13 5DE Norwich
    Amministratore
    18 Broadmead Green
    Thorpe End
    NR13 5DE Norwich
    British111697420001
    GLOVER, Richard Gordon Finlay
    86 Grange Road
    Ealing
    W5 3PJ London
    Amministratore
    86 Grange Road
    Ealing
    W5 3PJ London
    EnglandBritish5884200002
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish116885790001
    HEWITT, Alison Deborah
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish66782800004
    LEVER, Paul Ronald Scott
    Great Peter Street
    SW1P 3LR London
    35
    Amministratore
    Great Peter Street
    SW1P 3LR London
    35
    United KingdomBritish106971650001
    MACHELL, Simon Christopher
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    British145338560001
    MASSEY, Paul Ashley
    20 Elwill Way
    Park Langley
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    Amministratore
    20 Elwill Way
    Park Langley
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish24243460001
    SNOWBALL, Patrick Joseph Robert
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Amministratore
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    British38351740003
    SPICKER, Richard Harold
    Honeysuckle Barn
    Brands Lane, Felthorpe
    NR10 4EA Norwich
    Amministratore
    Honeysuckle Barn
    Brands Lane, Felthorpe
    NR10 4EA Norwich
    EnglandBritish120021510001
    TODD, David
    64 Long Road
    Framingham Earl
    NR14 7RZ Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    64 Long Road
    Framingham Earl
    NR14 7RZ Norwich
    Norfolk
    British70494790001
    WALDEN, Jonathan Kim
    Hyatt Lodge
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Hyatt Lodge
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish3809630002

    PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 09 lug 2010
    Consegnato il 22 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of change of deposited monies
    Creato il 16 set 2009
    Consegnato il 18 set 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The debt or debts repesented by any money from time to time standing to the credit of or treated as part of the companys account number 8067436 at 20-13-42 (security account) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 18 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 10 feb 2009
    Consegnato il 13 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rac PLC (Noteholder)
    Transazioni
    • 13 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 14 feb 1997
    Consegnato il 25 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 81/87 hartfield road london borough of merton, title numbers SY257925 the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 20 mag 1993
    Consegnato il 07 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter and or the guarantee and debenture
    Brevi particolari
    Fixed charge over all stocks shares and all copyrights patents trademarks etc. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties as Defined
    Transazioni
    • 07 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee debenure
    Creato il 13 apr 1990
    Consegnato il 20 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee unde the terms of the facilities agreement and the interest rate protection agreements and this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 18 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of mortgage and charge
    Creato il 30 gen 1987
    Consegnato il 16 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 28.1.87 and/or this charge
    Brevi particolari
    Mortgage & charge of the aircraft described in schedule 1 to the deed including the engines and all equipment instanlled at delivery or installed on the aircraft and all replacements renewals and additions (please see form 395 M21/17 feb/ln and schedule for full details).
    Persone aventi diritto
    • Svenska Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 16 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Aircraft & mortgage
    Creato il 11 apr 1985
    Consegnato il 17 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For accuring £3,300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Bristol aeropace 125 series 800B aircraft constructors serial no 258028 (please see doc M23 for details).
    Persone aventi diritto
    • Lombart North Central PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Chattel mortgage
    Creato il 31 dic 1984
    Consegnato il 03 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £3,600,00/ and all other moneys due or to become due from the comapny to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    British aerospace 125 series 800B aircraft constructors serial no:- 258028.
    Persone aventi diritto
    • Combard North Central PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 20 dic 1984
    Consegnato il 04 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the contract dted 14TH december 1984 and/or this charge
    Brevi particolari
    Motor vehicles belonging to the company from time to time, purcharsed pursuant tto the said agreement dated 14TH decembeer, 1984.
    Persone aventi diritto
    • Austin Rover Finance Limited
    Transazioni
    • 04 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    Deed of mortgage
    Creato il 25 gen 1983
    Consegnato il 03 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan facility letter dated 29TH november, 1982.
    Brevi particolari
    British aeordspace 125 series 700 b aircraft serial no 257189 reg mark g-osam with all equipments and engines.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1983Registrazione di un'ipoteca

    PARALLEL REALISATIONS 2 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 gen 2011Inizio dell'amministrazione
    31 gen 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    2
    DataTipo
    16 set 2016Data di scioglimento
    31 gen 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0