ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED

ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01264521
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MIDLAND GILLETT LEASING (NORTH) LIMITED22 giu 197622 giu 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 03 set 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    17 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    26 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di David John Cavanna come amministratore in data 24 lug 2013

    2 pagineAP01

    Nomina di Jaya Subramaniyan come amministratore in data 24 lug 2013

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Hollie Rheanna Wood come segretario in data 24 lug 2013

    1 pagineTM02

    Nomina di Katherine Dean come segretario in data 24 lug 2013

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Desmond Richard Turner come amministratore in data 20 giu 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Fiona Ann Barker come amministratore in data 21 giu 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Nomina di John Richard Kent come amministratore in data 06 dic 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Carl Thomas Senior come amministratore in data 19 giu 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Gareth Owen Conway il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 23 feb 2012

    1 pagineTM02

    Nomina di Hollie Rheanna Wood come segretario in data 23 feb 2012

    2 pagineAP03

    Nomina di Carl Thomas Senior come amministratore in data 04 gen 2012

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180092210001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Amministratore
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Segretario
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BROOKES, Malcolm James
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    Segretario
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    British61727900003
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Segretario
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Segretario
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Segretario
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Segretario
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Segretario
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Segretario
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154911870001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    166967380001
    ALDRIDGE, Peter Colin
    The Barn,Stoneleigh Quarry Farm
    Quarry Lane
    CV9 2RD Macetter
    Warwickshire
    Amministratore
    The Barn,Stoneleigh Quarry Farm
    Quarry Lane
    CV9 2RD Macetter
    Warwickshire
    British145932800001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BROOKES, Malcolm James
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    British61727900003
    BROOKES, Malcolm James
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    British61727900003
    BROWNE, Ian James
    4 Hawkshill Drive
    Box Lane
    HP3 0BS Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Hawkshill Drive
    Box Lane
    HP3 0BS Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British143599030001
    CARNEY, Brian
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    British100001170001
    DEVENISH, William Frederick
    12 Hyde Place
    OX2 7JB Oxford
    Amministratore
    12 Hyde Place
    OX2 7JB Oxford
    British52830160002
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Amministratore
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Amministratore
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HOLMES, Timothy Victor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Amministratore
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British28497420002
    KELL, Christopher Raymond
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    British87307470001
    KENNY, Mary Bridget
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    Amministratore
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    United KingdomBritish118995490002
    LANE, Robert David
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    Amministratore
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    EnglandBritish150099050001
    LEECH, Ian Robert
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    Amministratore
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    British52909330001
    LESTER, Edward Paul
    26 St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    26 St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    British4300370001
    MEAD, David Harry
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish254170760001
    PICKEN, Graham Edward
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    Amministratore
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    British144947830001
    QUINN, Noel Paul
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    British72093050001

    ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Ship mortgage
    Creato il 29 ott 1982
    Consegnato il 29 ott 1982
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from shell international petroleum company limited to the chargee on an account current under the terms of deed of covenant dated 29 oct 1982 and a demise charter dated 30 jan 1979
    Brevi particolari
    64/64 shares in M.S. "isocardia" registered at the port of london with official no. 703216 and in her boats, guns, ammunition, small arms and appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • United States Trust Company of New York
    Transazioni
    • 29 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Deed of covenant
    Creato il 29 ott 1982
    Consegnato il 29 ott 1982
    In corso
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due from shell international petroleum company limited to the chargee pursuant to a demise charter dated 30 jan 1979 and secured by a deed of covenants dated 29 oct, 1982
    Brevi particolari
    1) all the right, title and interest, present and future of the mortgage in and to M.S."isocardia"registered at the port of london with official no.703216 And 2) all the right, title and interest, present & future of the mortgage to the "ancillary benefits" as defined in the deed of covenants.
    Persone aventi diritto
    • United States Trust Company of New York
    Transazioni
    • 29 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Deeds of covenant
    Creato il 30 apr 1982
    Consegnato il 30 apr 1982
    In corso
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due from shell international petroleum company limited to the chargee pursuant to a demise charter dated 30 jan 1979 and secured by a mortgage dated 30 april 1982.
    Brevi particolari
    All the rights title & interest present & future of the mortgagor in 1) M.S. isomeria title no. 399061 2) to the ancillary benefits as defined in the deed of covenants.
    Persone aventi diritto
    • United States Trust Company of New York.
    Transazioni
    • 30 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    Ships mortgage
    Creato il 30 apr 1982
    Consegnato il 30 apr 1982
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from shell international petroleum company limited on an account current under the terms of a demise charter dated 30 jan 1979 and a deed of covenant dated 30 april 82
    Brevi particolari
    64/64 M.S.isomeria registered in london official no.399061 & her guns boats ammunition small arms & appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • United States Trust Company of New York
    Transazioni
    • 30 apr 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0