ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01264521 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?
- Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MIDLAND GILLETT LEASING (NORTH) LIMITED | 22 giu 1976 | 22 giu 1976 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2012 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 03 set 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 26 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di David John Cavanna come amministratore in data 24 lug 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Jaya Subramaniyan come amministratore in data 24 lug 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hollie Rheanna Wood come segretario in data 24 lug 2013 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Katherine Dean come segretario in data 24 lug 2013 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Desmond Richard Turner come amministratore in data 20 giu 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Fiona Ann Barker come amministratore in data 21 giu 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di John Richard Kent come amministratore in data 06 dic 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Carl Thomas Senior come amministratore in data 19 giu 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Gareth Owen Conway il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 23 feb 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Hollie Rheanna Wood come segretario in data 23 feb 2012 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Carl Thomas Senior come amministratore in data 04 gen 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAN, Katherine | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180092210001 | |||||||
| BENCARD, Robin Louis Henning | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 46782110002 | |||||
| CAVANNA, David John | Amministratore | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 180384720001 | |||||
| KENT, John Richard | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 174308200001 | |||||
| OWEN CONWAY, Gareth | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 82999960002 | |||||
| SUBRAMANIYAN, Jaya | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Malaysian | 136924480002 | |||||
| BAYER, George William | Segretario | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
| BROOKES, Malcolm James | Segretario | 3 School Close Pinvin WR10 2TZ Pershore Worcestershire | British | 61727900003 | ||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Segretario | Whitworth Street SE10 9EN London 13 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
| MCKENZIE, John Hume | Segretario | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Segretario | 1 Bolney Court Portsmouth Road KT6 4HX Surbiton Surrey | British | 109247130001 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Segretario | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Segretario | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| PEARCE, Mark Vivian | Segretario | 55 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | 26776940002 | ||||||
| READ, Alice | Segretario | 188 Berglen Court 7 Branch Road E14 7JZ London | British | 106168980003 | ||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 154911870001 | |||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 166967380001 | |||||||
| ALDRIDGE, Peter Colin | Amministratore | The Barn,Stoneleigh Quarry Farm Quarry Lane CV9 2RD Macetter Warwickshire | British | 145932800001 | ||||||
| BARKER, Fiona Ann | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 151858510001 | |||||
| BROOKES, Malcolm James | Amministratore | 3 School Close Pinvin WR10 2TZ Pershore Worcestershire | British | 61727900003 | ||||||
| BROOKES, Malcolm James | Amministratore | 3 School Close Pinvin WR10 2TZ Pershore Worcestershire | British | 61727900003 | ||||||
| BROWNE, Ian James | Amministratore | 4 Hawkshill Drive Box Lane HP3 0BS Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 143599030001 | ||||||
| CARNEY, Brian | Amministratore | Springwood Lodge Owler Park Road LS29 0BG Ilkley West Yorkshire | British | 100001170001 | ||||||
| DEVENISH, William Frederick | Amministratore | 12 Hyde Place OX2 7JB Oxford | British | 52830160002 | ||||||
| EVANS, Geoffrey William | Amministratore | The Trumpet House Kington Lane Claverdon CV35 8PP Warwick | British | 42712190001 | ||||||
| GILMAN, David William | Amministratore | 32 Riverside Drive Selly Oak B29 7ES Birmingham | British | 5681410002 | ||||||
| HOLMES, Timothy Victor | Amministratore | 18 The Badgers Mearse Lane Barnt Green B45 8QR Birmingham | British | 28497420002 | ||||||
| KELL, Christopher Raymond | Amministratore | 6 Gorse Close WR9 7SG Droitwich Worcestershire | British | 87307470001 | ||||||
| KENNY, Mary Bridget | Amministratore | 178 Empire Square West Long Lane SE1 4NL London | United Kingdom | British | 118995490002 | |||||
| LANE, Robert David | Amministratore | 42 Bridgnorth Road WV5 0AA Wombourne Staffordshire | England | British | 150099050001 | |||||
| LEECH, Ian Robert | Amministratore | 139 Lordswood Road Harborne B17 9BL Birmingham | British | 52909330001 | ||||||
| LESTER, Edward Paul | Amministratore | 26 St Barnabas Road CB1 2BY Cambridge Cambridgeshire | British | 4300370001 | ||||||
| MEAD, David Harry | Amministratore | Willowbank Pirton WR8 9ED Worcester Worcestershire | England | British | 254170760001 | |||||
| PICKEN, Graham Edward | Amministratore | 60 Church Road Aspley Heath Woburn Sands MK17 8TA Milton Keynes | British | 144947830001 | ||||||
| QUINN, Noel Paul | Amministratore | 10 Besford Grove Shirley B90 4YU Solihull West Midlands | British | 72093050001 |
ASSETFINANCE DECEMBER (C) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Ship mortgage | Creato il 29 ott 1982 Consegnato il 29 ott 1982 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from shell international petroleum company limited to the chargee on an account current under the terms of deed of covenant dated 29 oct 1982 and a demise charter dated 30 jan 1979 | |
Brevi particolari 64/64 shares in M.S. "isocardia" registered at the port of london with official no. 703216 and in her boats, guns, ammunition, small arms and appurtenances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of covenant | Creato il 29 ott 1982 Consegnato il 29 ott 1982 | In corso | Importo garantito For further securing all monies due or to become due from shell international petroleum company limited to the chargee pursuant to a demise charter dated 30 jan 1979 and secured by a deed of covenants dated 29 oct, 1982 | |
Brevi particolari 1) all the right, title and interest, present and future of the mortgage in and to M.S."isocardia"registered at the port of london with official no.703216 And 2) all the right, title and interest, present & future of the mortgage to the "ancillary benefits" as defined in the deed of covenants. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deeds of covenant | Creato il 30 apr 1982 Consegnato il 30 apr 1982 | In corso | Importo garantito For further securing all monies due or to become due from shell international petroleum company limited to the chargee pursuant to a demise charter dated 30 jan 1979 and secured by a mortgage dated 30 april 1982. | |
Brevi particolari All the rights title & interest present & future of the mortgagor in 1) M.S. isomeria title no. 399061 2) to the ancillary benefits as defined in the deed of covenants. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Ships mortgage | Creato il 30 apr 1982 Consegnato il 30 apr 1982 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from shell international petroleum company limited on an account current under the terms of a demise charter dated 30 jan 1979 and a deed of covenant dated 30 april 82 | |
Brevi particolari 64/64 M.S.isomeria registered in london official no.399061 & her guns boats ammunition small arms & appurtenances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0