TURBINE BLADING LIMITED

TURBINE BLADING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTURBINE BLADING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01265008
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TURBINE BLADING LIMITED?

    • lavorazioni meccaniche (25620) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova TURBINE BLADING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TURBINE BLADING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TURBINE BLADING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 apr 2021

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 apr 2020

    10 pagineLIQ03

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 apr 2019

    9 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Arena Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1PU a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR in data 26 apr 2018

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 03 apr 2018

    LRESSP

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    1 pagineAD03

    Notifica di Ge Inspection and Repair Services Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 29 dic 2017

    2 paginePSC09

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    15 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    That the sum of £1,196,177.00 being the total amount standing to the credit of the company's other reserves, be and is hereby capitalised and appropriated as capital to the holders of the ordinary shares of £1.00 each in the capital of the company 21/09/2017
    RES14
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 27 set 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 22/09/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 21 set 2017

    • Capitale: GBP 1,208,477
    3 pagineSH01

    Chi sono gli amministratori di TURBINE BLADING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione7038430
    146358090001
    DOWNEY, Stephen Thomas
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSenior Operation Manager184747430001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishTax Manager127244240001
    CATALDO, John
    3306 Jameson Pass
    Alpharotta
    FOREIGN 30022 Georgia
    Usa
    Segretario
    3306 Jameson Pass
    Alpharotta
    FOREIGN 30022 Georgia
    Usa
    British62465990001
    JAFFA, Richard Henry
    32 Malcolmson Close
    Edgbaston
    B15 3LS Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    32 Malcolmson Close
    Edgbaston
    B15 3LS Birmingham
    West Midlands
    English9163880001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    BREMNER, Ian Miller
    1 Melford Hall Road
    B91 2ES Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    1 Melford Hall Road
    B91 2ES Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant29995610001
    CARTLEDGE, Andrew
    30 Trailside Road
    MA 02493 Weston
    United States
    Amministratore
    30 Trailside Road
    MA 02493 Weston
    United States
    BritishDirector70072110003
    CHRISTIE, Roderick Angus
    14 Oakfield Road
    SL8 5QN Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    14 Oakfield Road
    SL8 5QN Bourne End
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Manager Energy Service82543780001
    CLARK, Alyson Margaret
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishLegal Counsel56868460002
    COYLE, Feilim Malachy
    24 Saint Davids Drive
    TW20 0BA Englefield Green
    Surrey
    Amministratore
    24 Saint Davids Drive
    TW20 0BA Englefield Green
    Surrey
    IrishDirector70072140002
    DANIELL, Paul Nigel
    7 Lucerne Drive
    Stadhampton
    OX44 7QT Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    7 Lucerne Drive
    Stadhampton
    OX44 7QT Oxford
    Oxfordshire
    BritishHuman Resources Manager62463920001
    DIGBY, Mark Damien
    Calle Valle Del Roncal 71,
    Las Lomas
    28660 Boadilla Del Monte
    Madrid
    Spain
    Amministratore
    Calle Valle Del Roncal 71,
    Las Lomas
    28660 Boadilla Del Monte
    Madrid
    Spain
    IrishEurope Operations Manager103125610001
    FENECH, Lindy Frances
    Service Centre
    Littlebrook Manor Way
    DA1 5PZ Dartford
    Ge Energy Dartford
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Service Centre
    Littlebrook Manor Way
    DA1 5PZ Dartford
    Ge Energy Dartford
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone172863970001
    FRASER, Gillian Annette
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector30720040001
    FRASER, Michael James
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Badgeworth Manor
    Badgeworth
    GL51 5UL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector35575120001
    GAULT, Ernest Harold
    520 Fawn Glenn Court
    Roswell
    Georgia
    30075
    Usa
    Amministratore
    520 Fawn Glenn Court
    Roswell
    Georgia
    30075
    Usa
    AmericanCompany Director62463900001
    GRIFFITHS, Kyle
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomUs CitizenOperations Executive172602560001
    JORDAN, Stephen John
    1 Pike Corner
    Willersey
    WR12 7PZ Broadway
    Worcestershire
    Amministratore
    1 Pike Corner
    Willersey
    WR12 7PZ Broadway
    Worcestershire
    BritishCompany Director32376290001
    KEENAN, John Joseph
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    Amministratore
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    BritishUk Controller Ge Energy106985300001
    LEVITCH, Paul Edward
    Spring Rise Whichford Road
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Spring Rise Whichford Road
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    BritishSales Director50792110001
    MULHOLLAND, Diarmaid Patrick
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    ItalyIrishSales Engineer116288460001
    PARKES, David John William
    35 St Martins Close
    CV37 9QW Stratford
    Warwickshire
    Amministratore
    35 St Martins Close
    CV37 9QW Stratford
    Warwickshire
    BritishAccountant85953530001
    ROBERTSON, Moria Ann
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United KingdomBritishCfo Europe203364460001
    TON, Gwaine William
    Beech Hill Lodge
    Ridgemead Road, Englefield Green
    TW20 0YD Egham
    Surrey
    Amministratore
    Beech Hill Lodge
    Ridgemead Road, Englefield Green
    TW20 0YD Egham
    Surrey
    AmericanCompany Director93302530001
    WAKE, Hilary Anne, Mrs.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTax Manager96648390001
    WARDLE, John Malcolm
    Norton Grange
    Norton Grange Lane Knowle
    Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Norton Grange
    Norton Grange Lane Knowle
    Solihull
    West Midlands
    BritishDirector5096040001
    WHITE, Andrew Christopher
    4050 Keswick Drive
    Ga 30339 Atlanta
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    4050 Keswick Drive
    Ga 30339 Atlanta
    FOREIGN Usa
    BritishGeneral Manager62466070001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TURBINE BLADING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1182449
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per TURBINE BLADING LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    15 ott 201601 dic 2017La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    TURBINE BLADING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 26 feb 1998
    Consegnato il 04 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 24 gen 1997
    Consegnato il 29 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Car park and adjoining land at station rd,shipston-on-stour warwickshire with all rights,licences,guarantees,rent deposits contracts,undertakings,goodwill of business and all other payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 18 dic 1996
    Consegnato il 24 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Station road, shipston-on-stour warwickshire; any goodwill of any business from time to time carried on at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 18 dic 1996
    Consegnato il 19 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at berry hill industrial estate droitwich with the benefit of all rights and licences shares or membership rights goodwill of any business rental and other money payable.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 dic 1996
    Consegnato il 07 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 15 mar 1993
    Consegnato il 25 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heller horizontal - PFH10 - M39498 (for full details of charge see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 06 lug 1992
    Consegnato il 15 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various chattels (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 01 lug 1991
    Consegnato il 10 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account whether already opened or to be opened hereafter and in whatsoever currency such account may be denominated and whether with the bank or opened by the bank.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 giu 1991
    Consegnato il 10 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Piece of land near station road, shipston-on-stour, in the county of warwickshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge.
    Creato il 12 ott 1989
    Consegnato il 31 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC, re: turbine blading limited uum al - jawaby no.2.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 12 ott 1989
    Consegnato il 31 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC, re: turbine blading limited egat.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 12 set 1989
    Consegnato il 02 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account. Of the company with the bank designated barclays bank PLC re. Turbine blading limited uum al jawaby.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 08 feb 1989
    Consegnato il 22 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re. Turbine blading limited.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 18 ago 1986
    Consegnato il 26 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various machinery (see continuation sheet NO1. Attached to doc 395).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 22 lug 1986
    Consegnato il 28 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Mandelli machining centre serial no. 7239.81.07000049. (see doc M14 for futher details and attached continuation sheet no 1 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 22 lug 1986
    Consegnato il 28 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Mitutoyo coordinate measurer with attachments serial no. Cmm-B241-6002 hp 9816. mandelli machining centre (HP9872 plotter 7289/83/07000067) (see doc M13 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 1986
    Consegnato il 12 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Dale cross grange. Mearse lane, barnt green, bromsgrove, hereford & worcester. Title no. Hw 17903.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 giu 1978
    Consegnato il 05 lug 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 26 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TURBINE BLADING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 apr 2018Inizio della liquidazione
    06 lug 2022Data prevista di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Derek Hyslop
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0