GCI LONDON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGCI LONDON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01269264
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GCI LONDON LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova GCI LONDON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Rose Court
    2 Southwark Bridge Road
    SE1 9HS London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GCI LONDON LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PCI LONDON LTD30 giu 200830 giu 2008
    GCI LONDON LIMITED12 feb 199212 feb 1992
    GCI STERLING LIMITED26 mag 198926 mag 1989
    STERLING PUBLIC RELATIONS LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    BONDTIME LIMITED16 lug 197616 lug 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di GCI LONDON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per GCI LONDON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 nov 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9LT a Rose Court 2 Southwark Bridge Road London SE1 9HS in data 14 gen 2022

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 dic 2015

    Stato del capitale al 17 dic 2015

    • Capitale: GBP 200,001
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 nov 2014

    Stato del capitale al 21 nov 2014

    • Capitale: GBP 200,001
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Wpp Group (Nominees) Limited il 20 dic 2013

    1 pagineCH04

    Bilancio annuale redatto al 17 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 dic 2013

    Stato del capitale al 20 dic 2013

    • Capitale: GBP 200,001
    SH01

    Chi sono gli amministratori di GCI LONDON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Segretario
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione2757919
    80143770001
    WEST, Ian
    2 Southwark Bridge Road
    SE1 9HS London
    Rose Court
    England
    Amministratore
    2 Southwark Bridge Road
    SE1 9HS London
    Rose Court
    England
    United KingdomBritish175296410001
    BERGEN, John Donald
    876 Gainsway Road
    PA 19067 Yardley
    Pennsylvania
    Usa
    Segretario
    876 Gainsway Road
    PA 19067 Yardley
    Pennsylvania
    Usa
    Us Citizen36971950001
    GRIFFITHS, Sally Jane
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    Segretario
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    British91601070001
    LAM, Steve Wye Keong
    5 Oakwood Avenue
    WD6 1SP Borehamwood
    Hertfordshire
    Segretario
    5 Oakwood Avenue
    WD6 1SP Borehamwood
    Hertfordshire
    Malaysian56183390001
    LYSIONEK, Susan Mary
    Nightingales
    GU3 1DT Compton
    Surrey
    Segretario
    Nightingales
    GU3 1DT Compton
    Surrey
    British78777420001
    AINGER, Colin
    10 Fir Trees
    Tidys Lane
    CM16 6SJ Epping
    Essex
    Amministratore
    10 Fir Trees
    Tidys Lane
    CM16 6SJ Epping
    Essex
    EnglandBritish18056800001
    ARNOLD, Virginia
    76 Westfield Avenue
    Barnes
    SW13 0AZ London
    Amministratore
    76 Westfield Avenue
    Barnes
    SW13 0AZ London
    British112176580001
    BEATTIE, Geoffrey Spencer
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    Amministratore
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    United KingdomBritish131562650001
    BERGEN, John Donald
    876 Gainsway Road
    PA 19067 Yardley
    Pennsylvania
    Usa
    Amministratore
    876 Gainsway Road
    PA 19067 Yardley
    Pennsylvania
    Usa
    Us Citizen36971950001
    BRILL, John
    Rookhurst Coast Hill Lane
    Westcott
    RH4 3LJ Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Rookhurst Coast Hill Lane
    Westcott
    RH4 3LJ Dorking
    Surrey
    British10684530001
    BRYAN, Harriet
    141 Acton Lane
    Chiswick
    W4 5HW London
    Amministratore
    141 Acton Lane
    Chiswick
    W4 5HW London
    British37442420001
    CARTER, Carolyn
    2 Sterling Street
    SW7 1HN London
    Amministratore
    2 Sterling Street
    SW7 1HN London
    American80287820001
    CARTWRIGHT, Roderick Anthony
    46 St Julian's Farm Road
    SE27 0RS London
    Amministratore
    46 St Julian's Farm Road
    SE27 0RS London
    EnglandBritish109202680001
    CATER, Mark
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    United Kingdom
    Amministratore
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    United Kingdom
    British116938400003
    CLARK, Nicholas John
    53 Wick Road
    TW11 9DN Teddington
    Amministratore
    53 Wick Road
    TW11 9DN Teddington
    United KingdomBritish75978080002
    DADRA, Raj Kumar
    30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    New Bridge Street House
    Amministratore
    30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    New Bridge Street House
    British88610840003
    DALBY, Derek George
    Glebe Corner
    Croft Road
    CR3 7EG Woldingham
    Surrey
    Amministratore
    Glebe Corner
    Croft Road
    CR3 7EG Woldingham
    Surrey
    British16975870001
    DEWHURST, Philip
    29 Chesfield Road
    KT2 5TH Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    29 Chesfield Road
    KT2 5TH Kingston Upon Thames
    Surrey
    British77166960001
    DOBSON, Isabel Claire
    16 Hartley Way
    CR8 4EG Purley
    Surrey
    Amministratore
    16 Hartley Way
    CR8 4EG Purley
    Surrey
    EnglandBritish66065060002
    EDWARDS, Roger John
    The Thatches
    Forest Road
    GU22 8LU Pyrford
    Surrey
    Amministratore
    The Thatches
    Forest Road
    GU22 8LU Pyrford
    Surrey
    British36176200001
    HARRIES, Rhodri Nicholas Lloyd
    104 Fernside Road
    SW12 8LJ London
    Amministratore
    104 Fernside Road
    SW12 8LJ London
    British74124480002
    INGRAM, Tamara
    Middle House
    No 12 Highbury Place
    N5 1QZ London
    Amministratore
    Middle House
    No 12 Highbury Place
    N5 1QZ London
    United KingdomBritish76558150002
    KNOWLES, David Christopher
    Flat 4
    56 Nightingale Lane
    SW12 8NY London
    Amministratore
    Flat 4
    56 Nightingale Lane
    SW12 8NY London
    British37442460001
    LINNELL, Peter John
    Rivers Reach
    Hamm Court
    KT13 8YA Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Rivers Reach
    Hamm Court
    KT13 8YA Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish63174210002
    MADDOCK, Paul
    Flat 4
    13 Elder Avenue
    N8 9TE London
    Amministratore
    Flat 4
    13 Elder Avenue
    N8 9TE London
    British102154190001
    MCAVOY, Michael Anthony
    Middleton House
    Milton Abbas
    DT11 0BS Blandford Forum
    Dorset
    Amministratore
    Middleton House
    Milton Abbas
    DT11 0BS Blandford Forum
    Dorset
    British47510970001
    MEDLEY, Richard David
    21 Wexfenne Gardens
    Pyrford
    GU22 8TX Woking
    Surrey
    Amministratore
    21 Wexfenne Gardens
    Pyrford
    GU22 8TX Woking
    Surrey
    EnglandBritish166924940001
    MOUCHLY-WEISS, Harriet
    777 Third Avenue
    FOREIGN New York 10017
    Usa
    Amministratore
    777 Third Avenue
    FOREIGN New York 10017
    Usa
    American16975880001
    NOBLE, Fiona Catherine
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    Amministratore
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Lynton House
    United KingdomBritish146832700001
    PENSON, Alan Anthony
    Fairfield House
    HP8 4EL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Fairfield House
    HP8 4EL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish490110001
    PICKERING, Conor
    38 Grafton Terrace
    NW5 London
    Amministratore
    38 Grafton Terrace
    NW5 London
    British76542890001
    RANDLE, Caroline Anne Mary
    47 Biddulph Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1HT London
    Amministratore
    47 Biddulph Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1HT London
    British70063750001
    RODLEY, Fiona Elsbeth
    9 Latimer Close
    54 Kensington Park Road
    W11 3BL London
    Amministratore
    9 Latimer Close
    54 Kensington Park Road
    W11 3BL London
    British96595430001
    RYAN, Susan Frances
    24 Ravenslea Road
    SW12 8RY London
    Amministratore
    24 Ravenslea Road
    SW12 8RY London
    British47402280001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GCI LONDON LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hatton Garden
    EC1N 8JS London
    77
    England
    17 nov 2016
    Hatton Garden
    EC1N 8JS London
    77
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1795794
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    GCI LONDON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 15 ott 2001
    Consegnato il 25 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re gci london limited, business premium account number 40256374. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 29 set 1998
    Consegnato il 07 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    In barclays bank PLC business premium account number 60779008. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 set 1994
    Consegnato il 10 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 01 mar 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 25 mar 1987
    Consegnato il 06 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    22 chelsea manor gardens london SW3 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 06 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 set 1982
    Consegnato il 07 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge overall f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale threof fixed & floating charge overundertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 07 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0