FARM GAS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFARM GAS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01272438
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FARM GAS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FARM GAS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lancaster House Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FARM GAS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per FARM GAS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    5 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    5 pagineAA

    Nomina di Awg Corporate Services Limited come segretario in data 22 feb 2021

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Elizabeth Ann Horlock Clarke come segretario in data 22 feb 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Wayne Paul Young come amministratore in data 15 feb 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Jonathan David Forster il 30 giu 2020

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Ang Group Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2016 con aggiornamenti

    24 pagineCS01

    Nomina di Claire Tytherleigh Russell come amministratore in data 28 lug 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Ann Horlock Clarke come amministratore in data 28 lug 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Lancaster House Lancaster Way Ermine Business Park Huntingdon Cambridgeshire PE29 6YJ a Lancaster House Lancaster Way Ermine Business Park Huntingdon Cambridgeshire PE29 6XU in data 29 set 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 07 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 lug 2015

    Stato del capitale al 07 lug 2015

    • Capitale: GBP 117,856.7
    SH01

    Chi sono gli amministratori di FARM GAS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AWG CORPORATE SERVICES LIMITED
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Segretario
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione12618899
    270129230001
    FORSTER, Jonathan David
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish101812460002
    RUSSELL, Claire Tytherleigh
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritish105433380001
    YOUNG, Wayne Paul
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish264531200001
    CLARKE, Elizabeth Ann Horlock
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6YJ Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Segretario
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6YJ Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    198438490001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    ANDERSON, Mark Stephen
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    EnglandBritish122463830003
    CHESSHIRE, Michael James
    The Firs
    Steventon
    SY8 4BN Ludlow
    Salop
    Amministratore
    The Firs
    Steventon
    SY8 4BN Ludlow
    Salop
    British33851510001
    CLARKE, Elizabeth Ann Horlock
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6YJ Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6YJ Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish195497270001
    CROOM-JOHNSON, William Slade
    Highfield
    Horderley
    SY7 8HP Craven Arms
    Salop
    Amministratore
    Highfield
    Horderley
    SY7 8HP Craven Arms
    Salop
    British/Canadian47156150001
    DICKINSON, Roger Martin
    36 Glapthorn Road
    PE8 4JQ Oundle
    Peterborough
    Amministratore
    36 Glapthorn Road
    PE8 4JQ Oundle
    Peterborough
    British91579530001
    FIRTH, Patrick
    The Cottage
    High Street
    PE28 0AB Ellington Huntingdon
    Cambs
    Amministratore
    The Cottage
    High Street
    PE28 0AB Ellington Huntingdon
    Cambs
    British85034900001
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish66174560001
    HORLOCK, Elizabeth Ann
    9 Ermine Court
    PE29 7SD Huntingdon
    Cambs
    Amministratore
    9 Ermine Court
    PE29 7SD Huntingdon
    Cambs
    British110831950001
    LATHAM, David Charles Frederick
    Thicket Lodge Thicket Road
    Houghton
    PE17 2DB Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Thicket Lodge Thicket Road
    Houghton
    PE17 2DB Huntingdon
    Cambridgeshire
    British61429350001
    MALONEY, Robert John
    33 Long Furlong
    CV22 5QT Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    33 Long Furlong
    CV22 5QT Rugby
    Warwickshire
    British107772920001
    MANTLE, Jeremy
    West Wing Seifton Court Barns
    Seifton
    SY1 1DG Ludlow
    Shropshire
    Amministratore
    West Wing Seifton Court Barns
    Seifton
    SY1 1DG Ludlow
    Shropshire
    British52996050001
    NICOLL, Peter
    Westerlee
    Hawks Hill Guildford Road
    KT22 9DP Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Westerlee
    Hawks Hill Guildford Road
    KT22 9DP Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish17510150002
    NIELD, Andrew Simon
    Ruhpolding Mill Lane
    Hemingford Grey
    PE18 9DQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Ruhpolding Mill Lane
    Hemingford Grey
    PE18 9DQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    British69491180002
    NIELD, Andrew Simon
    Ruhpolding Mill Lane
    Hemingford Grey
    PE18 9DQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Ruhpolding Mill Lane
    Hemingford Grey
    PE18 9DQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    British69491180002
    PEDDIE, James Barrie
    The Square House
    Tunnel Hill
    WR8 0QL Upton-On-Severn
    Worcester
    Amministratore
    The Square House
    Tunnel Hill
    WR8 0QL Upton-On-Severn
    Worcester
    British9761100001
    ROWLANDS, Harry Spencer
    5 Unwin Crescent
    DY8 3UY Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    5 Unwin Crescent
    DY8 3UY Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish68150590001
    RUSSELL, Claire Tytherleigh
    Southfields
    Brick House End, Berden
    CM23 1AZ Bishop's Stortford
    Herts
    Amministratore
    Southfields
    Brick House End, Berden
    CM23 1AZ Bishop's Stortford
    Herts
    EnglandBritish105433380001
    SAUNDERS, Malcolm Richard
    The Gullet Cottage
    Adforton
    SY7 0NQ Leintwardine
    Shropshire
    Amministratore
    The Gullet Cottage
    Adforton
    SY7 0NQ Leintwardine
    Shropshire
    British37427530001
    SUDBURY, Roger Graham
    32 Park Lane
    CM23 3NH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    32 Park Lane
    CM23 3NH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British82545120001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Amministratore
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    EnglandBritish135181230001
    WARRACK, Anne Victoria Mary
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    United KingdomBritish123157220001
    WIJKMARK, Carl Goran
    Styrmansvagen 1
    133 00 Saltsjobaden
    Sweden
    Amministratore
    Styrmansvagen 1
    133 00 Saltsjobaden
    Sweden
    Swedish34984690001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FARM GAS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Awg Group Limited
    Lancaster Way
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Lancaster Way
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazione2366618
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    FARM GAS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 10 ago 1987
    Consegnato il 11 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £40,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H units 1 & 2 love lane industrial estate, bishops castle, shropshire.
    Persone aventi diritto
    • Council for Small Industries in Rural Areas
    Transazioni
    • 11 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1987
    Consegnato il 24 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 1 and 2 love lane industrial estate bishop castle shropshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 apr 1984
    Consegnato il 03 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0