SESCOMATICS
Panoramica
Nome della società | SESCOMATICS |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
Numero di società | 01272630 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SESCOMATICS?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova SESCOMATICS?
Indirizzo della sede legale | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SESCOMATICS?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TOBYSOUND LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
CAPTIONFINE LIMITED | 11 ago 1976 | 11 ago 1976 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SESCOMATICS?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per SESCOMATICS?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2018 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Steven John Holmes come amministratore in data 22 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Stewart Frank Bradley Baker come amministratore in data 21 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 24 set 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 26 set 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 set 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di James William O'halleran come amministratore in data 02 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Steven John Holmes come amministratore in data 24 mar 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Carys Damon come segretario in data 23 mar 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Steven John Holmes come segretario in data 23 mar 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 set 2013 | 1 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2012 | 1 pagine | AA | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 24 set 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SESCOMATICS?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMON, Carys | Segretario | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | 196178450001 | |||||||
BAKER, Stewart Frank Bradley | Amministratore | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 230753770001 | ||||
ALBION, Susan | Segretario | 7 Brownsfield Road WS13 6BT Lichfield Staffordshire | British | Solicitor | 80142740001 | |||||
HOLMES, Steven John | Segretario | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | British | General Counsel | 80455940002 | |||||
OLDHAM, Annette | Segretario | Edwards Farm Road Fradley WS13 8NR Lichfield 29 Staffordshire | British | 135120610001 | ||||||
PAGE, David | Segretario | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | British | 31059170002 | ||||||
THOMAS, Paul | Segretario | 26 Risegate NG12 3JF Cotgrave Nottinghamshire | British | 29218800001 | ||||||
BEER, Brian Leslie | Amministratore | 52 Meadow View Rolleston On Dove DE13 9AN Burton On Trent Staffordshire | British | Company Director | 61154670001 | |||||
BUTLER, Christopher | Amministratore | 1 Richmond Court Repton DE65 6WS Derby Derbyshire | British | Director Of Operations | 64814300001 | |||||
CHILDS, Mervyn Peter | Amministratore | Riverdale Lower High Street DE13 9LU Burton On Trent Staffordshire | British | Company Director | 4619870002 | |||||
CHINN, Neil | Amministratore | 12 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 61154190002 | ||||
CUSKER, David Thomas | Amministratore | Two Loos 5 Paddock Close Copmanthorpe YO2 3RX York North Yorkshire | British | Director Of Operations | 8118380001 | |||||
DARBY, Otto Charles | Amministratore | 103 Harborne Road Edgbaston B15 3HG Birmingham | British | Chairman | 3928470001 | |||||
DAY, John Michael | Amministratore | 27 Newfield Lane S17 3DB Sheffield South Yorkshire | England | British | Finance Director/Company Sec | 69255730001 | ||||
HARRISON, Gerald Edward | Amministratore | 57 Furlong Lane Alrewas DE13 7EE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Director Of Operations | 47602430001 | ||||
HOLMES, Steven John | Amministratore | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Solicitor | 195545010001 | ||||
HOYLE, Russell Blackburn | Amministratore | 5 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | England | British | Company Director | 52822380002 | ||||
LANGLEY, Paul | Amministratore | 9 Besbury Close Dorridge B93 8NT Solihull | England | British | Sales Director | 99802010001 | ||||
MASSEY, Timothy John | Amministratore | Chestnut Cottage Silver Lane Marchington ST14 8LL Uttoxeter Staffordshire | United Kingdom | British | Free Trade Sales Director | 100259370001 | ||||
NAPIER, Iain John Grant | Amministratore | Loxley 5 Ladywood Road B74 2SN Sutton Coldfield West Midlands | British | Company Chairman | 68802120001 | |||||
O'HALLERAN, James William | Amministratore | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | England | British | Company Director | 103876820003 | ||||
PAGE, David | Amministratore | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | England | British | Chartered Accountant (Acma) | 31059170002 | ||||
PORTNO, Antony David, Dr | Amministratore | 91 Burley Lane Quarndon DE22 5JR Derby | British | Company Director | 58363120001 | |||||
SHERLOCK, Peter Charles | Amministratore | The Grange Somersal Herbert DE6 5PD Ashbourne Derbyshire | British | Company Director | 27922900001 | |||||
SIMON, Christopher Neil | Amministratore | 89 Ella Road West Bridgford NG2 5GZ Nottingham | England | British | Marketing Director | 95528490001 | ||||
SMITH, Keith Ian | Amministratore | Wythtree Manor Park DE13 7JA Kings Bromley Staffordshire | United Kingdom | British | Operations Director | 40284060002 | ||||
THOMAS, Paul | Amministratore | 26 Risegate NG12 3JF Cotgrave Nottinghamshire | British | Company Director | 29218800001 | |||||
THOMPSON, Michael Robert | Amministratore | Park Road Alrewas DE13 7AG Burton On Trent 20 Staffordshire | British | Chartered Accountant | 134817070001 | |||||
WITHERS, Roger Dean | Amministratore | Ivy Cottage The Green Dinton HP17 8UP Aylesbury Buckinghamshire | England | British | Company Director | 29586130001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SESCOMATICS?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspired Gaming (Uk) Limited | 06 apr 2016 | The Maltings, Wetmore Road DE14 1SE Burton-On-Trent 3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
SESCOMATICS ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of amendment and restatement to a composite guarantee and debenture dated 3RD august 1998 (the "deed") | Creato il 26 mar 1999 Consegnato il 10 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All indebtedness and liabilities and obligations due owing or incurred pursuant to the revolving credit facility, the mezzanine loan facility and that part of the term loan facility not used to repay indebtedness due under the facilities agreement to the chargee by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise | |
Brevi particolari L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 (for further details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 03 ago 1998 Consegnato il 20 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due pursuant to the revolving credit facility to the security beneficiaries by any group company on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0