LYDIASHOURNE LIMITED

LYDIASHOURNE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLYDIASHOURNE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01272673
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LYDIASHOURNE LIMITED?

    • Attività di gioco d'azzardo e scommesse (92000) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova LYDIASHOURNE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Poynt
    45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LYDIASHOURNE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STRIPES CASINO CLUB LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    LYDIASHOURNE LIMITED11 ago 197611 ago 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di LYDIASHOURNE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 set 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per LYDIASHOURNE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da , New Castle House Castle Boulevard, Nottingham, Nottinghamshire, NG7 1FT, England in data 31 lug 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 lug 2013

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Stato del capitale al 24 mag 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Willits il 19 feb 2013

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da , 71 Queensway, London, W2 4QH, England in data 18 feb 2013

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 set 2010

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Diane Penfold come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Harry Willits come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Gala Coral Properties Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 set 2009

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LYDIASHOURNE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Segretario
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    GALA CORAL PROPERTIES LIMITED
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3720332
    154705860001
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    LOVE, Andrew Michael
    The Old Forge Cottage 45 High Street
    Markyate
    AL3 8PG St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    The Old Forge Cottage 45 High Street
    Markyate
    AL3 8PG St Albans
    Hertfordshire
    British35693230001
    NOBLE, Michael Jeremy
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    Segretario
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    British32786810004
    SIMMONDS, Gordon Graham
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    Segretario
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    British34446930003
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Segretario
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    BENNETT, Michael Daniel
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    Amministratore
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    British71518290003
    CHALK, Robert Clifford
    79 Queensway
    W2 4QY London
    Amministratore
    79 Queensway
    W2 4QY London
    British35401590002
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Amministratore
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    CUNIN, Edmond Hubert Yves
    4 Canons Close
    WD7 7ER Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Canons Close
    WD7 7ER Radlett
    Hertfordshire
    French36095950001
    DAVEY, Johann Lesley
    71 Queensway
    W2 4QH London
    Amministratore
    71 Queensway
    W2 4QH London
    British42372810002
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Amministratore
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    HARLEY, Susan Boyle
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41384040001
    HAYWARD, Patrick Henry
    81 Queensway
    W2 4QY London
    Amministratore
    81 Queensway
    W2 4QY London
    British52032550002
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish65090920001
    KELLY, John Michael
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    Amministratore
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    British56474600002
    KENT-LEMON, Nigel William
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    Amministratore
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    British6467990001
    LLOYD, Thomas Richard
    Little Foxwood 207 The Street
    Capel
    RH5 5ER Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Little Foxwood 207 The Street
    Capel
    RH5 5ER Dorking
    Surrey
    British66394670001
    LOVE, Andrew Michael
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    Amministratore
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    British35693230002
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    PAYNE, Ian Timothy
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    British78974110002
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    ROSS, Alan Spencer
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    Amministratore
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    British69823550001
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003
    STANLEY, Kate Emma
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    British66637240001
    VAUGHAN, Kenneth Gerald
    Maple Court
    Central Park
    WD1 1HZ Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maple Court
    Central Park
    WD1 1HZ Watford
    Hertfordshire
    British50731890001
    WAGGETT, Colin
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    Amministratore
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    British62266600001

    LYDIASHOURNE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 11 mag 2006
    Consegnato il 24 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 24 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 27 ott 2005
    Consegnato il 09 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 09 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 01 set 2005
    Consegnato il 20 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 20 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 18 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transazioni
    • 18 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 17 mar 2003
    Consegnato il 03 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including 1A palace gate,kensington,london W8 5LS; LN3490 and NGL474780; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston,London Branch,as Security Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties
    Transazioni
    • 03 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fifth supplemental and accession deed
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 11 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Brevi particolari
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transazioni
    • 11 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 ott 1993
    Consegnato il 19 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) under the terms of this charge and any of the financing documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 19 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement entitled "prompt credit application"
    Creato il 09 ott 1991
    Consegnato il 18 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £77,466.88 being the total amount payable by the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement.
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance. (Please see m 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 18 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee debenture
    Creato il 28 lug 1990
    Consegnato il 02 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or celthald limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property at bach of 1A palace gate kensington london W8 5LS l/h three basement vaults 1E palace gate kensington london W8. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 mar 1985
    Consegnato il 26 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at the back of 1A palace gate kensington title no ngl 474780 (please see doc M68 for full details).
    Persone aventi diritto
    • County Bank Limited
    Transazioni
    • 26 mar 1985Registrazione di un'ipoteca

    LYDIASHOURNE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 feb 2014Data di scioglimento
    24 lug 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jill Sandford
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nottinghamshire
    Praticante
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nottinghamshire
    Patrick B Ellward
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Praticante
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0