01273188 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società01273188 LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01273188
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 01273188 LIMITED?

    • (5190) /

    Dove si trova 01273188 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di 01273188 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 gen 2010
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 ott 2010
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2009

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per 01273188 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al03 apr 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma17 apr 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 01273188 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per 01273188 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed kierbeck\certificate issued on 26/11/14
    CERTNM

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    13 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 nov 2011

    11 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 16 nov 2010

    12 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Keirbeck Wharf River Road Barking Essex IG11 0DG* in data 02 ago 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    11 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    33 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    2 pagine2.12B

    Nomina di Mr Krishan Chand Attawar come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jeffrey Peanick come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mag 2010

    Stato del capitale al 20 mag 2010

    • Capitale: GBP 1,856
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jeffrey Lou Peanickl il 03 apr 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2009

    20 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    5 pagineMG01

    Nomina di Mr Jeffrey Lou Peanickl come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Martin Woods come amministratore

    2 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di 01273188 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ATTAWAR, Krishan Chand
    Belmont Close
    ME16 9DY Maidstone
    17
    Kent
    England
    Amministratore
    Belmont Close
    ME16 9DY Maidstone
    17
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector151592490001
    LYNCH, Cornelius Finbarr
    68 Leyspring Road
    E11 3BX London
    Amministratore
    68 Leyspring Road
    E11 3BX London
    EnglandIrishEngineer70335650001
    O'CONNELL, Brendan Kelvin
    57 The Causeway
    EN6 5HF Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    57 The Causeway
    EN6 5HF Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor89136910001
    ALEXANDER, Michael
    Stammers Farm, Ulting Lane
    Ulting
    CM9 6QZ Maldon
    Essex
    Segretario
    Stammers Farm, Ulting Lane
    Ulting
    CM9 6QZ Maldon
    Essex
    British141199110001
    EGAN, James Michael
    Nazeing Park Betts Lane
    Nazeing
    EN9 2DN Waltham Abbey
    Essex
    Segretario
    Nazeing Park Betts Lane
    Nazeing
    EN9 2DN Waltham Abbey
    Essex
    Irish10191280002
    O'CONNELL, Brendan Kelvin
    57 The Causeway
    EN6 5HF Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    57 The Causeway
    EN6 5HF Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishChartered Surveyor89136910001
    BYRNE, Rosa L
    22 Roding Lane North
    Woodford Bridge
    IG8 8NN Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    22 Roding Lane North
    Woodford Bridge
    IG8 8NN Woodford Green
    Essex
    EnglishManageress32398720002
    CONCANNON, John
    117 Slough Lane
    Kingsbury
    NW9 8YD London
    Amministratore
    117 Slough Lane
    Kingsbury
    NW9 8YD London
    BritishFactory Manager13069800001
    EGAN, James Michael
    Nazeing Park Betts Lane
    Nazeing
    EN9 2DN Waltham Abbey
    Essex
    Amministratore
    Nazeing Park Betts Lane
    Nazeing
    EN9 2DN Waltham Abbey
    Essex
    IrishGeneral Manager10191280002
    GARNHAM, Peter
    7 Bramston Close
    Great Baddow
    CM2 7EW Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    7 Bramston Close
    Great Baddow
    CM2 7EW Chelmsford
    Essex
    IrishYard Manager10183470001
    PEANICK, Jeffrey Lou
    River Road
    IG11 0DG Barking
    Keirbeck Wharf
    Essex
    Amministratore
    River Road
    IG11 0DG Barking
    Keirbeck Wharf
    Essex
    EnglandUnited States Of America CitizenCeo150404310001
    WOODS, Martin Anthony
    Coolbanagher Emo
    Co. Laois
    Eire
    Amministratore
    Coolbanagher Emo
    Co. Laois
    Eire
    IrishCompany Director139909540001

    01273188 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 01 apr 2010
    Consegnato il 15 apr 2010
    In corso
    Importo garantito
    £768,797.11 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Goodwill and any uncalled capital and a floating charge over the undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Thamesteel Limited
    Transazioni
    • 15 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 16 nov 2009
    Consegnato il 28 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,500,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Van Merksteijn Steel Netherlands B.V.
    Transazioni
    • 28 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 15 ott 2009
    Consegnato il 17 ott 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £75,000 credited to account designation 49816691 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 05 mar 2008
    Consegnato il 08 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leumi Abl Limited
    Transazioni
    • 08 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 dic 2007
    Consegnato il 21 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 29 mar 2007
    Consegnato il 02 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leumi Abl Limited
    Transazioni
    • 02 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 06 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Unit 1 a kierbeck business comples north woolwich road silvertown london, unit 10 kierbeck business comples north wollwich road silvertown london kierbeck wharf. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Enterprise Finance Europe (UK) Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Insurance premium plan
    Creato il 11 nov 2003
    Consegnato il 19 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Assigns to the bank the benefit of the policy and all moneys bonuses profits and additions thereunder.policy nos 66001261 (aig europe (UK) limited, H9H039831 (hsb engineering) for details of furthe policies charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC T/as Allied Irish Bank (GB)
    Transazioni
    • 19 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge over chattels
    Creato il 05 set 2003
    Consegnato il 10 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The fixed assets :- 1 x mosa GE55 psx super silences welding generator ser/no 840550100004, 1 x sdmo NS80 electric generator 80 kva (1992) s/no S60996, 1 x la roche LRC50 re-bar cropping machine s/NO3836 (for further details of the property charged please refer to the form 395) together with the proceeds and anyproducts resulting from the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transazioni
    • 10 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 04 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kierbeck Holdings Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge over assets
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 03 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nmb-Heller Limited and/or Any Receiver
    Transazioni
    • 03 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Insurance premium
    Creato il 08 gen 2003
    Consegnato il 15 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies that may become payable to the company under or in respect of the insurance policies listed zurich insurance company renewal date 01/10/2003 risks insured commercial combined liability,zurich insurance company renewal date 01/10/2003 risks insured combined liability and zurich insurance company renewal date 01/10/2003 property owners for details of further details policies please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 15 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 nov 1996
    Consegnato il 04 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the land and buildings on the south side of north woolwich road silvertown in the london borough of newham t/n-EGL348945 the company also charged by way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses from time to time carried on by or for the account of the company upon all or any part of the mortgaged property ("the goodwill"). The company also charged by way of floating security all moveable plant, machinery, implements, furniture, equipment, stock-in-trade, work-in-progress and other chattels of the company at any time placed on or used in or about the mortgaged property.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 04 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 nov 1996
    Consegnato il 03 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Three parcels of land lying to the south west of betts lane nazeing in district of epping forest essex t/o EX559325. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposits
    Creato il 26 set 1996
    Consegnato il 01 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge over any sums deposited or to be deposited by the company in any deposit account of the company held with the security trustee at any of its branches. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 01 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 ott 1994
    Consegnato il 28 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a steel wharf, 30/34 (even nos) river road barking t/no.NGL21199 and goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks Plcas Trustee for Itself and Aib Finance Limited
    Transazioni
    • 28 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the heron ind; estate t/n EGL97739 and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC (As Security Trustee for Itself and Aib Finance Limited)
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a limmer wharf river road barking t/n EGL254383 and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC (As Security Trustee for Itself and Aib Finance Limited)
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC (As Security Trustee for Itself and Aib Finance Limited)
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 10,11,12 and 14 marshgate lane stratford t/n NGL109691 and l/h property k/a part of above t/n NGL109689 and the goodwill of the businedd. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Bank PLC (As Security Trustee for Itself and Aib Finance Limited)
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H prperty k/a unit 3 francis court elizabeth way harlow t/n EX323189 and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC (As Securirty Trustee for Itself and Aib Finance Limited)
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a east of pudding mill lane stratford london t/NEGL262633 and l/h property k/a 35/39 marshgate lane stratford t/n EGL271284 and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC (The Security Trustee for Itself and Aib Finance Limited)
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 giu 1993
    Consegnato il 12 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 20/05/93
    Brevi particolari
    F/H limmer wharf river road barking t/n egl 254386.
    Persone aventi diritto
    • Banco Central Hispanoamericano S.A.
    Transazioni
    • 12 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement
    Creato il 13 nov 1992
    Consegnato il 19 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £26,396.16 under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All rights title interest in and to all sums due under the insurances.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 19 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 giu 1991
    Consegnato il 24 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Banco Central S.A.
    Transazioni
    • 24 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    01273188 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 mag 2010Inizio dell'amministrazione
    16 nov 2010Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael James Wellard
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    2
    DataTipo
    16 nov 2010Inizio della liquidazione
    18 giu 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael James Wellard
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0