MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED

MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01275799
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ELLIS & CO (LIFE & PENSION BROKERS) LIMITED21 gen 198821 gen 1988
    MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED23 dic 198723 dic 1987
    ELLIS & CO. (LIFE & PENSION BROKERS) LIMITED23 feb 198223 feb 1982
    ELLIS & CO. (LIFE AND PENSION CONSULTANTS) LIMITED03 set 197603 set 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a 15 Canada Square London E14 5GL in data 17 lug 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 21 giu 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF England a 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di John Robert Porteous come amministratore in data 28 feb 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Wadham St.John Downing come amministratore in data 21 feb 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O: Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL a C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL in data 02 nov 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Mrs Rehana Hasan come segretario in data 31 ott 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 31 ott 2016

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Robert Alan Devey come amministratore in data 29 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Vernon Wright come amministratore in data 30 giu 2016

    1 pagineTM01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata C/O C/O: Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL

    1 pagineAD04

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF

    1 pagineAD03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 dic 2015

    Stato del capitale al 21 dic 2015

    • Capitale: GBP 45,020
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Jacqueline Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a C/O C/O: Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL in data 21 dic 2015

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 lug 2016 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da 60 Queen Victoria Street London EC4N 4TR a C/O Jacqueline Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL in data 14 ago 2015

    1 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 3rd Floor City Point 29 King Street Leeds LS1 2HL England a Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 60 Queen Victoria Street London EC4N 4TR

    1 pagineAD04

    Chi sono gli amministratori di MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HASAN, Rehana
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Segretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    217678430001
    DOWNING, Wadham St. John
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    England
    Amministratore
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    England
    EnglandBritish203301710001
    BELLAMY, Martin William
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Segretario
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    173987310001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    c/o C/O: Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Segretario
    c/o C/O: Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    197502480001
    JOHNSTON, Carol Ann
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    Segretario
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    British52538020003
    MADELEY, Keith Douglas
    21 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    Segretario
    21 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    British2265960002
    MADELEY, Stuart Andrew
    4 Woodlea Park
    Meanwood
    LS6 4SH Leeds
    Segretario
    4 Woodlea Park
    Meanwood
    LS6 4SH Leeds
    British43205950002
    NICHOLS, Sarah
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    Segretario
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    British157370890001
    PEACOCK, Natasha Valerie
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    Segretario
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    British129803720001
    SPRECKLEY, Antony
    311 Oxford Road
    Gomersal
    BD19 4LA Cleckheaton
    West Yorkshire
    Segretario
    311 Oxford Road
    Gomersal
    BD19 4LA Cleckheaton
    West Yorkshire
    British2236720001
    BEARDSMORE, David Eric
    The Old Bakehouse
    High Street
    DT10 2LJ Stalbridge
    Dorset
    Amministratore
    The Old Bakehouse
    High Street
    DT10 2LJ Stalbridge
    Dorset
    BritainBritish40464420003
    BRADSHAW, Phillip Gordon
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish26428400002
    COATS, Peter Herbert
    Bridge Place Farm
    Camerton
    BA2 OPS Bath
    Bath And North East Somerset
    Amministratore
    Bridge Place Farm
    Camerton
    BA2 OPS Bath
    Bath And North East Somerset
    British81633470001
    DEVEY, Robert Alan
    c/o C/O: Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O: Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish146956760001
    ELLIS, John Michael
    Ellingdale 50 Effingham Road
    Harden
    BD16 1LQ Bingley
    Amministratore
    Ellingdale 50 Effingham Road
    Harden
    BD16 1LQ Bingley
    EnglandBritish2236740002
    MADELEY, Christine Muriel
    Keris Plah
    21 Oaklands Avenue Adel
    LS16 8NR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Keris Plah
    21 Oaklands Avenue Adel
    LS16 8NR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish72770620001
    MADELEY, Keith Douglas
    21 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    Amministratore
    21 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    United KingdomBritish2265960002
    MADELEY, Stuart Andrew
    4 Woodlea Park
    Meanwood
    LS6 4SH Leeds
    Amministratore
    4 Woodlea Park
    Meanwood
    LS6 4SH Leeds
    British43205950002
    POLIN, Jonathan Charles
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    ScotlandBritish97840060003
    PORTEOUS, John Robert
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish166212270001
    SINCLAIR, Richard Harris
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish204668540001
    SPRECKLEY, Antony
    311 Oxford Road
    Gomersal
    BD19 4LA Cleckheaton
    West Yorkshire
    Amministratore
    311 Oxford Road
    Gomersal
    BD19 4LA Cleckheaton
    West Yorkshire
    British2236720001
    TAGLIABUE, Alfio
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomItalian76352220004
    WILKINSON, Patrick Richard
    The Old School House
    Thorner
    LS14 3ED Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old School House
    Thorner
    LS14 3ED Leeds
    West Yorkshire
    British99559630001
    WRIGHT, Paul Vernon
    c/o C/O: Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O: Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish137936580001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    06 apr 2016
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04918786
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment of agent's income
    Creato il 30 set 2004
    Consegnato il 12 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All commissions bonuses profits additions benefits and other monies paid or payable by an insurer. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Investment Group Limited
    Transazioni
    • 12 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 lug 2001
    Consegnato il 04 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed
    Brevi particolari
    All its right and entitlement to the rent deposit monies including the initial deposit of £8,550 plus vat.
    Persone aventi diritto
    • Hemingway Atlas Limited
    Transazioni
    • 04 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 dic 1993
    Consegnato il 18 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Mark manor 5 & 7 russell street little horton bradford west yorkshire with fixtures & fittings (other than trade) plant machinery & A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MANOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 lug 2018Data di scioglimento
    21 giu 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0