ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED

ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01277502
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FTMF LEASING MARCH (E) LIMITED01 apr 199701 apr 1997
    FORWARD MOTOR FINANCE LIMITED01 mar 199501 mar 1995
    GRIFFIN DISCOUNT LIMITED16 set 197616 set 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Seconda presentazione per la nomina di Crispin Robert John Irvin come amministratore

    6 pagineRP04AP01

    Cessazione della carica di John Richard Kent come amministratore in data 31 mag 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Rob Irvin come amministratore in data 22 mar 2017

    3 pagineAP01
    Note
    DataNota
    07 giu 2017Clarification A second filed AP01 was registered on 07/06/2017.

    Cessazione della carica di Michael Connelly Anderson come amministratore in data 22 mar 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    26 pagineAA

    Cessazione della carica di Robin Louis Henning Bencard come amministratore in data 01 ago 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2016

    Stato del capitale al 05 mag 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr Simon Einar Long come amministratore in data 15 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David John Cavanna come amministratore in data 31 dic 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Michael Connelly Anderson come amministratore in data 16 dic 2015

    2 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    18 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Nomina di Ms Romana Lewis come segretario in data 12 giu 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 12 giu 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2015

    Stato del capitale al 08 mag 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Tony Bhambhra come segretario in data 05 gen 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 05 gen 2015

    2 pagineAP03

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    18 pagineAA

    Nomina di Tony Bhambhra come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Katherine Dean come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Segretario
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    198529700001
    IRVIN, Crispin Robert John
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish228671160001
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Segretario
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    188917860001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180092010001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Segretario
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Segretario
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Segretario
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Segretario
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Segretario
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Segretario
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194209440001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154950760001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    166967360001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Amministratore
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    DEVENISH, William Frederick
    12 Hyde Place
    OX2 7JB Oxford
    Amministratore
    12 Hyde Place
    OX2 7JB Oxford
    British52830160002
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Amministratore
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Amministratore
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Amministratore
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HOLMES, Timothy Victor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Amministratore
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British28497420002
    KELL, Christopher Raymond
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    British87307470001
    KENNY, Mary Bridget
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    Amministratore
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    United KingdomBritish118995490002
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LANE, Robert David
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    Amministratore
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    EnglandBritish150099050001
    MEAD, David Harry
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish254170760001
    PICKEN, Graham Edward
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    Amministratore
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    British144947830001
    QUINN, Noel Paul
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    British72093050001
    SENIOR, Carl Thomas
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish165728830001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    26 ott 2016
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione229341
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Specific legal mortgage (no 10)
    Creato il 27 feb 2004
    Consegnato il 11 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the equipment identified by the serial numbers described in or attached to schedule 1 to such first priority mortgage, the benefit of all insurances of the specific equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 11 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Specific legal mortgage (no 9)
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 02 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The equipment as specifid in first priority mortgage (specific equipment) , all insurances, compensation payable and warranties, contracts or other agreements relating to the specific equipment.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 02 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Specific legal mortgage (no 8)
    Creato il 31 ott 2003
    Consegnato il 04 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The equipment identified by the serial numbers described in or attached to schedule 1 to such first priority mortgage; the benefit of all insurances of the specific equipment; any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment; and all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 04 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Specific legal mortgage (no 7)
    Creato il 30 set 2003
    Consegnato il 02 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest present and future in and to the equipment described in schedule 1 of the first priority mortgage (specific equipment) the benefit of all insurances of the specific equipment, any compensation payable in respect of the compulsory purchase or requisition for title of the specific equipment and all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 02 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Specific legal mortgage (no 6)
    Creato il 29 ago 2003
    Consegnato il 08 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest present and future in and to the equipment described in schedule 1 of the charge (specific equipment) the benefits of all insurances of the specific equipment any compensation payable in respect of the compulsory acquisition for title of the specific equipment all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 08 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    First priority mortgage
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 05 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest present and future in and to the equipment, the benefit of all insurances of the specific equiptment, any compensation payable, all warranties, contracts or other agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A first priority mortgage
    Creato il 30 giu 2003
    Consegnato il 01 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The equipment, the benefit of all insurances of the specific equipment, any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment and all warraties contracts or other agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 01 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A first priority mortgage
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 03 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the equipment (as further defined therein) the benefit of all insurances, any compensation payable and all warranties contracts or other agreements in respect of the said equioment.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 03 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    First priority mortgage
    Creato il 30 apr 2003
    Consegnato il 07 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The equipment and the benefit of all insurances of the specific equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 07 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A first priority mortgage
    Creato il 31 mar 2003
    Consegnato il 04 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest present and future in and to: (a) the equipment (b) the benefit of all insurances of the specific equipment (c) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment, and (d) all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use of repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyds Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An account assignment
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 04 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company's right, title and interest present and future in and to: (a) the interest bearing dollar account of the company opened by the company with citibank international PLC designated "p&o re asset finance december (w) limited (lessor proceeds ACCOUNT0" and with account number 0020482508 and with swift address "CITTGB2LELA" (the "account") and any re-designation and sub-accounts of the account (b) the moneys, interest and other amounts from time to time credited to, and for the time being standing to the credit of, the account, and (c) any certificates of deposits, deposit receipt or other instruments or securities relating to the items described above. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A first priority mortgage
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 04 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right, title, interest and benefit (if any) present and future in and to: (a) the equipment (b) the benefit of all insurances of the equipment, and (c) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0