DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED
Panoramica
Nome della società | DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01278095 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O MAZARS LLP Tower Bridge House St. Katharines Way E1W 1DD London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TREE HOUSE PROPERTY LIMITED | 21 set 1976 | 21 set 1976 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di beni vacanti | 1 pagine | BONA | ||||||||||
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU England a Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD in data 23 ott 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 5 Churchill Place Canary Wharf London E14 5HU | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di Balfour Beatty Plc come persona con controllo significativo il 18 gen 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Balfour Beatty Property Investments Limited (In Members' Voluntary Liquidation) come persona con controllo significativo il 18 gen 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 apr 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Ross Mercer come amministratore in data 28 mar 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Robert Astin come amministratore in data 28 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Bnoms Limited il 09 dic 2015 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Fourth Floor 130 Wilton Road London SW1V 1LQ a 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU in data 09 dic 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Andrew Robert Astin come amministratore in data 04 ago 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher William Healy come amministratore in data 03 ago 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Christopher William Healy come amministratore in data 27 apr 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin Terence Alan Purvis come amministratore in data 27 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNOMS LIMITED | Segretario | Churchill Place Canary Wharf E14 5HU London 5 England England | 67896020002 | |||||||
MERCER, David Ross | Amministratore | St. Katharines Way E1W 1DD London Tower Bridge House | England | British | Solicitor | 211137990001 | ||||
TAYLOR, Bryan Mark | Amministratore | St. Katharines Way E1W 1DD London Tower Bridge House | United Kingdom | British | Company Director | 92126770002 | ||||
FLINT, Henry Lawrence | Segretario | Orchard End House Orchard End Bulford SP4 9EA Salisbury Wiltshire | British | Finance Director | 78490580001 | |||||
MACINTOSH, Kenneth | Segretario | Woodpecker Cottage Keysworth BH20 7BH Wareham Dorset | British | 9297490001 | ||||||
MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Segretario | Shore Road PO18 8HZ Bosham Cob Cottage West Sussex | British | 34131020003 | ||||||
ASTIN, Andrew Robert | Amministratore | Churchill Place Canary Wharf E14 5HU London 5 England England | England | British | Chartered Secretary | 200138200001 | ||||
BARKER, Kenneth William | Amministratore | Millmead Cottage West Street Winterbourne Stickland DT11 0NT Blandford Dorset | British | Director | 9297500002 | |||||
DYBALL, Adrian Stuart Brennan | Amministratore | 4 Cornwall Road TW1 3LS Twickenham London | British | Company Director | 58499000002 | |||||
DYBALL, Peter Brennan | Amministratore | West Park Farm Colehill BH16 6BS Lytchett Matravers Dorset | British | Director | 9289300001 | |||||
FLINT, Henry Lawrence | Amministratore | Orchard End House Orchard End Bulford SP4 9EA Salisbury Wiltshire | England | British | Finance Director | 78490580001 | ||||
GOLDSMITH, Paul William | Amministratore | 102 Fawnbrake Avenue Herne Hill SE24 0BZ London | England | British | Director | 28639100003 | ||||
HARDACRE, Guy Pitt | Amministratore | 1 Forest Meadows Hythe SO45 3RH Southampton | England | British | Company Director | 72271690001 | ||||
HEALY, Christopher William | Amministratore | 130 Wilton Road SW1V 1LQ London Fourth Floor | United Kingdom | British | Solicitor | 197650570001 | ||||
HIRST, Martin Beverley Bodenham | Amministratore | Treview Windfield Drive Winchester Hill SO41 0RA Romsey Hampshire | England | British | Director | 9289310002 | ||||
MACINTOSH, Kenneth | Amministratore | Woodpecker Cottage Keysworth BH20 7BH Wareham Dorset | British | Director | 9297490001 | |||||
MCNAUGHTON, Andrew James | Amministratore | 8 Sparrow Way RH15 9UL Burgess Hill West Sussex | British | Civil Engineer | 101231740001 | |||||
MEDHURST, Alexander Clyde | Amministratore | Orchards 39 St Paul's Road PO19 3BJ Chichester West Sussex | British | Surveyor | 116706680001 | |||||
MOLLOY, John Francis | Amministratore | 10 Bristol Road Southsea PO4 9QH Portsmouth Hampshire | Irish | Director | 52412920002 | |||||
PEASLAND, Michael John | Amministratore | 48 Bathgate Road Wimbledon SW19 5PJ London | United Kingdom | British | Director | 714450006 | ||||
PETERS, Mark David | Amministratore | 130 Wilton Road SW1V 1LQ London Fourth Floor | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 192348430001 | ||||
PURVIS, Martin Terence Alan | Amministratore | 130 Wilton Road SW1V 1LQ London Fourth Floor | United Kingdom | British | Director | 7901050001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balfour Beatty Plc | 18 gen 2018 | Churchill Place Canary Wharf E14 5HU London 5 England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Balfour Beatty Property Investments Limited (In Members' Voluntary Liquidation) | 06 apr 2016 | St Katharine's Way E1W 1DD London Tower Bridge House United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
An omnibus guarantee and set-off agreement dated 23 january 2002 and | Creato il 16 dic 2008 Consegnato il 24 dic 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 01 ott 2007 Consegnato il 09 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The new justice centre wilton road salisbury,. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 01 ott 2007 Consegnato il 03 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 23/01/2002 | Creato il 20 set 2005 Consegnato il 22 set 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present and future account of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 11 feb 2000 Consegnato il 18 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land lying to the south of gorsey lane coleshill also k/a unit 27 roman way coleshill industrial estate t/n WK260754. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent account deed | Creato il 04 dic 1996 Consegnato il 11 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed | |
Brevi particolari A rent account opened with the chargee now or in the future to receive all rents and income from property at london road addington kent t/n K382893. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 04 dic 1996 Consegnato il 11 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at london road addington kent forming part of t/n K362893 with all right title and interest in any proceeds of insurances, together with all buildings structures fixtures fixed plant and machinery and equipment thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub-mortgage | Creato il 30 nov 1994 Consegnato il 12 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land north of northney road hayling island hampshire t/n HP455088 all right title and interest of the company in the land. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 22 ott 1993 Consegnato il 27 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a land on the north side of northney road hayling island with all buldings and fixtures t/no HP455088 and by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 24 lug 1991 Consegnato il 25 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property being land on the north side of fort cumberland road eastney title no. HP327535. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 24 lug 1991 Consegnato il 25 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property being land at london road addington kent title no K362839 (see 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 20 dic 1990 Consegnato il 08 gen 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 20 acres of undeveloped land at the rear of the nuffield industrial estate. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Single debenture | Creato il 31 mag 1990 Consegnato il 04 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 06 dic 1979 Consegnato il 11 dic 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property known as heron road sowton industrial estate, exeter devon.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0