DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED

DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01278095
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O MAZARS LLP
    Tower Bridge House St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TREE HOUSE PROPERTY LIMITED21 set 197621 set 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA
    RA11U25F

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagineLIQ13
    A8J5X6FE

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU England a Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD in data 23 ott 2018

    2 pagineAD01
    A7FHUNE3

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 5 Churchill Place Canary Wharf London E14 5HU

    2 pagineAD02
    A7FHUNEB

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600
    A7FHUNDV

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01
    A7FHUNDF

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 21 set 2018

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA
    R7BY6S2Z

    Notifica di Balfour Beatty Plc come persona con controllo significativo il 18 gen 2018

    2 paginePSC02
    X7AG7761

    Cessazione di Balfour Beatty Property Investments Limited (In Members' Voluntary Liquidation) come persona con controllo significativo il 18 gen 2018

    1 paginePSC07
    X7AG773U

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    X73YMRAW

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA
    R6EHH7Y1

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01
    X645PE21

    Nomina di Mr David Ross Mercer come amministratore in data 28 mar 2017

    2 pagineAP01
    X63N8Z28

    Cessazione della carica di Andrew Robert Astin come amministratore in data 28 mar 2017

    1 pagineTM01
    X63CWUBD

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    5 pagineAA
    A5E79AZ5

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2016

    Stato del capitale al 28 apr 2016

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01
    X55UHNVV

    Dettagli del segretario cambiati per Bnoms Limited il 09 dic 2015

    1 pagineCH04
    X4LYZUPS

    Indirizzo della sede legale modificato da Fourth Floor 130 Wilton Road London SW1V 1LQ a 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU in data 09 dic 2015

    1 pagineAD01
    X4LWCL2Q

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA
    A4F5KEBV

    Nomina di Andrew Robert Astin come amministratore in data 04 ago 2015

    3 pagineAP01
    R4DBCF17

    Cessazione della carica di Christopher William Healy come amministratore in data 03 ago 2015

    1 pagineTM01
    X4D237GI

    Nomina di Christopher William Healy come amministratore in data 27 apr 2015

    3 pagineAP01
    R479TQ37

    Cessazione della carica di Martin Terence Alan Purvis come amministratore in data 27 apr 2015

    1 pagineTM01
    X4694U5V

    Chi sono gli amministratori di DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BNOMS LIMITED
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Segretario
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    67896020002
    MERCER, David Ross
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Amministratore
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    EnglandBritishSolicitor211137990001
    TAYLOR, Bryan Mark
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Amministratore
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritishCompany Director92126770002
    FLINT, Henry Lawrence
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    BritishFinance Director78490580001
    MACINTOSH, Kenneth
    Woodpecker Cottage Keysworth
    BH20 7BH Wareham
    Dorset
    Segretario
    Woodpecker Cottage Keysworth
    BH20 7BH Wareham
    Dorset
    British9297490001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    Cob Cottage
    West Sussex
    Segretario
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    Cob Cottage
    West Sussex
    British34131020003
    ASTIN, Andrew Robert
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    EnglandBritishChartered Secretary200138200001
    BARKER, Kenneth William
    Millmead Cottage West Street
    Winterbourne Stickland
    DT11 0NT Blandford
    Dorset
    Amministratore
    Millmead Cottage West Street
    Winterbourne Stickland
    DT11 0NT Blandford
    Dorset
    BritishDirector9297500002
    DYBALL, Adrian Stuart Brennan
    4 Cornwall Road
    TW1 3LS Twickenham
    London
    Amministratore
    4 Cornwall Road
    TW1 3LS Twickenham
    London
    BritishCompany Director58499000002
    DYBALL, Peter Brennan
    West Park Farm
    Colehill
    BH16 6BS Lytchett Matravers
    Dorset
    Amministratore
    West Park Farm
    Colehill
    BH16 6BS Lytchett Matravers
    Dorset
    BritishDirector9289300001
    FLINT, Henry Lawrence
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritishFinance Director78490580001
    GOLDSMITH, Paul William
    102 Fawnbrake Avenue
    Herne Hill
    SE24 0BZ London
    Amministratore
    102 Fawnbrake Avenue
    Herne Hill
    SE24 0BZ London
    EnglandBritishDirector28639100003
    HARDACRE, Guy Pitt
    1 Forest Meadows
    Hythe
    SO45 3RH Southampton
    Amministratore
    1 Forest Meadows
    Hythe
    SO45 3RH Southampton
    EnglandBritishCompany Director72271690001
    HEALY, Christopher William
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    Fourth Floor
    Amministratore
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    Fourth Floor
    United KingdomBritishSolicitor197650570001
    HIRST, Martin Beverley Bodenham
    Treview
    Windfield Drive Winchester Hill
    SO41 0RA Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    Treview
    Windfield Drive Winchester Hill
    SO41 0RA Romsey
    Hampshire
    EnglandBritishDirector9289310002
    MACINTOSH, Kenneth
    Woodpecker Cottage Keysworth
    BH20 7BH Wareham
    Dorset
    Amministratore
    Woodpecker Cottage Keysworth
    BH20 7BH Wareham
    Dorset
    BritishDirector9297490001
    MCNAUGHTON, Andrew James
    8 Sparrow Way
    RH15 9UL Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    8 Sparrow Way
    RH15 9UL Burgess Hill
    West Sussex
    BritishCivil Engineer101231740001
    MEDHURST, Alexander Clyde
    Orchards
    39 St Paul's Road
    PO19 3BJ Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Orchards
    39 St Paul's Road
    PO19 3BJ Chichester
    West Sussex
    BritishSurveyor116706680001
    MOLLOY, John Francis
    10 Bristol Road
    Southsea
    PO4 9QH Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    10 Bristol Road
    Southsea
    PO4 9QH Portsmouth
    Hampshire
    IrishDirector52412920002
    PEASLAND, Michael John
    48 Bathgate Road
    Wimbledon
    SW19 5PJ London
    Amministratore
    48 Bathgate Road
    Wimbledon
    SW19 5PJ London
    United KingdomBritishDirector714450006
    PETERS, Mark David
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    Fourth Floor
    Amministratore
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    Fourth Floor
    United KingdomBritishChartered Secretary192348430001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    Fourth Floor
    Amministratore
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    Fourth Floor
    United KingdomBritishDirector7901050001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    18 gen 2018
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company (Listed)
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione395826
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2343440
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set-off agreement dated 23 january 2002 and
    Creato il 16 dic 2008
    Consegnato il 24 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 2007
    Consegnato il 09 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The new justice centre wilton road salisbury,. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 ott 2007
    Consegnato il 03 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 23/01/2002
    Creato il 20 set 2005
    Consegnato il 22 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present and future account of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 11 feb 2000
    Consegnato il 18 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land lying to the south of gorsey lane coleshill also k/a unit 27 roman way coleshill industrial estate t/n WK260754. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent account deed
    Creato il 04 dic 1996
    Consegnato il 11 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed
    Brevi particolari
    A rent account opened with the chargee now or in the future to receive all rents and income from property at london road addington kent t/n K382893.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 11 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 dic 1996
    Consegnato il 11 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at london road addington kent forming part of t/n K362893 with all right title and interest in any proceeds of insurances, together with all buildings structures fixtures fixed plant and machinery and equipment thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 11 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 10 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creato il 30 nov 1994
    Consegnato il 12 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land north of northney road hayling island hampshire t/n HP455088 all right title and interest of the company in the land. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 ott 1993
    Consegnato il 27 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land on the north side of northney road hayling island with all buldings and fixtures t/no HP455088 and by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property being land on the north side of fort cumberland road eastney title no. HP327535.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property being land at london road addington kent title no K362839 (see 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 dic 1990
    Consegnato il 08 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 20 acres of undeveloped land at the rear of the nuffield industrial estate. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 31 mag 1990
    Consegnato il 04 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 06 dic 1979
    Consegnato il 11 dic 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property known as heron road sowton industrial estate, exeter devon.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 10 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DEAN & DYBALL DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 set 2018Inizio della liquidazione
    02 mar 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0