TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED

TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01279747
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HURST PUBLISHING LIMITED01 ott 197601 ott 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 mar 2016

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio redatto al 29 mar 2015

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Joanne Walker come amministratore in data 22 giu 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 mag 2015

    Stato del capitale al 28 mag 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Joanne Walker il 18 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Somerset il 17 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Sean Robert Glithero il 17 mar 2015

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Auto Trader House Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Reading Berkshire RG6 4UT a 1 Tony Wilson Place Manchester England M15 4FN in data 23 dic 2014

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Tara Collet come amministratore in data 03 ott 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Ian Somerset come amministratore in data 25 set 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 mag 2014

    Stato del capitale al 28 mag 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Joanne Walker come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Zillah Byng-Maddick come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 01 apr 2012

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 03 apr 2011

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Stephen Lane come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Tara Collet come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GLITHERO, Sean
    Hyde End Road
    Spencers Wood
    RG7 1DL Reading
    262
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Hyde End Road
    Spencers Wood
    RG7 1DL Reading
    262
    Berkshire
    United Kingdom
    159905020001
    GLITHERO, Sean Robert
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Amministratore
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritishAccountant129229070002
    SOMERSET, Ian
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Amministratore
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritishGroup Financial Controller191225040001
    BESWITHERICK, David Peter
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    Segretario
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    BritishAccountant15959630001
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    Segretario
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    British6848030001
    HOLLAND, Steven John
    10/12 Ramsbottom Road
    Hawkshaw
    BL8 4JS Bury
    Lancashire
    Segretario
    10/12 Ramsbottom Road
    Hawkshaw
    BL8 4JS Bury
    Lancashire
    BritishAccountant72060560001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    JENKIN, Elizabeth
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    British137518870001
    LACEY, Eugenia
    151 Ash Street
    GU12 6LJ Ash
    Surrey
    Segretario
    151 Ash Street
    GU12 6LJ Ash
    Surrey
    BritishGroup Treasurer79114130001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Segretario
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    BritishDirector162220750001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Segretario
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Segretario
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South AfricanAccountant97879810002
    BYNG-MADDICK, Zillah Ellen
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Finance Officer147214630001
    COLLET, Tara
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    Amministratore
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Financial Controller160951420001
    GIBBONS, Paul
    Oakleigh House
    Bere Court Road
    RG8 8JU Pangbourne
    Berkshire
    Amministratore
    Oakleigh House
    Bere Court Road
    RG8 8JU Pangbourne
    Berkshire
    United KingdomBritishPublisher8699020002
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    Amministratore
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    BritishAccountant6848030001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    BritishAccountant86019470001
    LANE, Stephen John Roger
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    Amministratore
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant123670600001
    LUFF, Graham Ewart
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Executive46555440002
    MADEJSKI, Robert John, Sir
    Northcourt
    Pangbourne
    RG8 8PT Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Northcourt
    Pangbourne
    RG8 8PT Reading
    Berkshire
    EnglandBritishPublisher42866240001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    Amministratore
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    EnglandUnited KingdomCo Director155633620001
    PALLEY, Simon Dan
    32 Regents Park Road
    NW1 7TR London
    Amministratore
    32 Regents Park Road
    NW1 7TR London
    BritishInvestment Adviser17925410001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South AfricanAccountant97879810002
    RILEY, Ian
    Cokes Lane House Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cokes Lane House Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishInvestment Manager59747560002
    STOREY, Graham Neil
    Treetops
    Garden Close Lane
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Treetops
    Garden Close Lane
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector48939070004
    WALKER, Joanne
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Amministratore
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritishGroup Hr Director180119580001

    TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Global accession deed
    Creato il 03 ott 2003
    Consegnato il 10 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 10 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture , supplementing and amending a debenture dated 21/07/98 between the company and each of the companies listed therein
    Creato il 24 mag 2000
    Consegnato il 08 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present ans future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever ) of each obligor to the lenders (or any of them) under each of the senior finance documents, the senior subordinated facility agreement and the hedging documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 08 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 lug 1998
    Consegnato il 07 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under the terms of each or any of the senior finance documents the mezzanine finance documents and the hedging documents (all as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutche Bank Ag London(As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders)
    Transazioni
    • 07 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 17 nov 1995
    Consegnato il 17 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof being one new kodak photo C.D. imaging workstation serial no:3465132 00755 K374-6055.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 17 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 nov 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (I) f/hold land - 209 king's rd,reading,berkshire; bk 182629 (ii) ...........- 211.............................;bk 169772. together with all buildings/fixtures/fittings,plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Leasing (Af) Limited and All the Other Companies Listed
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 nov 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold land on west side of first avenue,royal portbury dock,portbury,bristol,BS20 9XP with all buildings/fixtures,plant/machinery thereon; t/no av 177145.
    Persone aventi diritto
    • Forward Leasing (Af) Limited and All the Other Companies Listed
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Secured loan note 1992/1994
    Creato il 19 feb 1992
    Consegnato il 09 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transazioni
    • 09 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Secured loan note 1992/1994
    Creato il 19 feb 1992
    Consegnato il 09 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Gran Nominees Limited ("the Noteholder")
    Transazioni
    • 09 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 1991
    Consegnato il 09 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises at philips street bedminster bristol.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 apr 1991
    Consegnato il 03 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    211 kings road reading berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 apr 1991
    Consegnato il 03 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Auto trader house cutbush lane tower earley reading berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 apr 1991
    Consegnato il 03 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    209 kings road reading berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 25 apr 1991
    Consegnato il 03 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mag 1981
    Consegnato il 02 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 211 kings road, reading, berks. Bk 169772.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1980
    Consegnato il 09 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments and premises being 209 kings road reading berkshire together with all fixtures whatsoever.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 14 nov 1980
    Consegnato il 21 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on undertaking and all property and and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1980Registrazione di un'ipoteca

    TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 mar 2016Inizio della liquidazione
    21 gen 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praticante
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0