P1 ATTRACTIONS LIMITED
Panoramica
Nome della società | P1 ATTRACTIONS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01284934 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di P1 ATTRACTIONS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova P1 ATTRACTIONS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 55 Baker Street W1U 7EU London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di P1 ATTRACTIONS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TUSSAUDS ATTRACTIONS LIMITED | 08 apr 1999 | 08 apr 1999 |
WARWICK CASTLE LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
GREVILLE ENTERPRISES (WARWICK CASTLE) LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
BANIGORT LIMITED | 04 nov 1976 | 04 nov 1976 |
Quali sono gli ultimi bilanci di P1 ATTRACTIONS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per P1 ATTRACTIONS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 nov 2016 | 8 pagine | 4.68 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 15 dic 2015 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2015 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 17 set 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2010 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy James Evans il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di P1 ATTRACTIONS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMM, Sandra Louise | Segretario | Baker Street W1U 7EU London 55 | Australian | 57113450003 | ||||||
EVANS, Timothy James | Amministratore | Baker Street W1U 7EU London 55 | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 104934670002 | ||||
GUMM, Sandra Louise | Amministratore | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | Australian | Chartered Accountant | 57113450003 | ||||
LESLAU, Nicholas Mark | Amministratore | Baker Street W1U 7EU London 55 | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 6815470021 | ||||
AUSTIN, Terence Nigel | Segretario | 73 Balmoral SL6 6SX Maidenhead Berkshire | British | Chartered Accountant | 49056190001 | |||||
BURROWS, Peter Anthony | Segretario | Tregaron 44 Highland Road HP7 9AY Amersham Buckinghamshire | British | 10051840001 | ||||||
COOTE, Sarah | Segretario | 14 Byron Road Hutton CM13 2RU Brentwood Essex | British | Chartered Sectretary | 71252790001 | |||||
LESTER, Frances Joan | Segretario | 7 Beult Meadow Cage Lane Smarden TN27 8PZ Ashford Kent | British | Chartered Secretary | 63327910001 | |||||
TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Segretario | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
BARRATT, Raymond | Amministratore | Ivy Cottage Freehay Road ST10 1TR Mobberley Staffordshire | British | Business Executive | 10051870002 | |||||
BRITTON, Jill | Amministratore | Flat 6 77 Queens Gate South Kensington SW7 5JU London | British | Executive Director Brands Stra | 73984210001 | |||||
CARR, Andrew Christopher | Amministratore | 3 Market Close BH15 1NQ Poole Dorset | United Kingdom | British | Company Director | 65490970003 | ||||
CHITTICK, Gavin William | Amministratore | 19 Kitson Road SW13 9HJ Barnes London | England | British | Finance Dir | 4524080002 | ||||
DOUBLE, Michael Stockwell | Amministratore | Arden 37 Grovewood Close Chorleywood WD3 5PX Rickmansworth Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 14090870001 | |||||
EARLAM, Donald Glenn | Amministratore | Seaforth 26 Ganghill GU1 1XF Guildford Surrey | England | British | Managing Director | 96494270001 | ||||
HERBERT, Michael | Amministratore | 14 Eaton Place SW1X 8AE London | British | Chief Executive | 14090880001 | |||||
HOLLINGSWORTH, Andrew Roy | Amministratore | Dadbrook Barn Roundhill Court Oxford Road HP17 3TR Haddenham Buckinghamshire | British | Executive Director | 10051880004 | |||||
JOLLY, Michael Gordon | Amministratore | Flat 29 Harmont House 20 Harley Street W1G 9PH London | England | British | Business Executive | 110538760001 | ||||
PHILLIPSON, Peter William | Amministratore | Woodhall Grange Woodhall Lane SL5 9QW Ascot Berkshire | England | British | Director | 141295120001 | ||||
ROGER, Robert | Amministratore | 15 Meadway KT10 9HG Esher Surrey | British | Finance Director | 46751430009 | |||||
STREETS, William Henry | Amministratore | 28 Causeway RH12 1HE Horsham West Sussex | British | Business Executive | 75769930001 | |||||
TANSLEY, Philip Andrew | Amministratore | 11 Montagu Square W1H 2LD London | British | Business Executive | 73984290001 | |||||
TAYLOR, Philip Boyd | Amministratore | 23 Castlebar Road W5 2DL London | British | Business Development | 47270660002 | |||||
VARNEY, Nicholas John | Amministratore | 3 Market Close BH15 1NQ Poole Dorset | England | British | Company Director | 50480360003 | ||||
WELLS, Pauline Ruth | Amministratore | Fieldways Vicarage Road RH7 6HA Lingfield Surrey | British | Executive Director Human Resou | 53790450001 |
P1 ATTRACTIONS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage of shares | Creato il 12 mag 1999 Consegnato il 25 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities due or to become due by each obligor in clause 2.1 of the security trust deed (as defined) to the chargee in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement (as defined) | |
Brevi particolari All issued share capital of madame tussaud australia pty limited and all rights thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Pledge of shares | Creato il 12 mag 1999 Consegnato il 25 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee all monies and liabilities due or to become due from each obligor in clause 2.1 of the security trust deed (as defined) to the chargee in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement (as defined) | |
Brevi particolari All shares and voting rights/dividends thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A security trust deed made between, inter alia, the borrowers (as defined) (which terms includes tussauds attractions limited (the "company")), the parent (as defined), holdings (as defined) and the issuer (as defined) issued by the company | Creato il 12 mag 1999 Consegnato il 25 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito In favour of the chargee the moneys and liabilities which each obligor (as defined) covenants in clause 2.1 of the security trust deed to pay or discharge and all claims, demands and damages for breach of any such covenant, and references to the secured amounts includes references to any of them and following substitution of the issuer in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement also includes the issuer secured amounts (the "secured amounts") | |
Brevi particolari By way of legal mortgage f/h land on the south side of almshouse lane chessington t/n-SGL498994. F/h "burnt stub" or "burnt stubbs" chessington t/n-TGL155538. F/h land lying to the west of leatherhead road chessington t/n-SGL293017 (see for. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of accession (to a debenture and guarantee dated 12 october 1998) | Creato il 13 nov 1998 Consegnato il 19 nov 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (the security agent) under each or any of the senior finance documents, the subordinated finance documents and the hedging documents | |
Brevi particolari The f/h property k/a warwick castle grounds and stables t/n WK251524. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
P1 ATTRACTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0