P1 ATTRACTIONS LIMITED

P1 ATTRACTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàP1 ATTRACTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01284934
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di P1 ATTRACTIONS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova P1 ATTRACTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di P1 ATTRACTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TUSSAUDS ATTRACTIONS LIMITED08 apr 199908 apr 1999
    WARWICK CASTLE LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    GREVILLE ENTERPRISES (WARWICK CASTLE) LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    BANIGORT LIMITED04 nov 197604 nov 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di P1 ATTRACTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per P1 ATTRACTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 nov 2016

    8 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 15 dic 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 nov 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2015

    Stato del capitale al 01 lug 2015

    • Capitale: GBP 2,500,201
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2015

    9 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 lug 2014

    Stato del capitale al 16 lug 2014

    • Capitale: GBP 2,500,201
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 01 lug 2013

    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 17 set 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy James Evans il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di P1 ATTRACTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GUMM, Sandra Louise
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Segretario
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Australian57113450003
    EVANS, Timothy James
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritishChartered Surveyor104934670002
    GUMM, Sandra Louise
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandAustralianChartered Accountant57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritishChartered Surveyor6815470021
    AUSTIN, Terence Nigel
    73 Balmoral
    SL6 6SX Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    73 Balmoral
    SL6 6SX Maidenhead
    Berkshire
    BritishChartered Accountant49056190001
    BURROWS, Peter Anthony
    Tregaron 44 Highland Road
    HP7 9AY Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    Tregaron 44 Highland Road
    HP7 9AY Amersham
    Buckinghamshire
    British10051840001
    COOTE, Sarah
    14 Byron Road
    Hutton
    CM13 2RU Brentwood
    Essex
    Segretario
    14 Byron Road
    Hutton
    CM13 2RU Brentwood
    Essex
    BritishChartered Sectretary71252790001
    LESTER, Frances Joan
    7 Beult Meadow
    Cage Lane Smarden
    TN27 8PZ Ashford
    Kent
    Segretario
    7 Beult Meadow
    Cage Lane Smarden
    TN27 8PZ Ashford
    Kent
    BritishChartered Secretary63327910001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Segretario
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    BARRATT, Raymond
    Ivy Cottage Freehay Road
    ST10 1TR Mobberley
    Staffordshire
    Amministratore
    Ivy Cottage Freehay Road
    ST10 1TR Mobberley
    Staffordshire
    BritishBusiness Executive10051870002
    BRITTON, Jill
    Flat 6 77 Queens Gate
    South Kensington
    SW7 5JU London
    Amministratore
    Flat 6 77 Queens Gate
    South Kensington
    SW7 5JU London
    BritishExecutive Director Brands Stra73984210001
    CARR, Andrew Christopher
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Amministratore
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    United KingdomBritishCompany Director65490970003
    CHITTICK, Gavin William
    19 Kitson Road
    SW13 9HJ Barnes
    London
    Amministratore
    19 Kitson Road
    SW13 9HJ Barnes
    London
    EnglandBritishFinance Dir4524080002
    DOUBLE, Michael Stockwell
    Arden 37 Grovewood Close
    Chorleywood
    WD3 5PX Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Arden 37 Grovewood Close
    Chorleywood
    WD3 5PX Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant14090870001
    EARLAM, Donald Glenn
    Seaforth
    26 Ganghill
    GU1 1XF Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Seaforth
    26 Ganghill
    GU1 1XF Guildford
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director96494270001
    HERBERT, Michael
    14 Eaton Place
    SW1X 8AE London
    Amministratore
    14 Eaton Place
    SW1X 8AE London
    BritishChief Executive14090880001
    HOLLINGSWORTH, Andrew Roy
    Dadbrook Barn Roundhill Court
    Oxford Road
    HP17 3TR Haddenham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Dadbrook Barn Roundhill Court
    Oxford Road
    HP17 3TR Haddenham
    Buckinghamshire
    BritishExecutive Director10051880004
    JOLLY, Michael Gordon
    Flat 29 Harmont House
    20 Harley Street
    W1G 9PH London
    Amministratore
    Flat 29 Harmont House
    20 Harley Street
    W1G 9PH London
    EnglandBritishBusiness Executive110538760001
    PHILLIPSON, Peter William
    Woodhall Grange
    Woodhall Lane
    SL5 9QW Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Woodhall Grange
    Woodhall Lane
    SL5 9QW Ascot
    Berkshire
    EnglandBritishDirector141295120001
    ROGER, Robert
    15 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Amministratore
    15 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    BritishFinance Director46751430009
    STREETS, William Henry
    28 Causeway
    RH12 1HE Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    28 Causeway
    RH12 1HE Horsham
    West Sussex
    BritishBusiness Executive75769930001
    TANSLEY, Philip Andrew
    11 Montagu Square
    W1H 2LD London
    Amministratore
    11 Montagu Square
    W1H 2LD London
    BritishBusiness Executive73984290001
    TAYLOR, Philip Boyd
    23 Castlebar Road
    W5 2DL London
    Amministratore
    23 Castlebar Road
    W5 2DL London
    BritishBusiness Development47270660002
    VARNEY, Nicholas John
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Amministratore
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director50480360003
    WELLS, Pauline Ruth
    Fieldways
    Vicarage Road
    RH7 6HA Lingfield
    Surrey
    Amministratore
    Fieldways
    Vicarage Road
    RH7 6HA Lingfield
    Surrey
    BritishExecutive Director Human Resou53790450001

    P1 ATTRACTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of shares
    Creato il 12 mag 1999
    Consegnato il 25 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due by each obligor in clause 2.1 of the security trust deed (as defined) to the chargee in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement (as defined)
    Brevi particolari
    All issued share capital of madame tussaud australia pty limited and all rights thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trustee Company Limited,as Security Trustee
    Transazioni
    • 25 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge of shares
    Creato il 12 mag 1999
    Consegnato il 25 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee all monies and liabilities due or to become due from each obligor in clause 2.1 of the security trust deed (as defined) to the chargee in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement (as defined)
    Brevi particolari
    All shares and voting rights/dividends thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trustee Company Limited,the Security Trustee
    Transazioni
    • 25 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security trust deed made between, inter alia, the borrowers (as defined) (which terms includes tussauds attractions limited (the "company")), the parent (as defined), holdings (as defined) and the issuer (as defined) issued by the company
    Creato il 12 mag 1999
    Consegnato il 25 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee the moneys and liabilities which each obligor (as defined) covenants in clause 2.1 of the security trust deed to pay or discharge and all claims, demands and damages for breach of any such covenant, and references to the secured amounts includes references to any of them and following substitution of the issuer in accordance with clause 12.2 of the funding loan agreement also includes the issuer secured amounts (the "secured amounts")
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h land on the south side of almshouse lane chessington t/n-SGL498994. F/h "burnt stub" or "burnt stubbs" chessington t/n-TGL155538. F/h land lying to the west of leatherhead road chessington t/n-SGL293017 (see for. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trustee Company Limited (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 25 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession (to a debenture and guarantee dated 12 october 1998)
    Creato il 13 nov 1998
    Consegnato il 19 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (the security agent) under each or any of the senior finance documents, the subordinated finance documents and the hedging documents
    Brevi particolari
    The f/h property k/a warwick castle grounds and stables t/n WK251524. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 19 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    P1 ATTRACTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 feb 2017Data di scioglimento
    30 nov 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0