01285055 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società01285055 LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01285055
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 01285055 LIMITED?

    • (2612) /

    Dove si trova 01285055 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ground Floor Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 01285055 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DARBY GROUP PLC08 set 198808 set 1988
    MICHAEL J. DARBY (HOLDINGS) LIMITED04 nov 197604 nov 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di 01285055 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al28 feb 2010
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 nov 2010
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2009

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per 01285055 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al26 lug 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma09 ago 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 01285055 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per 01285055 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed darby group\certificate issued on 25/10/17
    pagineCERTNM

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2010

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2011

    Stato del capitale al 04 feb 2011

    • Capitale: GBP 1,381,729.7
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio redatto al 28 feb 2009

    15 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di 01285055 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    Ground Floor Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Segretario
    Ground Floor Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    36581310005
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    Amministratore
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    United KingdomBritish35557050001
    BANNISTER, Stephen John
    5 West Drive St Edwards Park
    Cheddleton
    ST13 7DW Leek
    Staffordshire
    Segretario
    5 West Drive St Edwards Park
    Cheddleton
    ST13 7DW Leek
    Staffordshire
    British115415890001
    BODDY, David Eric
    44 Horkstow Road
    DN18 5DZ Barton On Humber
    Humberside
    Segretario
    44 Horkstow Road
    DN18 5DZ Barton On Humber
    Humberside
    British34527260001
    COOPER, Robin Timothy
    6 Mayflower Court
    Austerfield
    DN10 6RZ Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    6 Mayflower Court
    Austerfield
    DN10 6RZ Doncaster
    South Yorkshire
    British108328050001
    DOVEY, Barry
    3 Woodhill Avenue
    Woodland View
    DN21 1FB Gainsborough
    Lincolnshire
    Segretario
    3 Woodhill Avenue
    Woodland View
    DN21 1FB Gainsborough
    Lincolnshire
    British34998480001
    HASWELL, Steven Hedley
    Greystones
    Brackenwell Lane North Rigton
    LS17 0DG Leeds
    North Yorkshire
    Segretario
    Greystones
    Brackenwell Lane North Rigton
    LS17 0DG Leeds
    North Yorkshire
    British16991280001
    HOPCROFT, Martin Peter
    1 The Pastures
    Edlesborough
    LU6 2HL Dunstable
    Bedfordshire
    Segretario
    1 The Pastures
    Edlesborough
    LU6 2HL Dunstable
    Bedfordshire
    British40168200002
    QUEEN, Roger Charles
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    Segretario
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    British78822570002
    ABRAHAMS, Mark Simon
    140 Clifton
    YO30 6BH York
    North Yorkshire
    Amministratore
    140 Clifton
    YO30 6BH York
    North Yorkshire
    EnglandBritish4381310001
    BABER, Ralph Peter
    Oaklands 5 Queenborough Gardens
    BR7 6NP Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Oaklands 5 Queenborough Gardens
    BR7 6NP Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish150093220001
    BANNISTER, Stephen John
    5 West Drive St Edwards Park
    Cheddleton
    ST13 7DW Leek
    Staffordshire
    Amministratore
    5 West Drive St Edwards Park
    Cheddleton
    ST13 7DW Leek
    Staffordshire
    EnglandBritish115415890001
    BODDY, David Eric
    44 Horkstow Road
    DN18 5DZ Barton On Humber
    Humberside
    Amministratore
    44 Horkstow Road
    DN18 5DZ Barton On Humber
    Humberside
    British34527260001
    COOPER, Brian
    Dew Lawn
    YO5 9QY Marton-Cum-Grafton
    York
    Amministratore
    Dew Lawn
    YO5 9QY Marton-Cum-Grafton
    York
    United KingdomBritish15446400002
    CORKE, Philip
    The Manor House
    1 Bedford Road
    MK44 3RG Moggerhanger
    Bedfordshire
    Amministratore
    The Manor House
    1 Bedford Road
    MK44 3RG Moggerhanger
    Bedfordshire
    EnglandBritish85311430001
    DARBY, Barbara Joan
    Emmerson House School Lane
    Redbourne
    DN21 4QN Gainsborough
    Lincolnshire
    Amministratore
    Emmerson House School Lane
    Redbourne
    DN21 4QN Gainsborough
    Lincolnshire
    British52184420001
    DARBY, Michael John
    New House
    School Lane
    DN21 4QN Redbourne
    Lincolnshire
    Amministratore
    New House
    School Lane
    DN21 4QN Redbourne
    Lincolnshire
    British18981290001
    DAVENPORT, Kathryn Anne
    Stoneleigh
    2 Moorfield Way
    LS29 8BX Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Stoneleigh
    2 Moorfield Way
    LS29 8BX Ilkley
    West Yorkshire
    British104948570001
    EDWARDS, Adrian Stewart
    Church Path
    CB10 1JP Saffron Walden
    2
    Essex
    Amministratore
    Church Path
    CB10 1JP Saffron Walden
    2
    Essex
    EnglandBritish101404540002
    GYLLENHAMMAR, Peter Jan Patrik Valentin
    Banergatan 3
    FOREIGN Stockholm
    Sweden
    Amministratore
    Banergatan 3
    FOREIGN Stockholm
    Sweden
    SwedenSwedish76805000001
    GYLLENHAMMER, Peter Jan Patrik Valentin
    Banergatan 3 3tr
    Stockholm
    Se-114 56
    Sweden
    Amministratore
    Banergatan 3 3tr
    Stockholm
    Se-114 56
    Sweden
    Swedish85781920001
    HARDY, Howard
    13 North Street
    DN21 2HP Gainsborough
    Lincolnshire
    Amministratore
    13 North Street
    DN21 2HP Gainsborough
    Lincolnshire
    British69084070002
    HART, Frederick Harry
    33 Foxhill
    LE15 7HB Whissendine
    Rutland
    Amministratore
    33 Foxhill
    LE15 7HB Whissendine
    Rutland
    British45291310001
    HASWELL, Steven Hedley
    Greystones
    Brackenwell Lane North Rigton
    LS17 0DG Leeds
    North Yorkshire
    Amministratore
    Greystones
    Brackenwell Lane North Rigton
    LS17 0DG Leeds
    North Yorkshire
    British16991280001
    HAYES, Michael Hugh
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    Amministratore
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    ScotlandBritish50729030001
    HOLMSTROM, Jan Gustaf Lennart
    Strandstigen 3 Strandstigen 3
    SE18134 Se-18134 Lidingo
    Sweden
    Amministratore
    Strandstigen 3 Strandstigen 3
    SE18134 Se-18134 Lidingo
    Sweden
    SwedenSwedish152201540001
    HOPCROFT, Martin Peter
    1 The Pastures
    Edlesborough
    LU6 2HL Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    1 The Pastures
    Edlesborough
    LU6 2HL Dunstable
    Bedfordshire
    British40168200002
    KNIGHT, Patrick Stephen Provis
    Hafod Wen
    LL65 2NJ Rhoscolyn
    Anglesey Gwynedd
    Amministratore
    Hafod Wen
    LL65 2NJ Rhoscolyn
    Anglesey Gwynedd
    WalesBritish97288820001
    LANGTON, Paul
    Fieldside Lodge
    Waterside Winteringham
    DN17 9PG Scunthorpe
    S Humberside
    Amministratore
    Fieldside Lodge
    Waterside Winteringham
    DN17 9PG Scunthorpe
    S Humberside
    British19038720001
    MAHER, Michael
    Norwood
    Shortheath Road
    GU9 8SL Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Norwood
    Shortheath Road
    GU9 8SL Farnham
    Surrey
    EnglandBritish64239090001
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    Amministratore
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    United KingdomBritish35557050001
    PAPADOPOULOS, James
    Westhurst Drive
    BR7 6HS Chislehurst
    87
    Kent
    Amministratore
    Westhurst Drive
    BR7 6HS Chislehurst
    87
    Kent
    British139470540001
    QUEEN, Roger Charles
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomBritish78822570002
    SHORT, Philip Christopher
    Waterside Outgate
    Ealand
    DN17 4JE Scunthorpe
    Humberside
    Amministratore
    Waterside Outgate
    Ealand
    DN17 4JE Scunthorpe
    Humberside
    British19038710001
    SIMPSON, Christopher Michael
    4 Bellbutts View
    Scotter
    DN21 3UX Gainsborough
    Lincolnshire
    Amministratore
    4 Bellbutts View
    Scotter
    DN21 3UX Gainsborough
    Lincolnshire
    EnglandBritish52678440001

    01285055 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 07 mar 2007
    Consegnato il 27 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 32-35 hoylake road bottesford t/no HS175599 the rental sums the goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Venture Finance PLC
    Transazioni
    • 27 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 08 dic 2006
    Consegnato il 16 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plots 32-35 hoylake road, bottesford, scunthorpe, north lincolnshire t/no. HS175599.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 lug 1991
    Consegnato il 01 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part plot 5 sunningdale rd. Scunthorpe t/n-160513 & plots 5A-9A sunningdale road scunthorpe t/n-161066 & plots 32-35 hoylake rd scunthorpe t/n-HS175599. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 ago 1989
    Consegnato il 25 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plots 32-35 hoylake road, bottesford, humberside.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 ott 1988
    Consegnato il 05 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H part plot 5, sunningdale road, scunthorpe, south humberside.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ott 1988
    Consegnato il 05 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H plots 5A, 6, 7, 8, 9 and 9A sunningdale road, scunthorpe, south humberside.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1987
    Consegnato il 30 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Horizontal glass toughening plant including heating chamber, batch system and fully automatic conveyor on rollers type t-p-r-13 x 440V-50 hertz 2000 x 3600 (see 395 for full details relevant to this charge).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 mar 1987
    Consegnato il 10 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold-plot 5A sunningdale road, scunthorpe, south humberside.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental charge
    Creato il 27 feb 1987
    Consegnato il 12 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land situate on the north side of sunningdale road, scunthorpe humberside. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures and fixed plant and machinery from time to time thereon and therein.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 09 ott 1985
    Consegnato il 15 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold 6, 8A, 9 and 9A sunningdale road, scunthorpe, south humberside.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 19 giu 1985
    Consegnato il 21 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over l/hold plot of land at sunningdale road scunthorpe south humberside known as plot 9A sunningdale road. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 21 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    Chattel mortgage
    Creato il 19 giu 1985
    Consegnato il 21 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of assignment the following plant machinery chattels or other equipment of the company. Stillage storage and rackery equipment internal over head crane serial number dmh 4318. see document M24 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    Collateral debenture
    Creato il 25 set 1984
    Consegnato il 28 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the teakglade limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Together with stock-in trade work in progress, pre payments stocks exchange investments & cash.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 28 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 02 ago 1984
    Consegnato il 08 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge by way of legal mortgage over:- plot of land at sunningdale road south park industrial estate scunthorpe, south humberside known as plot 9 together with all buildings fixed plant machinery fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    Chattel mortgage
    Creato il 02 ago 1984
    Consegnato il 08 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge by way of assignment over:- pannkoke single head cutting fine (see doc M21 for details).
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental legal charge
    Creato il 25 ott 1983
    Consegnato il 27 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All book debts and other debts present & future.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 27 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    Chattel mortgage
    Creato il 28 gen 1983
    Consegnato il 02 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 horizontal glass toughenine plant including heating chamber batch system and fully automatic conveyor on rollers type t-p-r-13X440V-sohz-2000X3600 so catedat sunningdale road, scunthorpe, south humberside.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 02 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 28 gen 1983
    Consegnato il 02 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital, stock-in-trade, work-in-progress, pre-payments, stock exchange investments a cash will all buildings, trade & other fixtures, fixed pland & machinery. L/hold 6-8 sunningdale road & 31-32 northampton road, scunthorpe, south humberside.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 02 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 30 lug 1981
    Consegnato il 06 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts of the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 lug 1981
    Consegnato il 04 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold lands hereditaments & premises being:- 6, 7, & 8 sunningdale road, scunthorpe south humberside.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 22 mag 1981
    Consegnato il 29 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold, 7 and 8 sunningdale road, scunthorpe.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mag 1981Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 13 mag 1981
    Consegnato il 20 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on leashold land and buildings at sunningdale road scunthorpe. And all buildings, fixtures (inc. Tradefixtures) fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 20 mag 1981Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 04 set 1980
    Consegnato il 10 set 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 6, 7 & 8 sunningdale road, moorawell road industrial estate boltesford scunthorpe all fixtures present & future.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 12 mag 1980
    Consegnato il 16 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold, factory premises situate in northampton road, known as 31 & 32, scunthorpe together with all fixtures present and fixture. Title no. Hs 39163.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 26 set 1977
    Consegnato il 03 ott 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0