RUBY DCO SIXTEEN LIMITED

RUBY DCO SIXTEEN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRUBY DCO SIXTEEN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01286551
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Office 5, International House
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SUPERFIELD LIMITED24 gen 199724 gen 1997
    MARTIN MCCULLOCH LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    MINGDU LIMITED16 nov 197616 nov 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione di Admenta Holdings Limited come persona con controllo significativo il 31 ago 2023

    1 paginePSC07

    Notifica di Dunamis Mind Accelerator Limited come persona con controllo significativo il 31 ago 2023

    2 paginePSC02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company name be changed / sole director appointment 31/08/2023
    RES13

    Cessazione della carica di Graham Wiseman come amministratore in data 31 ago 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Thorsten Sprank come amministratore in data 31 ago 2023

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Sapphire Court Walsgrave Triangle Coventry CV2 2TX a Office 5, International House Cray Avenue Orpington BR5 3RS in data 04 set 2023

    1 pagineAD01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed superfield LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name04 set 2023

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 31 ago 2023

    RES15

    Stato del capitale al 16 ago 2023

    • Capitale: GBP 0.01
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 ago 2023 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    3 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    33 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Ratification 07/09/2022
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Wendy Margaret Hall come amministratore in data 09 set 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nichola Louise Legg come segretario in data 09 set 2022

    1 pagineTM02

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Nomina di Graham Wiseman come amministratore in data 07 set 2022

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Christian Keen come amministratore in data 18 mag 2022

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SPRANK, Thorsten
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Amministratore
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandGerman203900280002
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Segretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Segretario
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    LEGG, Nichola Louise
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    163214890001
    MCCULLOCH, Thomas Martin
    The Neuk Dippenhall Street
    Crondall
    GU10 5NX Farnham
    Surrey
    Segretario
    The Neuk Dippenhall Street
    Crondall
    GU10 5NX Farnham
    Surrey
    British12970580001
    MURPHY, Francis Joseph
    Home Farm
    North End Lane Fulbeck
    NG32 3JR Grantham
    Lincolnshire
    Segretario
    Home Farm
    North End Lane Fulbeck
    NG32 3JR Grantham
    Lincolnshire
    British32866430001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Segretario
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    STEWART, Brian
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    British980530001
    BEER, Thorsten
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman172030260001
    ENGLAND, Philip Nicholas
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    Amministratore
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    British43835770003
    HALL, Wendy Margaret
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish172979860001
    HILGER, Marcus
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    GermanyGerman238936580003
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Amministratore
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    KEEN, Christian
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish54544790004
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Amministratore
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    LIPP, Hanns Martin
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman220582440001
    MAJOR, Michael Evelyn
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    Amministratore
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    British31230890001
    MCCULLOCH, Jane
    The Neuk Dippenhall Street
    Crondall
    GU10 5NX Farnham
    Surrey
    Amministratore
    The Neuk Dippenhall Street
    Crondall
    GU10 5NX Farnham
    Surrey
    British12970590001
    MCCULLOCH, Thomas Martin
    The Neuk Dippenhall Street
    Crondall
    GU10 5NX Farnham
    Surrey
    Amministratore
    The Neuk Dippenhall Street
    Crondall
    GU10 5NX Farnham
    Surrey
    British12970580001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    SANDERS, Alan Christopher
    17 Hollytrees
    GU13 0NL Church Crookham
    Hampshire
    Amministratore
    17 Hollytrees
    GU13 0NL Church Crookham
    Hampshire
    British46616760001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    STEWART, Brian
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish980530001
    TROUGHTON, John Mervyn
    Frolic House Woodlands Court
    Watford Village
    NN6 7XW Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Frolic House Woodlands Court
    Watford Village
    NN6 7XW Northampton
    Northamptonshire
    British1192800003
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British122881190001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    WISEMAN, Graham
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Amministratore
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandBritish299860960001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dunamis Mind Accelerator Limited
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    31 ago 2023
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    06 apr 2016
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneGreat Britain
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione244282
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    RUBY DCO SIXTEEN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 15 ott 1983
    Consegnato il 05 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 31 wellington st aldershot hants and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 15 set 1983
    Consegnato il 21 set 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 31 wellington street aldershot hampshire and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1983Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 12 mar 1982
    Consegnato il 18 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's f/h & l/h properties including fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, goodwill and uncalled capital and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 27 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 21 ago 1978
    Consegnato il 29 ago 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property known as 103/105 farnborough road, heath end, farnham,surrey. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 29 ago 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 27 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0