RUBY DCO SIXTEEN LIMITED
Panoramica
| Nome della società | RUBY DCO SIXTEEN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01286551 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Office 5, International House Cray Avenue BR5 3RS Orpington England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SUPERFIELD LIMITED | 24 gen 1997 | 24 gen 1997 |
| MARTIN MCCULLOCH LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
| MINGDU LIMITED | 16 nov 1976 | 16 nov 1976 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Cessazione di Admenta Holdings Limited come persona con controllo significativo il 31 ago 2023 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Notifica di Dunamis Mind Accelerator Limited come persona con controllo significativo il 31 ago 2023 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Graham Wiseman come amministratore in data 31 ago 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Thorsten Sprank come amministratore in data 31 ago 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Sapphire Court Walsgrave Triangle Coventry CV2 2TX a Office 5, International House Cray Avenue Orpington BR5 3RS in data 04 set 2023 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed superfield LIMITED\certificate issued on 04/09/23 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale al 16 ago 2023
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 ago 2023 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 33 pagine | MA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Wendy Margaret Hall come amministratore in data 09 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Nichola Louise Legg come segretario in data 09 set 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Nomina di Graham Wiseman come amministratore in data 07 set 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2022 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Christian Keen come amministratore in data 18 mag 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRANK, Thorsten | Amministratore | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | England | German | 203900280002 | |||||
| BRIERLEY, Jennifer Anne | Segretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
| DAVIES, John Richard Bridge | Segretario | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
| HEATON, Janet Ruth | Segretario | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
| LEGG, Nichola Louise | Segretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | 163214890001 | |||||||
| MCCULLOCH, Thomas Martin | Segretario | The Neuk Dippenhall Street Crondall GU10 5NX Farnham Surrey | British | 12970580001 | ||||||
| MURPHY, Francis Joseph | Segretario | Home Farm North End Lane Fulbeck NG32 3JR Grantham Lincolnshire | British | 32866430001 | ||||||
| SMERDON, Peter | Segretario | 40 Stoneton Crescent Balsall Common CV7 7QG Coventry Warwickshire | British | 16898700002 | ||||||
| STEWART, Brian | Segretario | 12 Fulwell Park Avenue TW2 5HQ Twickenham Middlesex | British | 980530001 | ||||||
| BEER, Thorsten | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | 172030260001 | |||||
| ENGLAND, Philip Nicholas | Amministratore | 5 Park Avenue Peper Harrow Park GU8 6BA Godalming Surrey | British | 43835770003 | ||||||
| HALL, Wendy Margaret | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | 172979860001 | |||||
| HILGER, Marcus | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | Germany | German | 238936580003 | |||||
| HOOD, John | Amministratore | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | 39644740002 | ||||||
| KEEN, Christian | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | 54544790004 | |||||
| KERSHAW, Graham Anthony | Amministratore | Selsley House Westhorpe LE16 9UL Sibbertoft Leicestershire | United Kingdom | British | 8991780003 | |||||
| LIPP, Hanns Martin | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | 220582440001 | |||||
| MAJOR, Michael Evelyn | Amministratore | 1 Frobisher Gardens GU1 2NT Guildford Surrey | British | 31230890001 | ||||||
| MCCULLOCH, Jane | Amministratore | The Neuk Dippenhall Street Crondall GU10 5NX Farnham Surrey | British | 12970590001 | ||||||
| MCCULLOCH, Thomas Martin | Amministratore | The Neuk Dippenhall Street Crondall GU10 5NX Farnham Surrey | British | 12970580001 | ||||||
| MEISTER, Stefan Mario | Amministratore | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | 43550520003 | ||||||
| MISCHKE, Gerhard Viktor | Amministratore | Whitehill Farmhouse Alderminster CV37 8BW Stratford Upon Avon Warwickshire | Germany | 62107000001 | ||||||
| SANDERS, Alan Christopher | Amministratore | 17 Hollytrees GU13 0NL Church Crookham Hampshire | British | 46616760001 | ||||||
| SHEPHERD, William | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | 162873980001 | |||||
| SMERDON, Peter | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 16898700002 | |||||
| STEWART, Brian | Amministratore | 12 Fulwell Park Avenue TW2 5HQ Twickenham Middlesex | England | British | 980530001 | |||||
| TROUGHTON, John Mervyn | Amministratore | Frolic House Woodlands Court Watford Village NN6 7XW Northampton Northamptonshire | British | 1192800003 | ||||||
| VIZARD, Ronald Charles, Harold | Amministratore | Fieldfare Pigeon Green, Snitterfield CV37 OLP Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | 122881190001 | ||||||
| WILLETTS, Andrew John | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 120451550002 | |||||
| WISEMAN, Graham | Amministratore | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | England | British | 299860960001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di RUBY DCO SIXTEEN LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunamis Mind Accelerator Limited | 31 ago 2023 | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Admenta Holdings Limited | 06 apr 2016 | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
RUBY DCO SIXTEEN LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creato il 15 ott 1983 Consegnato il 05 nov 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H 31 wellington st aldershot hants and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 15 set 1983 Consegnato il 21 set 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H 31 wellington street aldershot hampshire and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 12 mar 1982 Consegnato il 18 mar 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over the company's f/h & l/h properties including fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, goodwill and uncalled capital and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 21 ago 1978 Consegnato il 29 ago 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Leasehold property known as 103/105 farnborough road, heath end, farnham,surrey. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0