HAMMOND LOGISTICS LIMITED

HAMMOND LOGISTICS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAMMOND LOGISTICS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01290841
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAMMOND LOGISTICS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HAMMOND LOGISTICS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HAMMOND LOGISTICS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RICKABY AND LEE TRANSPORT LIMITED29 mar 198529 mar 1985
    RICKABY & LEE TRANSPORT (PUDSEY) LIMITED15 dic 197615 dic 1976

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAMMOND LOGISTICS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per HAMMOND LOGISTICS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 set 2015

    12 pagine4.68

    Cessazione della carica di Paul Andrew Cullingford come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 105 Duke Street Liverpool Merseyside L1 5JQ a Pannell House 159 Charles Street Leicester LE1 1LD in data 07 ott 2014

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 set 2014

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mag 2014

    Stato del capitale al 27 mag 2014

    • Capitale: GBP 258,226
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 20 in pieno

    3 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    legacy

    8 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Iain Alexander Speak il 01 mag 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Andrew Cullingford il 01 gen 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di HAMMOND LOGISTICS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BIBBY BROS. & CO. (MANAGEMENT) LIMITED
    105 Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    105 Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    Merseyside
    153567030002
    SPEAK, Iain Alexander
    Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    105
    United Kingdom
    Amministratore
    Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    105
    United Kingdom
    United KingdomBritish54684840001
    LAW, Martin
    16 Bumblehole Meadows
    Wombourne
    WV5 8BG Wolverhampton
    Staffordshire
    Segretario
    16 Bumblehole Meadows
    Wombourne
    WV5 8BG Wolverhampton
    Staffordshire
    British73908170001
    PICKLES, Patricia
    44 Crag Hill Road
    Thackley
    BD10 0AH Bradford
    Yorkshire
    Segretario
    44 Crag Hill Road
    Thackley
    BD10 0AH Bradford
    Yorkshire
    British6318470001
    SMITH, Philip Michael Forster
    19 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    19 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    British35806430001
    ATTOCK, George William
    Hill Top
    Wilsden Road
    BD16 1BG Harden
    Bingley
    Amministratore
    Hill Top
    Wilsden Road
    BD16 1BG Harden
    Bingley
    British22169650001
    CULLINGFORD, Paul Andrew
    Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    105
    United Kingdom
    Amministratore
    Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    105
    United Kingdom
    WalesBritish53644130003
    CUTLER, John Edward
    The White House
    8 Moor Hall Drive Four Oaks
    B75 6LP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    The White House
    8 Moor Hall Drive Four Oaks
    B75 6LP Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish126241800001
    DE PENCIER, Theodore Henry John
    Aysgarth House 9 Moreton Avenue
    AL5 2EU Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Aysgarth House 9 Moreton Avenue
    AL5 2EU Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish45068720001
    LEE, Rodney
    36 Ganners Road
    Bramley
    LS13 2PB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    36 Ganners Road
    Bramley
    LS13 2PB Leeds
    West Yorkshire
    British15512450001
    POLLARD, Geoffrey
    10 Grasleigh Way
    Allerton
    BD15 9AN Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Grasleigh Way
    Allerton
    BD15 9AN Bradford
    West Yorkshire
    British76191570001
    RICKABY, Robert William
    18 Ash Dene Crescent
    LS28 8NS Pudsey
    West Yorkshire
    Amministratore
    18 Ash Dene Crescent
    LS28 8NS Pudsey
    West Yorkshire
    British49347490001
    SHARP, Garry Macdonald
    6 Pembroke Mews
    Morgan Street
    E3 5AW London
    Amministratore
    6 Pembroke Mews
    Morgan Street
    E3 5AW London
    British6245120001
    SHARP, Gary
    Clough Green Farm
    Cawthorne
    S75 4AB Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    Clough Green Farm
    Cawthorne
    S75 4AB Barnsley
    South Yorkshire
    British92322610001
    SHARP, Gary
    Clough Green Farm
    Cawthorne
    S75 4AB Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    Clough Green Farm
    Cawthorne
    S75 4AB Barnsley
    South Yorkshire
    British92322610001
    SIMONS, David Frank
    Grosvenor 32 Fletsand Road
    SK9 2AB Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Grosvenor 32 Fletsand Road
    SK9 2AB Wilmslow
    Cheshire
    British8608100001
    SMITH, Philip Michael Forster
    19 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    19 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish35806430001
    SWANNELL, Dennis Peter
    Kestrels
    Chapel Haddlesey
    YO8 8QQ Selby
    North Yorkshire
    Amministratore
    Kestrels
    Chapel Haddlesey
    YO8 8QQ Selby
    North Yorkshire
    British91114820001
    TUTTON, Ian Allen
    8 Sutton Drive
    Cullingworth
    BD13 5BQ Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Sutton Drive
    Cullingworth
    BD13 5BQ Bradford
    West Yorkshire
    British6318490001

    HAMMOND LOGISTICS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 01 ago 2011
    Consegnato il 13 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 set 2005
    Consegnato il 17 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 gen 2003
    Consegnato il 28 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 ago 1998
    Consegnato il 17 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 2 dealburn road woodroyd industrial estate bradford west yorkshire t/n WYK416541.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 ago 1998
    Consegnato il 17 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or hammond group holdings limited and/or hammond logistics group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 ago 1998
    Consegnato il 17 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1 dealburn road woodroyd industrial estate bradford west yorkshire t/n WYK389702.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on book debts and related rights
    Creato il 09 lug 1996
    Consegnato il 10 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 8TH july 1996 or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge over all factored debts the other debts an all related rights.
    Persone aventi diritto
    • Venture Factors PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £13670-93
    Brevi particolari
    All the rights title and interest of the company (please see doc 395 tc ref M99C for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 27 giu 1990
    Consegnato il 28 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Transazioni
    • 28 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 gen 1990
    Consegnato il 02 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal mortgage dated 27.5.87 and the charge
    Brevi particolari
    L/H land on the west side of dealburn road low moor bradford west yorkshire title no wyk 389702.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 02 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 26 lug 1988
    Consegnato il 01 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h land & buildings on south west of dealburn road low moor title no wyk 389702 f/h land approx 3.3 acres & buildings in dealburn road & low moor bradford and the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1988
    Consegnato il 25 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at dealburn road, low moor bradford, west yrokshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    First charge
    Creato il 16 mag 1988
    Consegnato il 26 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £800,000
    Brevi particolari
    Warehouse premises at dealburn road, woodroyd industrial estate, low moor, bradford, west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Sun Life Assurance Company
    Transazioni
    • 26 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 30 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 27 mag 1987
    Consegnato il 02 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H land at dealburn rd, low moor, bradford tog with buildings erected thereon.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 02 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 25 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 gen 1987
    Consegnato il 03 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Approx 6 acres of land on the south west side of dealburn road low moor bradford west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 giu 1983
    Consegnato il 13 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and bldgs at dealburn road, k/a woodroyd industrial estate new works rd., Low moor bradford west yorkshire as comprised in a lease dated 20.5.83.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 20 mag 1983
    Consegnato il 24 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £21,600
    Brevi particolari
    3.862 acres (approx) of land with buildings at woodroyd industrial estate new works road low moor bradford.
    Persone aventi diritto
    • City of Bradford Metropolitan Council
    Transazioni
    • 24 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 20 mag 1983
    Consegnato il 24 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75,000 due from the company to the chargee under the terms of the mortgage dated 12.11.82 or this charge
    Brevi particolari
    3.862 acres (approx) of land with buildings at woodroyd industrial estate new works road low moor bradford.
    Persone aventi diritto
    • City of Bradford Metropolitan Council
    Transazioni
    • 24 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 12 nov 1982
    Consegnato il 17 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Assigns all interest in the property referred to in clause 1 of the building agreement dated 12.11.82 and the full benefit of the agreement.
    Persone aventi diritto
    • City of Bradford Metropolitan Council
    Transazioni
    • 17 nov 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 29 apr 1982
    Consegnato il 07 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital and all fixtures plant & machinery (please see doc M28).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1982Registrazione di un'ipoteca

    HAMMOND LOGISTICS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 set 2014Inizio della liquidazione
    14 dic 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Terence Kerr
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Praticante
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    Praticante
    Bdo Llp Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0