COLIN BUCHANAN AND PARTNERS LIMITED

COLIN BUCHANAN AND PARTNERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOLIN BUCHANAN AND PARTNERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01292315
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COLIN BUCHANAN AND PARTNERS LIMITED?

    • Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova COLIN BUCHANAN AND PARTNERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Birchin Court, 20 Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COLIN BUCHANAN AND PARTNERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per COLIN BUCHANAN AND PARTNERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 set 2022

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 set 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 27 Great West Road Brentford TW8 9BW England a Birchin Court, 20 Birchin Lane London EC3V 9DU in data 21 set 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 set 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Ms Patricia Murray come amministratore in data 17 nov 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Bradley Garnet Andrews come amministratore in data 17 nov 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Brenda Connell come amministratore in data 17 nov 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020

    13 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 giu 2019

    19 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Sinclair Knight Merz (Europe) Limited come persona con controllo significativo il 14 giu 2019

    2 paginePSC05

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 set 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    17 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 set 2019 al 30 giu 2019

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Graeme Dodd 4th Floor Metro 33 Trafford Road Salford Quays Manchester M5 3NN a 27 Great West Road Brentford TW8 9BW in data 30 mag 2019

    1 pagineAD01

    Nomina di Victor Jibuike come segretario in data 24 mag 2019

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jonathan Ross Shattock come amministratore in data 26 apr 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Ellis come amministratore in data 26 apr 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di COLIN BUCHANAN AND PARTNERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JIBUIKE, Victor
    Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court, 20
    Segretario
    Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court, 20
    258974310001
    ANDREWS, Bradley Garnet
    Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court, 20
    Amministratore
    Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court, 20
    EnglandCanadianPresident276681340001
    MURRAY, Patricia
    Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court, 20
    Amministratore
    Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court, 20
    United KingdomBritishFinance Director276690010001
    BRADSHAW, Trevor John
    88 Manor Way
    HA4 8HL Ruislip
    Middlesex
    Segretario
    88 Manor Way
    HA4 8HL Ruislip
    Middlesex
    British76453150001
    BURSEY, Nicholas Charles
    2 Abbeville Road
    SW4 9NJ London
    Segretario
    2 Abbeville Road
    SW4 9NJ London
    British16439750001
    BURSEY, Nicholas Charles
    2 Abbeville Road
    SW4 9NJ London
    Segretario
    2 Abbeville Road
    SW4 9NJ London
    British16439750001
    CHAUDHARY, Tejender Singh
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    Segretario
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    246692570001
    DODD, Graeme Ronald
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    England
    Segretario
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    England
    146729050001
    DYKES, Graeme Alan
    6 Heighams
    CM19 5NU Harlow
    Essex
    Segretario
    6 Heighams
    CM19 5NU Harlow
    Essex
    British17683450002
    NORRIS, Michael Timothy
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    Segretario
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    199191210001
    SHERBURN, Michael Peter
    9 Walscombe Close
    TA14 6QJ Stoke Sub Hamdon
    Somerset
    Segretario
    9 Walscombe Close
    TA14 6QJ Stoke Sub Hamdon
    Somerset
    BritishAccountant61250920001
    BABES, Simon James
    Frances Road
    SL4 3AJ Windsor
    82
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Frances Road
    SL4 3AJ Windsor
    82
    Berkshire
    England
    EnglandBritishCompany Director151130820001
    BUCHANAN, Colin Paul
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    England
    Amministratore
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    England
    EnglandBritishTransport Economist79649180003
    BUCHANAN, Colin Malcolm
    2 Eaton Rise
    W5 2ER London
    Amministratore
    2 Eaton Rise
    W5 2ER London
    BritishCompany Director7630070001
    BURSEY, Nicholas Charles
    2 Abbeville Road
    SW4 9NJ London
    Amministratore
    2 Abbeville Road
    SW4 9NJ London
    BritishDirector16439750001
    CARR, Claire Patricia
    73 Comiston Drive
    EH10 5QT Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    73 Comiston Drive
    EH10 5QT Edinburgh
    Midlothian
    BritishCompany Director69321370001
    COLE, Adrian Keith
    Mexfield Road
    SW15 2RG London
    33
    Amministratore
    Mexfield Road
    SW15 2RG London
    33
    BritishCompany Director135600180001
    CONNELL, Brenda
    Great West Road
    TW8 9BW Brentford
    27
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Great West Road
    TW8 9BW Brentford
    27
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomIrishNone134154370002
    ELLIS, David
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    Amministratore
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    United KingdomBritishCompany Director206422550001
    HEMMATI, Shahram
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    England
    Amministratore
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    England
    United KingdomBritishConsulting Engineer90825140002
    MACKELLAR, Peter Robert
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    England
    Amministratore
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    England
    EnglandBritishChief Operating Officer146724610001
    MARKIDES, Andreas Christodoulou
    4 The Oaks
    RG26 4XX Tadley
    Hampshire
    Amministratore
    4 The Oaks
    RG26 4XX Tadley
    Hampshire
    EnglandBritishCivil Engineer56471840001
    MCGOVERN, Kevin James Peter Martin
    3 Chestnut Avenue
    KT19 0SY Ewell
    Surrey
    Amministratore
    3 Chestnut Avenue
    KT19 0SY Ewell
    Surrey
    BritishTown Planner79649150002
    MCTERNAN, Dominic Paul
    80 Knock Eden Park
    Rosetta
    BT6 0JG Belfast
    County Antrim
    Amministratore
    80 Knock Eden Park
    Rosetta
    BT6 0JG Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandIrishCompany Director127274310001
    MOGRIDGE, Michael Charles
    Quince Cottage
    King's Road Bloxham
    OX15 4QE Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Quince Cottage
    King's Road Bloxham
    OX15 4QE Banbury
    Oxfordshire
    BritishCompany Director26581950005
    MORGAN, Simon Keith
    9 Green Lane
    HA6 2UX Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    9 Green Lane
    HA6 2UX Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director50046770001
    NIBLETT, Geoffrey Roland
    16 Madeira Park
    TN2 5SX Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    16 Madeira Park
    TN2 5SX Tunbridge Wells
    Kent
    BritishTransport Planner62184570001
    NOON, Atholl Wellesley
    109 Kings Road
    KT2 5JB Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    109 Kings Road
    KT2 5JB Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishConsultant78031750003
    PARKYN, Neil Keith
    50 Huntingdon Road
    N2 9DU London
    Amministratore
    50 Huntingdon Road
    N2 9DU London
    BritishArchitect & Town Planner8948770001
    PIKE, Jonathan Richard
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    England
    Amministratore
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    England
    United KingdomBritishArea Manager Emea128485820001
    POWER, Alan
    9 Redwood Grove
    Ealing
    W5 4SZ London
    Amministratore
    9 Redwood Grove
    Ealing
    W5 4SZ London
    United KingdomBritishCompany Director101717150002
    POWER, Leon Anthony
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    Amministratore
    c/o Graeme Dodd
    33 Trafford Road
    Salford Quays
    M5 3NN Manchester
    4th Floor Metro
    IrelandIrishFinancial Director126002790001
    PYATT, Christopher Charles John
    18 St. Andrews Road
    RG9 1JB Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    18 St. Andrews Road
    RG9 1JB Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director50046780003
    QUARMBY, David Anthony, Dr
    13 Shooters Hill Road
    SE3 7AR London
    Amministratore
    13 Shooters Hill Road
    SE3 7AR London
    UkBritishCompany Director51753000001
    ROBERTS, Malcolm Thomas
    The Cottage
    Comptons Alley
    GL20 5QE Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Cottage
    Comptons Alley
    GL20 5QE Tewkesbury
    Gloucestershire
    BritishEngineer41656990002

    Chi sono le persone con controllo significativo di COLIN BUCHANAN AND PARTNERS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Worley Europe Services Ltd
    Great West Road
    TW8 9BW Brentford
    27
    England
    06 apr 2016
    Great West Road
    TW8 9BW Brentford
    27
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland Companies Registry
    Numero di registrazione3371550
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    COLIN BUCHANAN AND PARTNERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 05 ago 2008
    Consegnato il 08 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £167,797.05 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ls Onc Holdings Limited
    Transazioni
    • 08 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 05 ago 2008
    Consegnato il 08 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £167,966.25 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ls Onc Holdings Limited
    Transazioni
    • 08 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 26 nov 2007
    Consegnato il 28 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 550/01/67647081 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 ago 2006
    Consegnato il 22 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 22 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 11 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 09482520 and 06450308 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 nov 2003
    Consegnato il 06 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 06 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of deposit account moneys
    Creato il 09 giu 1998
    Consegnato il 13 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that principal sum of £274,307.12 or such sum or such part thereof as is for the time being standing to the credit of account number 20013909 in the name of 3I group PLC at the royal bank of scotland PLC,corporate banking office,5-10 great tower street,london EC3P 3HX with all interest credited thereto and all the right title and interest of the company whatsoever therein both present and future.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 ago 1990
    Consegnato il 29 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 06 ago 1990
    Consegnato il 06 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £45,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    59 queens gardens paddington london.
    Persone aventi diritto
    • Target Life Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 06 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 01 ago 1988
    Consegnato il 02 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 02 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 01 ago 1988
    Consegnato il 02 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 59 queens gardens london W2 3AF & all buildings & fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 02 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 ago 1985
    Consegnato il 30 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    59 queens gardens london W2 title no.- Ln 92846 and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 ott 1983
    Consegnato il 12 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge by way of a legal mortgage over the property. F/h 59 queens gardens paddington, london W2 title no. Ln 92846 with title absolute with all buildings and fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 mag 1979
    Consegnato il 10 mag 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 47 princes gate london SW7. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    COLIN BUCHANAN AND PARTNERS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 ott 2023Data prevista di scioglimento
    09 set 2021Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Gordon Bathgate
    Bishops Court, 29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Praticante
    Bishops Court, 29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0