SSL RETAIL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSSL RETAIL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01296016
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SSL RETAIL LIMITED?

    • Altra vendita al dettaglio non in negozi, bancarelle o mercati (47990) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova SSL RETAIL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp
    1 St Peter'S Square
    M2 3AE Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SSL RETAIL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OLYMPUS SPORT INTERNATIONAL LIMITED30 giu 198530 giu 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di SSL RETAIL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 gen 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SSL RETAIL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SSL RETAIL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 set 2015

    23 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 25 set 2015

    23 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 lug 2015

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 gen 2015

    22 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE a Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE in data 28 gen 2015

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp St. James's Square Manchester Lancashire M2 6DS a Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE in data 28 gen 2015

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 lug 2014

    23 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 gen 2014

    24 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 lug 2013

    24 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 mar 2013

    24 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da * J J B Sports Plc Martland Park Challenge Way Wigan Lancashire WN5 0LD* in data 20 dic 2012

    2 pagineAD01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    35 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Keith Jones come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 gen 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 giu 2012

    Stato del capitale al 08 giu 2012

    • Capitale: GBP 40,135,000
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 26/04/2012
    RES13

    legacy

    15 pagineMG01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 gen 2011

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Keith John Jones come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SSL RETAIL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Segretario
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    161511810001
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Amministratore
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish157062220001
    ASHBY, Jonathan
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    Segretario
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    British134682180001
    FOOT, Peter John Lewis
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    Segretario
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    British51176110002
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Segretario
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    British4527320003
    HEATHER, John Langdale
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    British33307810001
    KAYE, David Stanley
    56 Castleton Drive
    Newton Mearns
    G77 5LE Glasgow
    Segretario
    56 Castleton Drive
    Newton Mearns
    G77 5LE Glasgow
    British78278710002
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Segretario
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    British128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Segretario
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    152719260001
    SIMKINS, Paul Charles
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    Segretario
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    British37115350001
    CLAIRMONTS SOLICITORS
    9 Clairmont Gardens
    G3 7LW Glasgow
    Segretario
    9 Clairmont Gardens
    G3 7LW Glasgow
    44581680001
    SEARS SPORTS AND LEISUREWEAR PLC
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    Segretario
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    16600870001
    CHAMBERLAIN, Adrian
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    British117106730001
    CLIFFORD, Timothy David Ordish
    Flint House
    Hatherden
    SP11 0HP Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Flint House
    Hatherden
    SP11 0HP Andover
    Hampshire
    British44473790001
    COPPOCK, Lawrence Patrick
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    EnglandUnited Kingdom152718990001
    DAVIES, Philip Norman
    62 Cunningham Drive
    LE17 4YR Lutterworth
    Leicestershire
    Amministratore
    62 Cunningham Drive
    LE17 4YR Lutterworth
    Leicestershire
    British30542390001
    DUNN, Barry John Keith
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    Amministratore
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    United KingdomBritish60493690005
    FALLON, John Edward
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    Amministratore
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    British52124910001
    GLANVILLE, Richard
    Crooked Willows
    Wash Road
    SS15 4BP Basildon
    Essex
    Amministratore
    Crooked Willows
    Wash Road
    SS15 4BP Basildon
    Essex
    British69669910004
    GRABINER, Ian Michael
    Daylesford
    5 Methven Road
    G46 6TG Glasgow
    Amministratore
    Daylesford
    5 Methven Road
    G46 6TG Glasgow
    ScotlandBritish63235540002
    GREEN, Philip Nigel Ross, Sir
    129 Marylebone Road
    London
    Nw1 5qd
    Amministratore
    129 Marylebone Road
    London
    Nw1 5qd
    United KingdomBritish103945640001
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish4527320003
    GUNTER, Kevin
    9 Hawthorn Drive
    Uppingham
    LE15 9TA Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    9 Hawthorn Drive
    Uppingham
    LE15 9TA Oakham
    Leicestershire
    British55255580001
    HELME, John Frederick
    23 Peacock Place
    NN1 2DP Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    23 Peacock Place
    NN1 2DP Northampton
    Northamptonshire
    British34463520002
    HUNTER, Thomas Blane, Sir
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    Amministratore
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    United KingdomBritish97904280003
    JONES, Andrew Gethin
    Orchard Bank Button Bridge Lane
    DY12 3DN Bewdley
    Worcestershire
    Amministratore
    Orchard Bank Button Bridge Lane
    DY12 3DN Bewdley
    Worcestershire
    British57400720001
    JONES, Anthony David
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    Amministratore
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    British41640680002
    JONES, Keith John
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish149574500001
    KINNAIRD, John
    1 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    1 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    British70691510002
    KNIGHT, Thomas William
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    Amministratore
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    British11423040008
    LOVELOCK, Derek John
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116560620001
    LUSTMAN, Margaret Eve
    25 Sherriff Road
    NW6 2AS London
    Amministratore
    25 Sherriff Road
    NW6 2AS London
    British40930620001
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Amministratore
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    EnglandBritish128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    EnglandBritish77961690002
    MCCLUSKEY, Brian
    5b Longbank Road
    Alloway
    KA7 4SA Ayr
    Ayrshire
    Uk
    Amministratore
    5b Longbank Road
    Alloway
    KA7 4SA Ayr
    Ayrshire
    Uk
    British68223140002

    SSL RETAIL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 apr 2012
    Consegnato il 04 mag 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and from each other chargor (except as guarantor for the company) to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 04 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 giu 2009
    Consegnato il 17 giu 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Account charge
    Creato il 17 dic 2008
    Consegnato il 24 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All of the chargor's rights,title and interest from time to time in and to each charged asset see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Bank of Scotland PLC and Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 24 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 ott 2008
    Consegnato il 11 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 11 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 set 2008
    Consegnato il 02 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 set 2008
    Consegnato il 29 set 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 03 apr 1996
    Consegnato il 17 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 nov 1995
    Consegnato il 30 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SSL RETAIL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 ott 2012Inizio dell'amministrazione
    25 set 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0