ZYTEK MOTORSPORT LIMITED

ZYTEK MOTORSPORT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàZYTEK MOTORSPORT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01297589
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ZYTEK MOTORSPORT LIMITED?

    • (5020) /
    • (5030) /

    Dove si trova ZYTEK MOTORSPORT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Zytek House Lancaster Road
    Fradley Park
    WS13 8RY Lichfield
    Staffordshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ZYTEK MOTORSPORT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ZYTEK ENGINEERING LIMITED07 nov 199007 nov 1990
    ALAN SMITH RACING LIMITED04 dic 198704 dic 1987
    ALAN W. SMITH RACING (1977) LIMITED08 feb 197708 feb 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di ZYTEK MOTORSPORT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per ZYTEK MOTORSPORT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Richard Ian Smith come amministratore in data 08 dic 2011

    2 pagineTM01

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 03 ott 2011

    13 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 apr 2011

    17 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    29 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di John Manchester come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Trevor Foster come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen William Wallis come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Karen Ellen Brittan come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Simon Finnis come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 30 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 lug 2010

    Stato del capitale al 19 lug 2010

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Trevor Foster il 30 mag 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per John Leslie Manchester il 30 mag 2010

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Lancaster Road Fradley Lichfield Staffordshire WS13 8NE in data 17 lug 2010

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Richard Dean come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Richard Davies come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    20 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed zytek engineering LIMITED\certificate issued on 12/12/09
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name12 dic 2009

    Avviso di cambio di nome"

    CONNOT

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 04 nov 2009

    RES15

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    17 pagineAA

    legacy

    9 pagine395

    Chi sono gli amministratori di ZYTEK MOTORSPORT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GIBSON, Helen Claire
    6 St Martins Road
    B75 7QL Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    6 St Martins Road
    B75 7QL Sutton Coldfield
    West Midlands
    British106715960001
    BRITTAN, Karen Ellen
    Lancaster Road
    Fradley Park
    WS13 8RY Lichfield
    Zytek House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Road
    Fradley Park
    WS13 8RY Lichfield
    Zytek House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154709230001
    DAVIES, Richard James
    Isabella Road
    Garforth
    LS25 2DY Leeds
    Unit 2 Helios 47
    West Yorkshire
    Amministratore
    Isabella Road
    Garforth
    LS25 2DY Leeds
    Unit 2 Helios 47
    West Yorkshire
    United KingdomBritish73787010003
    FINNIS, Simon
    Isabella Road
    Garforth
    LS25 2DY Leeds
    Helios 47
    West Yorkshire
    Amministratore
    Isabella Road
    Garforth
    LS25 2DY Leeds
    Helios 47
    West Yorkshire
    United KingdomBritish153324310001
    GIBSON, William Harley, Dr
    4 Selwyn Walk
    Little Aston Park
    B74 3FG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    4 Selwyn Walk
    Little Aston Park
    B74 3FG Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish11308900002
    WALLIS, Stephen William
    Lancaster Road
    Fradley Park
    WS13 8RY Lichfield
    Zytek House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Road
    Fradley Park
    WS13 8RY Lichfield
    Zytek House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish48233290001
    GIBSON, William Harley
    18 Ashdene Close
    B73 6HL Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    18 Ashdene Close
    B73 6HL Sutton Coldfield
    West Midlands
    British11308900001
    WALLIS, Stephen William
    40 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    Segretario
    40 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    British48233290001
    DEAN, Richard Antony
    23 West Park Street
    WF13 4LE Dewsbury
    West Yorkshire
    Amministratore
    23 West Park Street
    WF13 4LE Dewsbury
    West Yorkshire
    United KingdomBritish77920040004
    FOSTER, Trevor Anthony
    Sandalwood Road
    LE11 3PR Loughborough
    11
    Leicester
    Amministratore
    Sandalwood Road
    LE11 3PR Loughborough
    11
    Leicester
    EnglandBritish131844630001
    GIBSON, William Harley, Dr
    4 Selwyn Walk
    Little Aston Park
    B74 3FG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    4 Selwyn Walk
    Little Aston Park
    B74 3FG Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish11308900002
    MANCHESTER, John Leslie
    Cruck Barn
    Ashbourne Road Church Broughton
    DE65 5AT Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Cruck Barn
    Ashbourne Road Church Broughton
    DE65 5AT Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish114293680001
    MANCHESTER, John Leslie
    Cruck Barn
    Ashbourne Road Church Broughton
    DE65 5AT Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Cruck Barn
    Ashbourne Road Church Broughton
    DE65 5AT Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish114293680001
    MASON, Brian William
    18 Foldyard Close
    B76 1QZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    18 Foldyard Close
    B76 1QZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British11308920001
    SMITH, Richard Ian
    9 Lancet Rise
    Robin Hood
    WF3 3UE Wakefield
    Amministratore
    9 Lancet Rise
    Robin Hood
    WF3 3UE Wakefield
    EnglandBritish109282890001
    TOMLINSON, Lawrence Neil
    Bilberry Farm
    Norwood
    LS21 2QU Otley
    North Yorkshire
    Amministratore
    Bilberry Farm
    Norwood
    LS21 2QU Otley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish55593060001
    WALLIS, Stephen William
    40 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    40 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish48233290001

    ZYTEK MOTORSPORT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 ago 2008
    Consegnato il 16 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 05 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the item or items being A1 engine-ZA01348, ZA01, s/no 01; A1 engine-ZA01 348, ZA01 s/no 02 and A1 engine-ZA01 348, ZA01, s/no 03 (for details of further property charged please refer to from 395).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 09 dic 2005
    Consegnato il 20 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    £800,000 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    The goods being mori seiki model mh 633 machining centre, serial number: 986, yom 2001; mori seiki model SL2500Y/650 C CNC lathe, s/no:10, yom 2001; mori seiki model MT2000S/1000 multi axis turning centre, s/no: 12, yom 2002, for details of further goods charged please refer to form 395, together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 dic 2005
    Consegnato il 21 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage supplemental to a mortgage debenture dated 20 april 1988
    Creato il 22 gen 1998
    Consegnato il 11 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assignment of judd zytek formula 3000 racing engines serial numbers KV002-KV004 KV008-KV012 KV014-KV022 KV024-KV066 (the equipment) including any part or parts thereto and all additions alterations and accessories.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 giu 1996
    Consegnato il 03 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Engine Developments Limited
    Transazioni
    • 03 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 apr 1988
    Consegnato il 26 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 07 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ZYTEK MOTORSPORT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 ott 2011Fine dell'amministrazione
    13 ott 2010Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Michael Pankhurst
    4 Jury Street
    CV34 4EW Warwick
    Praticante
    4 Jury Street
    CV34 4EW Warwick
    Jeremy Bowden
    4 Jury Street
    CV34 4EW Warwick
    Praticante
    4 Jury Street
    CV34 4EW Warwick

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0