SHERIFF PLANT HIRE LIMITED

SHERIFF PLANT HIRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHERIFF PLANT HIRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01297611
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHERIFF PLANT HIRE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SHERIFF PLANT HIRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    100 Cheapside
    EC2V 6DT London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHERIFF PLANT HIRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SHERIFF PLANT HIRE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SHERIFF PLANT HIRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 feb 2016

    Stato del capitale al 15 feb 2016

    • Capitale: GBP 4,000,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Ashtead Group Plc Kings House 36-37 King Street London EC2V 8BB a 100 Cheapside London EC2V 6DT in data 23 set 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2015

    Stato del capitale al 04 feb 2015

    • Capitale: GBP 4,000,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 feb 2014

    Stato del capitale al 14 feb 2014

    • Capitale: GBP 4,000,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Michael Richard Pratt come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stuart Robson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Eric Watkins il 14 feb 2012

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Ian Robson il 14 feb 2012

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Eric Watkins il 28 ago 2009

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2009

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    Chi sono gli amministratori di SHERIFF PLANT HIRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WATKINS, Eric
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    Segretario
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    British100734790001
    PRATT, Michael Richard
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    EnglandBritish37254010002
    CLARK, Robert Edmund
    50 Motspur Park
    KT3 6PL New Malden
    Surrey
    Segretario
    50 Motspur Park
    KT3 6PL New Malden
    Surrey
    British71028550001
    EVANS, Malcolm John
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    Segretario
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    British60525740001
    MAIR, James Stewart
    13 Jackson Close
    Oadby
    LE2 4US Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    13 Jackson Close
    Oadby
    LE2 4US Leicester
    Leicestershire
    British8864270002
    REED, Neil
    16a Church Lane
    Cossall
    NG16 2RW Nottingham
    East Midlands
    Segretario
    16a Church Lane
    Cossall
    NG16 2RW Nottingham
    East Midlands
    British85948070001
    ROBSON, Stuart Ian
    8 Belvedere Court Paulin Drive
    Winchmore Hill
    N21 1AZ London
    Segretario
    8 Belvedere Court Paulin Drive
    Winchmore Hill
    N21 1AZ London
    British71308340006
    ANDERSON, Alan
    78 Pennington Road
    Southborough
    TN4 0AF Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    78 Pennington Road
    Southborough
    TN4 0AF Tunbridge Wells
    Kent
    British3103840007
    BURNETT, George Barnett
    Kings Court
    41-51 Kingston Road
    KT22 7AP Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Kings Court
    41-51 Kingston Road
    KT22 7AP Leatherhead
    Surrey
    British55096390004
    CLARK, Robert Edmund
    50 Motspur Park
    KT3 6PL New Malden
    Surrey
    Amministratore
    50 Motspur Park
    KT3 6PL New Malden
    Surrey
    United KingdomBritish71028550001
    CLEMENTS, Colin Richard
    47 Water Lane
    Wootton
    NN4 6HA Northampton
    Amministratore
    47 Water Lane
    Wootton
    NN4 6HA Northampton
    British11419180002
    DUNN, Richard Martin
    84 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    84 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish5376410001
    EVANS, Malcolm John
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    Amministratore
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    British60525740001
    FOX, Derick Henry
    Renard Main Street
    Foston
    NG32 2JU Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    Renard Main Street
    Foston
    NG32 2JU Grantham
    Lincolnshire
    British5541820001
    LEWIS, Peter Donald
    Ashtead House Business Park 8
    Barnett Wood Lane
    KT22 7DG Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Ashtead House Business Park 8
    Barnett Wood Lane
    KT22 7DG Leatherhead
    Surrey
    British55096310003
    MACKAY, Gordon Angus
    39 High Meadow
    Tollerton
    NG12 4DZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    39 High Meadow
    Tollerton
    NG12 4DZ Nottingham
    Nottinghamshire
    British5541810003
    PETCH, Jonathan Leslie
    53 Solway Road
    WF17 6HJ Batley
    West Yorkshire
    Amministratore
    53 Solway Road
    WF17 6HJ Batley
    West Yorkshire
    British55719870001
    POWELL, John Michael
    Rosemaund Cottage
    Westonbirt
    GL8 8QT Tetbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Rosemaund Cottage
    Westonbirt
    GL8 8QT Tetbury
    Gloucestershire
    British65916250002
    ROBSON, Stuart Ian
    Kings House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    C/O Ashtead Group Plc
    Uk
    Amministratore
    Kings House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    C/O Ashtead Group Plc
    Uk
    United KingdomBritish71308340006
    SHEARSTONE, Michael Terence
    The Beeches
    Holme Pierrepont
    NG12 2LD Nottingham
    Amministratore
    The Beeches
    Holme Pierrepont
    NG12 2LD Nottingham
    British5485470001

    SHERIFF PLANT HIRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 01 apr 1995
    In corso
    Importo garantito
    £1,500,000 due from the compant to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Various items of property which include: 3 x ford transit 120 vans, 1 x daihatsu fourtrack fieldman commercial jeep, 1 x atlas 1304M wheeled hydraulic excavator.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 01 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 giu 1994
    Consegnato il 28 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 22 mar 1993
    Consegnato il 22 mar 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One volvo dump truck a 25 chassis no. 4452 (see schedule attached to form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 19 mar 1993
    Consegnato il 19 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached to the form 395.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 19 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 27 feb 1992
    Consegnato il 29 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000
    Brevi particolari
    First fixed charge over items as listed on the schedule to the form 395.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 29 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 25 feb 1992
    Consegnato il 25 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 25 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 lug 1991
    Consegnato il 06 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the south and west side of george street, lincoln.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 lug 1991
    Consegnato il 06 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the east side of dixon way, lincoln.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 ott 1988
    Consegnato il 03 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0