ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01299174 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
- Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MIDLAND MONTAGU LEASING (UK) LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
| MIDLAND BANK LEASING LIMITED | 18 feb 1977 | 18 feb 1977 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Seconda presentazione per la cessazione di Robin Louis Henning Bencard come amministratore | 5 pagine | RP04TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Robin Louis Henning Bencard come amministratore in data 08 ago 2016 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Simon Einar Long come amministratore in data 15 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John Cavanna come amministratore in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Connelly Anderson come amministratore in data 16 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Nomina di Ms Romana Lewis come segretario in data 28 mag 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 28 mag 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 05 gen 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tony Bhambhra come segretario in data 05 gen 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Katherine Dean come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Tony Bhambhra come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 52 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Romana | Segretario | Canada Square 14th Floor Canary Wharf E145HQ London, Greater London 8 England England | 198057330001 | |||||||
| ANDERSON, Michael Connelly | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 269666390001 | |||||
| KENT, John Richard | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 174308200001 | |||||
| LONG, Simon Einar | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 206202590001 | |||||
| OWEN CONWAY, Gareth | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 82999960002 | |||||
| SUBRAMANIYAN, Jaya | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Malaysian | 136924480002 | |||||
| BAYER, George William | Segretario | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
| BHAMBHRA, Tony | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 187824090001 | |||||||
| DEAN, Katherine | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180092630001 | |||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Segretario | Whitworth Street SE10 9EN London 13 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
| MCKENZIE, John Hume | Segretario | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Segretario | 1 Bolney Court Portsmouth Road KT6 4HX Surbiton Surrey | British | 109247130001 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Segretario | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Segretario | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| PEARCE, Mark Vivian | Segretario | 55 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | 26776940002 | ||||||
| READ, Alice | Segretario | 188 Berglen Court 7 Branch Road E14 7JZ London | British | 106168980003 | ||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 194209390001 | |||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 154911840001 | |||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 166967400001 | |||||||
| ALDRIDGE, Peter Colin | Amministratore | The Barn,Stoneleigh Quarry Farm Quarry Lane CV9 2RD Macetter Warwickshire | British | 145932800001 | ||||||
| BARKER, Fiona Ann | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 151858510001 | |||||
| BENCARD, Robin Louis Henning | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 46782110002 | |||||
| BROOKES, Malcolm James | Amministratore | 3 School Close Pinvin WR10 2TZ Pershore Worcestershire | British | 61727900003 | ||||||
| BROWNE, Ian James | Amministratore | 4 Hawkshill Drive Box Lane HP3 0BS Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 143599030001 | ||||||
| CARNEY, Brian | Amministratore | Springwood Lodge Owler Park Road LS29 0BG Ilkley West Yorkshire | British | 100001170001 | ||||||
| CAVANNA, David John | Amministratore | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 180384720001 | |||||
| DEVENISH, William Frederick | Amministratore | 12 Hyde Place OX2 7JB Oxford | British | 52830160002 | ||||||
| EVANS, Geoffrey William | Amministratore | The Trumpet House Kington Lane Claverdon CV35 8PP Warwick | British | 42712190001 | ||||||
| GILMAN, David William | Amministratore | 32 Riverside Drive Selly Oak B29 7ES Birmingham | British | 5681410002 | ||||||
| HOLMES, Timothy Victor | Amministratore | 18 The Badgers Mearse Lane Barnt Green B45 8QR Birmingham | British | 28497420002 | ||||||
| KELL, Christopher Raymond | Amministratore | 6 Gorse Close WR9 7SG Droitwich Worcestershire | British | 87307470001 | ||||||
| KENNY, Mary Bridget | Amministratore | 178 Empire Square West Long Lane SE1 4NL London | United Kingdom | British | 118995490002 | |||||
| LANE, Robert David | Amministratore | 42 Bridgnorth Road WV5 0AA Wombourne Staffordshire | England | British | 150099050001 | |||||
| LEECH, Ian Robert | Amministratore | 139 Lordswood Road Harborne B17 9BL Birmingham | British | 52909330001 | ||||||
| LESTER, Edward Paul | Amministratore | 26 St Barnabas Road CB1 2BY Cambridge Cambridgeshire | British | 4300370001 |
ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Lessor's security assignment | Creato il 19 dic 1996 Consegnato il 27 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage | |
Brevi particolari All rights,title and interest in respect of clause 5.1 of the conditional sale agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 10 dic 1996 Consegnato il 20 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage | |
Brevi particolari All rights,title,interest,insurances and proceeds of sale in the vessel "hull 1234". see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of covenant | Creato il 04 giu 1981 Consegnato il 22 giu 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £3404294 & all monies which may from time to time be or become due to the bank under the security documents & secured by a mortgage dated 4-6-81 | |
Brevi particolari The mortgaged premises being the ship (see doc M23). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 04 giu 1981 Consegnato il 22 giu 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on account current under the terms of a financial agreement dated 24-11-80 and a deed of covenant dated 4-6-81 | |
Brevi particolari 4/64TH shares in m v mensey marines registered in liverpool under official nunber 389177. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Delivery order | Creato il 24 nov 1980 Consegnato il 04 dic 1980 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and midland montague leasing limited pursuant to a financial agreement dated 24-11-80 & deeds supplemental thereto to the chargee | |
Brevi particolari All the owners rights interest & benefits under a building contract dated 24-11-80 all moneys payable to the owners in respect of insurances the vessel as she is constructed and all materials, machinery (further details see doc M29). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & assignment | Creato il 24 nov 1980 Consegnato il 04 dic 1980 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and midland montague leasing limited pursuant to a financial agreement dated 24.11.80 to the chargee | |
Brevi particolari All the owners rights interest & benefits under a building contract dated 24.11.80 all moneys payable to the owners in respect of insurances the vessel as she is constructed and all materials, machinery (further details see doc M29). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Financial agreement | Creato il 24 nov 1980 Consegnato il 04 dic 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £3494528 all monies due or to become due from the company and midland montague leasing limited under the terms of a financial agreement dated 24/11/1980 to the chargee | |
Brevi particolari All the owners right interest & benefits under a building contract dated 24 11 80 all moneys payable to the owners in respect of insurance the vessel in respect of insurance the vessel as she is constructed & all materials, machinery (further details see doc M29). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0