CMS BUILDING SERVICES LIMITED

CMS BUILDING SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCMS BUILDING SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01299640
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    • Installazione elettrica (43210) / Costruzioni

    Dove si trova CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor 40 Queen Square
    BS1 4QP Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COMBINED MECHANICAL SERVICES (ELECTRICAL) LIMITED22 feb 197722 feb 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2012
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2013
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine4.72

    Indirizzo della sede legale modificato da , 122 Widney Road, Bentley Heath, Solihull, B93 3BL a 2nd Floor 40 Queen Square Bristol BS1 4QP in data 03 nov 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 feb 2016

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 feb 2015

    12 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da , the Grange 26 Market Square, Westerham, Kent, TN16 1HB, United Kingdom in data 04 mar 2014

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    14 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Cessazione della carica di Avtar Sandhu come amministratore

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 012996400008

    21 pagineMR01

    Indirizzo della sede legale modificato da , 30 st. Dunstans Hill, Sutton, Surrey, SM1 2UD, United Kingdom in data 19 mar 2013

    1 pagineAD01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    6 pagine1.1

    Bilancio annuale redatto al 08 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 gen 2013

    Stato del capitale al 23 gen 2013

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da , Unit 8 Long Acre Trading Estate, Long Acre Aston, Birmingham, West Midlands, B7 5JD, United Kingdom in data 23 gen 2013

    1 pagineAD01

    legacy

    5 pagineMG01

    Cessazione della carica di Sean O'neill come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Avtar Singh Sandhu come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Sean Patrick O'neill come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da , 591 London Road, North Cheam, Surrey, SM3 9AG, England in data 26 giu 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 08 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio modificato redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAAMD

    Indirizzo della sede legale modificato da , 7 - 9, the Avenue, Eastbourne, East Sussex, BN21 3YA, United Kingdom in data 06 mag 2011

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di CMS BUILDING SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OSBORNE, Raymond Thomas
    - 9
    The Avenue
    BN21 3YA Eastbourne
    7
    East Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    - 9
    The Avenue
    BN21 3YA Eastbourne
    7
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector81964490002
    CHARLTON, Christopher Robert
    1 Woodland Drive
    Barnt Green
    B45 8FX Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    1 Woodland Drive
    Barnt Green
    B45 8FX Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector55853000005
    DOPSON, Barry
    White Gates
    Faircox Lane
    BN5 9PD Henfield
    West Sussex
    Segretario
    White Gates
    Faircox Lane
    BN5 9PD Henfield
    West Sussex
    British23336930004
    MACKENZIE, Jeremy
    14 Northend
    Batheaston
    BA1 7EN Bath
    Avon
    Segretario
    14 Northend
    Batheaston
    BA1 7EN Bath
    Avon
    British100984090001
    MASLIN, Roland Stephen
    Grek House 14 Primley Park Road
    LS17 7HS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Grek House 14 Primley Park Road
    LS17 7HS Leeds
    West Yorkshire
    New ZealandAccountant11901760001
    PANNELL, Keith James
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    Segretario
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    British100942650001
    CHARLTON, Benjamin James Robert
    Flat 11 18 Egerton Gardens
    SW3 2DG London
    Amministratore
    Flat 11 18 Egerton Gardens
    SW3 2DG London
    EnglandBritishCorporate Director103208830001
    CHARLTON, Christopher Robert
    1 Woodland Drive
    Barnt Green
    B45 8FX Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    1 Woodland Drive
    Barnt Green
    B45 8FX Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishDirector55853000005
    DALTON, John Charles
    Vale House Chess Hill
    Loudwater
    WD3 4HU Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Vale House Chess Hill
    Loudwater
    WD3 4HU Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant7382690001
    DEXTER, Lee
    Morgan Ryse
    Oldbury Wells
    WV16 5JE Bridgnorth
    Shropshire
    Amministratore
    Morgan Ryse
    Oldbury Wells
    WV16 5JE Bridgnorth
    Shropshire
    United KingdomBritishCompany Director94290580001
    DOPSON, Barry
    White Gates
    Faircox Lane
    BN5 9PD Henfield
    West Sussex
    Amministratore
    White Gates
    Faircox Lane
    BN5 9PD Henfield
    West Sussex
    BritishEngineer23336930004
    HANDFORD, Mark Adam
    - 9
    The Avenue
    BN21 3YA Eastbourne
    7
    East Sussex
    Amministratore
    - 9
    The Avenue
    BN21 3YA Eastbourne
    7
    East Sussex
    EnglandBritishEngineer154608220001
    HANDFORD, Mark Adam
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    Amministratore
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    EnglandBritishEngineer154608220001
    HANDFORD, Mark Adam
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    Amministratore
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    EnglandBritishElectronic Eng154608220001
    HANDFORD, Mark Adam
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    Amministratore
    Broadmead Road
    GU23 7AD Send
    Ashburton Lodge
    Surrey
    EnglandBritishEngineer154608220001
    LANHAM, Hugh Christopher
    October Lodge
    Fakenham Road
    NR21 7AW Great Ryburgh
    Norfolk
    Amministratore
    October Lodge
    Fakenham Road
    NR21 7AW Great Ryburgh
    Norfolk
    United KingdomBritishAccountant111108710001
    MASLIN, Roland Stephen
    Grek House 14 Primley Park Road
    LS17 7HS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Grek House 14 Primley Park Road
    LS17 7HS Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomNew ZealandAccountant11901760001
    MCLEOD, Alexander George Albert
    Longhouse
    Arkley Lane
    EN5 3JR Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    Longhouse
    Arkley Lane
    EN5 3JR Barnet
    Hertfordshire
    BritishDirector91173520001
    O'NEILL, Sean Patrick
    Long Acre Trading Estate
    Long Acre Aston
    B7 5JD Birmingham
    Unit 8
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Long Acre Trading Estate
    Long Acre Aston
    B7 5JD Birmingham
    Unit 8
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director104776410002
    OSBORNE, Raymond Thomas
    28 Raleigh Close
    ME5 7SB Chatham
    Kent
    Amministratore
    28 Raleigh Close
    ME5 7SB Chatham
    Kent
    United KingdomBritishEngineer81964490002
    PANNELL, Keith James
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    BritishElectrical Eng100942650001
    PANNELL, Keith James
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Freestones
    Blacksmith Lane
    GU4 8NQ Guildford
    Surrey
    BritishEngineer100942650001
    RODGER, Thomas John
    29 Wilkinson Place
    OX28 6JT Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    29 Wilkinson Place
    OX28 6JT Witney
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector20948660002
    SANDHU, Avtar Singh
    Long Acre
    Aston
    B7 5JD Birmingham
    Unit 8 Long Acre Trading Estate
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Long Acre
    Aston
    B7 5JD Birmingham
    Unit 8 Long Acre Trading Estate
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director159477460001

    CMS BUILDING SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 06 giu 2013
    Consegnato il 15 giu 2013
    In corso
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Technical & General Guarantee Company Sa
    Transazioni
    • 15 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of assignment
    Creato il 24 dic 2012
    Consegnato il 12 gen 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The receivables, together with all rights, benefits, interest, insurance monies or proceeds arising under or pursuant thereto see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Technical & General Guarantee Company Sa
    Transazioni
    • 12 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 22 set 2006
    Consegnato il 28 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 12 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 11 set 2006
    Consegnato il 13 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 3A the parade oldfields road sutton t/no SGL79625. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 apr 2006
    Consegnato il 19 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 19 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 dic 2005
    Consegnato il 04 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as combined mechanical services (electrical) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    3A the parade oldfield road sutton surrey t/no SGL79625. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 ago 2004
    Consegnato il 18 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 15 dic 1998
    Consegnato il 23 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Account no 70046671. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CMS BUILDING SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 feb 2013Data della riunione per approvare il CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Duncan Roderick Morris
    Elta House Birmingham Road
    CV37 0AQ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Praticante
    Elta House Birmingham Road
    CV37 0AQ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    2
    DataTipo
    07 mag 2017Data di scioglimento
    26 feb 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Colin Andrew Prescott
    Leonard Curtis Recovery 2nd Floor, 40 Queen Square
    BS1 4QP Bristol
    Praticante
    Leonard Curtis Recovery 2nd Floor, 40 Queen Square
    BS1 4QP Bristol
    Alan Clifton
    Po Box
    16114
    B93 3GS Solihull
    Praticante
    Po Box
    16114
    B93 3GS Solihull

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0