C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED

C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàC.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01303919
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O ATLANTIC PLASTICS LIMITED
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Mid Glamorgan
    Wales
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Atlantic Plastics Ltd Unit H200 Edison Road Hams Hall Coleshill West Midlands B46 1AB* in data 17 mar 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 24 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 ott 2013

    Stato del capitale al 15 ott 2013

    • Capitale: GBP 30,000
    SH01

    Nomina di Mr Mark Vernon Hodgens come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Saul Godfrey come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Marcus Billman come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Dr Ansgar Nonn come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Kris Holla come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Mr Marcus Billman come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Oliver Gosemann come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Kris Holla come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Oliver Frank Gosemann come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Cessazione della carica di Jan Van Ooijen come amministratore

    1 pagineTM01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    18 pagineAA

    Nomina di Mr James Fry come segretario

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FRY, James
    c/o C/O Atlantic Plastics Limited
    Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Coytrahene
    Mid Glamorgan
    Wales
    Segretario
    c/o C/O Atlantic Plastics Limited
    Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Coytrahene
    Mid Glamorgan
    Wales
    158470000001
    HODGENS, Mark Vernon
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Atlantic Plastics Limited
    Mid Glamorgan
    Wales
    Amministratore
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Atlantic Plastics Limited
    Mid Glamorgan
    Wales
    EnglandBritish94971440002
    NONN, Ansgar, Dr
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Amministratore
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyGerman177013380001
    HUNT, Nigel Thomas
    84 Fabis Close
    Walton Park
    DE11 9SN Swadlincote
    Derbyshire
    Segretario
    84 Fabis Close
    Walton Park
    DE11 9SN Swadlincote
    Derbyshire
    British39559640001
    MARTIN, Terry
    18 Ashford Crescent
    EN3 7HU Enfield
    Middlesex
    Segretario
    18 Ashford Crescent
    EN3 7HU Enfield
    Middlesex
    British69720220001
    MATTHEWS, Darren Jon
    60 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Shirley
    West Midlands
    Segretario
    60 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Shirley
    West Midlands
    British112391130001
    WALKER, Lesley
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    Segretario
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    British57030200002
    BILLMAN, Marcus
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Amministratore
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    United KingdomSwedish142246880001
    CATT, Nicholas William
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    Amministratore
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    EnglandBritish128624750001
    DAWES, Michael William
    The Nook
    Alton
    ST10 4BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    The Nook
    Alton
    ST10 4BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    British21194340001
    DURY, Paul John Edwin
    45 St Johns Treet
    DE6 1GP Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    45 St Johns Treet
    DE6 1GP Ashbourne
    Derbyshire
    British46194000001
    EDMONDS, David Henry
    One Carrington House
    Buxton Road
    DE6 1EX Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    One Carrington House
    Buxton Road
    DE6 1EX Ashbourne
    Derbyshire
    British73468520001
    GODFREY, Saul Gideon
    Charwood Close
    WD7 9LH Shenley
    12
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Charwood Close
    WD7 9LH Shenley
    12
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish103524290001
    GOSEMANN, Oliver Frank
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Amministratore
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyGerman167850440001
    HOLLA, Kris
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Amministratore
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyAmerican167994810001
    KING, Stuart Derek
    68 Wenallt Road
    Rhiwbina
    CF4 6SE Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    68 Wenallt Road
    Rhiwbina
    CF4 6SE Cardiff
    South Glamorgan
    British40173530001
    MACKEY, Damian
    18 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    Amministratore
    18 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    Australian125261330001
    MCKENDRY, Francis James
    26/28 Avenue Raymond Poincarre
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    Amministratore
    26/28 Avenue Raymond Poincarre
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    FranceBritish124595550001
    NICHOLAS, David Charles
    Lillingstone House
    84 Knowle Wood Road Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Lillingstone House
    84 Knowle Wood Road Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    British96403410001
    POLINE, Olivier Pierre
    30 Allee Du Chateau
    69780 Mioms
    France
    Amministratore
    30 Allee Du Chateau
    69780 Mioms
    France
    French112391190001
    TURNER, Stanley
    The Maples
    The Park
    B79 9DF Elford
    Staffordshire
    Amministratore
    The Maples
    The Park
    B79 9DF Elford
    Staffordshire
    EnglandBritish70686150004
    VAN OOIJEN, Jan Roelf
    Heeckerenlaan 5
    7531 HW Enschede
    7531 Hw
    Netherlands
    Amministratore
    Heeckerenlaan 5
    7531 HW Enschede
    7531 Hw
    Netherlands
    Dutch125281750001
    WALKER, Lesley
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    Amministratore
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    EnglandBritish57030200002
    WARD, Marcus Gordon Waddie
    Rue De Tenbosch 85
    Flat 113
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    Amministratore
    Rue De Tenbosch 85
    Flat 113
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    British74246040001
    WHELDON, Stephen
    11 Ashfield Park
    NE16 4SQ Whickham
    Tyne & Wear
    Amministratore
    11 Ashfield Park
    NE16 4SQ Whickham
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish93126410001
    WILLIAMS, Andrew
    79 The Crescent
    WS1 2DA Walsall
    Amministratore
    79 The Crescent
    WS1 2DA Walsall
    British39210390001

    C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 06 gen 2000
    Consegnato il 11 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 20 ago 1999
    Consegnato il 27 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and garage premises and part garage premises on the west side of woodland road swadlincote derbyshire t/no's;-DY3354 DY3355. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 mar 1994
    Consegnato il 20 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 20 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 ott 1991
    Consegnato il 22 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & premises woodland road swadlincote t/no DY3354 & DY3355.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 13 mar 1987
    Consegnato il 20 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book & other debts now & from time to time due or owing to the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 1982
    Consegnato il 08 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold land & premises k/a 115 and 117 hearthcote road, swadlincote, derbyshire. Title no: dy 82283.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 16 dic 1977
    Consegnato il 29 dic 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0