FOUR PILLARS HOTELS LIMITED

FOUR PILLARS HOTELS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOUR PILLARS HOTELS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01303927
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOUR PILLARS HOTELS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FOUR PILLARS HOTELS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FOUR PILLARS HOTELS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FOUR PILLARS RESTAURANTS LIMITED(THE)21 mar 197721 mar 1977

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOUR PILLARS HOTELS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per FOUR PILLARS HOTELS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 26 nov 2021

    • Capitale: GBP 0.20
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    2 pagineSH20

    Cessazione della carica di John Cody Bradshaw come amministratore in data 12 nov 2021

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 013039270010 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 013039270009 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    22 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    23 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    21 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 013039270010, creata il 17 dic 2020

    24 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    22 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di FOUR PILLARS HOTELS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    Principal Hayley, The Inspire
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    Principal Hayley, The Inspire
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish192486560001
    TROY, Anthony Gerard
    The Inspire
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    Principal Hayley
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    The Inspire
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    Principal Hayley
    North Yorkshire
    England
    United KingdomIrish104500230001
    CLAYTON, Rex
    Ducklington Lane
    OX28 4EX Witney
    Olney House
    Oxon
    Segretario
    Ducklington Lane
    OX28 4EX Witney
    Olney House
    Oxon
    British6477910005
    MURTAGH, Brian Paul
    The Croft House
    Church View
    OX18 2NE Bampton
    Oxfordshire
    Segretario
    The Croft House
    Church View
    OX18 2NE Bampton
    Oxfordshire
    British12017980006
    BRADSHAW, John Cody
    2, Harewood Place
    W1S 1BX London
    Starwood Capital Europe Advisers Llp
    England
    Amministratore
    2, Harewood Place
    W1S 1BX London
    Starwood Capital Europe Advisers Llp
    England
    EnglandAmerican175925260001
    BROUGHTON, Sarah
    2, Harewood Place
    W1S 1BX London
    Starwood Capital Europe Advisers Llp
    England
    Amministratore
    2, Harewood Place
    W1S 1BX London
    Starwood Capital Europe Advisers Llp
    England
    United KingdomBritish170320620001
    CLAYTON, Rex
    5 North Parade
    BA11 1AT Frome
    Somerset
    Amministratore
    5 North Parade
    BA11 1AT Frome
    Somerset
    British6477910005
    CRAWLEY, Nicholas David Townsend
    Ogbourne Maizey Manor
    Ogbourne Maizey
    SN8 1RY Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Ogbourne Maizey Manor
    Ogbourne Maizey
    SN8 1RY Marlborough
    Wiltshire
    EnglandEnglish96980780001
    DE BONA BOTTEGAL, Nicoletta
    Flat 1
    85 Greencroft Gardens
    NW6 3LJ London
    Amministratore
    Flat 1
    85 Greencroft Gardens
    NW6 3LJ London
    Italian125063670001
    EDE, Jonathan
    Mayfield House 3 Little Lane
    Cassington Road
    OX29 4LG Eynsham
    Oxfordshire
    Amministratore
    Mayfield House 3 Little Lane
    Cassington Road
    OX29 4LG Eynsham
    Oxfordshire
    United KingdomBritish88765330001
    GAREH, Benjamin Meir
    13 The Vale
    NW11 8SE London
    Amministratore
    13 The Vale
    NW11 8SE London
    United KingdomBritish124565940001
    HOLMES, Charles Richard
    Ducklington Lane
    OX28 4EX Witney
    Olney House
    Oxon
    Amministratore
    Ducklington Lane
    OX28 4EX Witney
    Olney House
    Oxon
    EnglandBritish81939380002
    KEELING, Ian
    The Lynch
    Westfield Road Cholsey
    OX10 9LS Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Lynch
    Westfield Road Cholsey
    OX10 9LS Wallingford
    Oxfordshire
    British20824710002
    LYKO-EDWARDS, Darren
    Ducklington Lane
    OX28 4EX Witney
    Olney House
    Oxon
    Amministratore
    Ducklington Lane
    OX28 4EX Witney
    Olney House
    Oxon
    United KingdomBritish134551380001
    MORRIS, Peter Ewan
    St Davids
    Box Lane Box
    GL6 9HA Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    St Davids
    Box Lane Box
    GL6 9HA Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritish1480430004
    MURTAGH, Brian Paul
    The Croft House
    Church View
    OX18 2NE Bampton
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Croft House
    Church View
    OX18 2NE Bampton
    Oxfordshire
    EnglandBritish12017980006
    MURTAGH, Kathleen Marion, Dr
    Marsh House
    Higham Marsh
    CO6 4SX Stoke By Nayland
    Essex
    Amministratore
    Marsh House
    Higham Marsh
    CO6 4SX Stoke By Nayland
    Essex
    British73366720001
    OLDMAN, John Russell
    The Lynch
    Cholsey
    OX10 9LS Oxford
    Oxon
    Amministratore
    The Lynch
    Cholsey
    OX10 9LS Oxford
    Oxon
    British3436710001
    OXLEY, Anthony Mark
    24 Swan Close
    MK18 7EP Buckingham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    24 Swan Close
    MK18 7EP Buckingham
    Buckinghamshire
    British23059930004
    RICHARDSON, David Hedley
    Ducklington Lane
    OX28 4EX Witney
    Olney House
    Oxon
    Amministratore
    Ducklington Lane
    OX28 4EX Witney
    Olney House
    Oxon
    United KingdomBritish31956080004
    TAYLOR, Rodney Frederick
    c/o Taylor Global Advisors Ltd
    Crawford Street
    Suite 356
    W1H 1PJ London
    19-21
    Amministratore
    c/o Taylor Global Advisors Ltd
    Crawford Street
    Suite 356
    W1H 1PJ London
    19-21
    United KingdomBritish148710830001
    TOLLEY, Thomas Mark
    2, Harewood Place
    W1S 1BX London
    Starwood Capital Europe Advisers Llp
    England
    Amministratore
    2, Harewood Place
    W1S 1BX London
    Starwood Capital Europe Advisers Llp
    England
    United KingdomBritish183506490001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FOUR PILLARS HOTELS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Spire Bidco Hotels Limited
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    06 apr 2016
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione07146956
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FOUR PILLARS HOTELS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 17 dic 2020
    Consegnato il 17 dic 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch
    Transazioni
    • 17 dic 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 nov 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 ott 2018
    Consegnato il 11 ott 2018
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch
    Transazioni
    • 11 ott 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 nov 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 dic 2016
    Consegnato il 20 dic 2016
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch
    Transazioni
    • 20 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 25 mar 2014
    Consegnato il 01 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ge Real Estate Loans Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 01 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 26 feb 2010
    Consegnato il 08 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Security Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 set 2007
    Consegnato il 27 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Agent for Itself and the Other Finance Parties Under the Finance Documents)(the Security Agent)
    Transazioni
    • 27 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 ago 2006
    Consegnato il 31 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 gen 2005
    Consegnato il 28 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and oxford spires four pillars hotel limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 1 church mill close standlake witney west oxfordshire oxfordshire t/n ON227407. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 2001
    Consegnato il 06 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a 1 church mill close standlake witney oxfordshire t/n ON19325.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 mar 2000
    Consegnato il 05 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0